Buscador CIF Logo

Actos BORME Kpmg Ces Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Kpmg Ces Sl

Actos BORME Kpmg Ces Sl - B87363768

Tenemos registrados 53 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Kpmg Ces Sl con CIF B87363768

🔙 Perfil de Kpmg Ces Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Kpmg Ces Sl

23 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUINEA LOPEZ FRANCISCO DE BORJA. Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ SAYANSDAVID. Datos registrales. T 35461 , F 210, S 8, H M 610025, I/A 52 (16.11.23).

22 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apoderado: GUEDES COELHO TERESA CRISTINA. Apo.Sol.: GUEDES COELHO TERESA CRISTINA. Datosregistrales. T 35461 , F 210, S 8, H M 610025, I/A 51 (14.08.23).

19 de Julio de 2023
Nombramientos. Apoderado: VIDAURRETA HERRERA JAVIER. Datos registrales. T 35461 , F 209, S 8, H M 610025, I/A 50(12.07.23).

09 de Mayo de 2023
Reelecciones. Consejero: CANO FERRER JUAN JOSE. Presidente: CANO FERRER JUAN JOSE. Datos registrales. T 35461 , F209, S 8, H M 610025, I/A 49 (28.04.23).

23 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: HERVAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ DE LA CALLE ALVARO MARIA. Datosregistrales. T 35461 , F 209, S 8, H M 610025, I/A 48 (16.12.22).

22 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA GRANDA CELSO. Datos registrales. T 35461 , F 208, S 8, H M 610025, I/A 47 (15.12.22).

05 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: HERRANZ PASCUAL MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 35461 , F 208, S 8, H M 610025, I/A46 (28.11.22).

27 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 35461 , F 208, S 8, H M 610025, I/A 45 (20.09.22).

25 de Enero de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Apoderado: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Otrosconceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A DON HILARIO ALBARRACIN SANTA CRUZ EN LA INSCRIPCION 20. Datosregistrales. T 35461 , F 208, S 8, H M 610025, I/A 44 (18.01.22).

12 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Secretario: CANO FERRER JUAN JOSE. Presidente:ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Nombramientos. Consejero: LACARRA CAMINERO MARIA. Presidente: CANO FERRERJUAN JOSE. Secretario: LACARRA CAMINERO MARIA. Datos registrales. T 35461 , F 207, S 8, H M 610025, I/A 43 ( 4.11.21).

07 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANO FERRER JUAN JOSE. Apo.Manc.: LACARRA CAMINERO MARIA;MARTELES GUTIERREZDEL ALAMO MARIA LORETO. Datos registrales. T 35461 , F 202, S 8, H M 610025, I/A 37 (30.09.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LACARRA CAMINERO MARIA. Apo.Manc.: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIALORETO;CANO FERRER JUAN JOSE. Datos registrales. T 35461 , F 204, S 8, H M 610025, I/A 38 (30.09.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO. Apo.Manc.: LACARRA CAMINEROMARIA;CANO FERRER JUAN JOSE. Datos registrales. T 35461 , F 205, S 8, H M 610025, I/A 39 (30.09.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: GUEDES COELHO TERESA CRISTINA. Datos registrales. T 35461 , F 206, S 8, H M 610025, I/A 40(30.09.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: BELTRAN ORTEGA ANTONIO. Datos registrales. T 35461 , F 207, S 8, H M 610025, I/A 41 (30.09.21).

Revocaciones. Apoderado: VALDES VERELST MARIA REYES. Nombramientos. Apoderado: MONTALVO DE MARCOS DIEGO.Datos registrales. T 35461 , F 207, S 8, H M 610025, I/A 42 (30.09.21).

01 de Junio de 2020
Reelecciones. Consejero: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO;GUINEA LOPEZ FRANCISCO DE BORJA. Presidente:ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Datos registrales. T 35461 , F 202, S 8, H M 610025, I/A 36 (25.05.20).

23 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GARCIA ALBA REBECA. Datos registrales. T 35461 , F 201, S 8, H M 610025, I/A 34(16.12.19).

Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ GONZALEZ ESTHER. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ ESTHER.Datos registrales. T 35461 , F 202, S 8, H M 610025, I/A 35 (16.12.19).

06 de Agosto de 2019
Fe de erratas: Se publicó por error en la inscripción 31ª el nombramiento de GUEDES COELHO TERESA CRISTINA comoapoderada mancomunada, siendo lo correcto apoderada. Datos registrales. T 35461 , F 200, S 8, H M 610025, I/A 31 ( 6.03.19).

24 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: TECLESMAYER FERRERO SEGOR. Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GONZALEZ ESTHER.Datos registrales. T 35461 , F 201, S 8, H M 610025, I/A 33 (17.06.19).

13 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FAUS PEREZ IGNACIO. Nombramientos. Apo.Manc.: GUEDES COELHO TERESA CRISTINA.Datos registrales. T 35461 , F 200, S 8, H M 610025, I/A 31 ( 6.03.19).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MARTIN CAROLINA. Datos registrales. T 35461 , F 201, S 8, H M 610025, I/A 32 (6.03.19).

08 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERRER PASTOR CESAR. Apo.Sol.: PALOMO SANCHEZ GEMA. Datos registrales. T 35461 , F200, S 8, H M 610025, I/A 30 ( 1.03.19).

07 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: FAUS PEREZ IGNACIO. Secretario: FAUS PEREZ IGNACIO. Nombramientos. Consejero: CANOFERRER JUAN JOSE. Secretario: CANO FERRER JUAN JOSE. Datos registrales. T 35461 , F 199, S 8, H M 610025, I/A 29(28.02.19).

05 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANO FERRER JUAN JOSE. Apo.Manc.: FERNANDEZ-VILLARAN ARA MARIAEUGENIA;MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO;GARCIA GRANDA CELSO;BRETT ANDREW;ALBARRACINSANTA CRUZ HILARIO. Datos registrales. T 35461 , F 198, S 8, H M 610025, I/A 28 (29.01.19).

12 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: NASARRE DE LETOSA LAGUARTA DANIEL;MINKOVA PENEVA VERA;PALOMO SANCHEZ GEMA.Datos registrales. T 35461 , F 198, S 8, H M 610025, I/A 27 (30.11.17).

19 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: BELTRAN ORTEGA ANTONIO. Datos registrales. T 35461 , F 198, S 8, H M 610025, I/A 26(10.10.17).

29 de Agosto de 2017
Otros conceptos: Se modifican los poderes otorgados a D. María Loreto Marteles Gutiérrez en la escritura que motivó la inscripción18ª de esta Hoja, en cuanto a las facultades números 12, 14 y 15. Datos registrales. T 35461 , F 197, S 8, H M 610025, I/A 24(22.08.17).

Nombramientos. Apoderado: LAMOLA VILLANUEVA JOSE SAMUEL. Datos registrales. T 35461 , F 197, S 8, H M 610025, I/A 25(22.08.17).

15 de Junio de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PALLARES QUEROL RAMON. Apo.Manc.: AGUILO GARCIA MARIA JOSE;ALBARRACIN SANTACRUZ HILARIO. Apo.Man.Soli: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Apo.Manc.: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIALORETO;FERRER PASTOR CESAR;PALLARES QUEROL RAMON;AGUILO GARCIA MARIA JOSE. Otros conceptos: Revocadoslos poderes otorgados a Doña María Loreto Marteles Gutiérrez del Alamo y a Don César Ferrer Pastor mediante escritura que causó lainscripción 3ª, excepto la facultad número 13 que permanece vigente. Datos registrales. T 35461 , F 197, S 8, H M 610025, I/A 23 (7.06.17).

30 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: SCOTT JOHN MACLEAN. Apoderado: SCOTT JOHN MACLEAN. Datos registrales. T 35461 , F 196, S8, H M 610025, I/A 21 (23.03.17).

Nombramientos. Apoderado: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Datos registrales. T 35461 , F 196, S 8, H M 610025, I/A 22(23.03.17).

03 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GRANDA CELSO. Datos registrales. T 33900 , F 146, S 8, H M 610025, I/A 15 (24.02.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: ZARATE MUÑOZ-REPISO MARTA. Datos registrales. T 33900 , F 147, S 8, H M 610025, I/A 16(24.02.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: BRETT ANDREW. Datos registrales. T 33900 , F 147, S 8, H M 610025, I/A 17 (24.02.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO. Datos registrales. T 33900 , F 148, S 8, HM 610025, I/A 18 (24.02.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FAUS PEREZ IGNACIO. Datos registrales. T 33900 , F 149, S 8, H M 610025, I/A 19 (24.02.17).

Otros conceptos: Se modifican los poderes otorgados a D. Hilarlo Albarracín Santa Cruz en la escritura que causó la inscripción 11ªde esta Hoja, en cuanto a la facultad número 14. Datos registrales. T 35461 , F 196, S 8, H M 610025, I/A 20 (24.02.17).

22 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: HEMZAOUI RODRIGO SAMI. Datos registrales. T 33900 , F 146, S 8, H M 610025, I/A 14 (13.02.17).

20 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: SCOTT JOHN MACLEAN. Presidente: SCOTT JOHN MACLEAN. Secretario: ALBARRACIN SANTACRUZ HILARIO. Nombramientos. Consejero: FAUS PEREZ IGNACIO. Secretario: FAUS PEREZ IGNACIO. Presidente:ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Datos registrales. T 33900 , F 145, S 8, H M 610025, I/A 13 (10.02.17).

29 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: VALDES VERELST MARIA REYES. Datos registrales. T 33900 , F 144, S 8, H M 610025, I/A 12(21.12.16).

17 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Apo.Manc.: FERNANDEZ-VILLARAN ARA MARIAEUGENIA;MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO;FERRER PASTOR CESAR;PALLARES QUEROL RAMON. Datosregistrales. T 33900 , F 143, S 8, H M 610025, I/A 11 ( 9.05.16).

13 de Mayo de 2016
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 259 C (MADRID). Datos registrales. T 33900 , F 143, S 8, H M 610025,I/A 10 ( 6.05.16).

24 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ REBOLLO SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: GUINEA LOPEZ FRANCISCO DEBORJA. Datos registrales. T 33900 , F 142, S 8, H M 610025, I/A 8 (16.02.16).

Revocaciones. Apoderado: GOMEZ REBOLLO SANTIAGO. Datos registrales. T 33900 , F 143, S 8, H M 610025, I/A 9 (16.02.16).

13 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: ZARATE MUÑOZ-REPISO MARTA. Datos registrales. T 33900 , F 141, S 8, H M 610025, I/A 6 (2.10.15).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ REBOLLO SANTIAGO. Datos registrales. T 33900 , F 142, S 8, H M 610025, I/A 7 ( 2.10.15).

08 de Octubre de 2015
Constitución. Comienzo de operaciones: 8.09.15. Objeto social: colaborar en la prestación de servicios profesionales relacionadoscon la actividad de auditoría; el asesoramiento fiscal, legal, de consultoría, y de negocio; y ello, mediante la realización de actividadesque no requieran deuna alta complejidad ni deunatitulación específica, tales como, .. Domicilio: PASEO DE LA CASTELLANA 95(MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: KPMG SA. Nombramientos. Consejero:SCOTT JOHN MACLEAN;ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO;GOMEZ REBOLLO SANTIAGO. Presidente: SCOTT JOHNMACLEAN. Secretario: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Datos registrales. T 33900 , F 135, S 8, H M 610025, I/A 1(30.09.15).

Nombramientos. Apoderado: TECLESMAYER FERRERO SEGOR. Datos registrales. T 33900 , F 138, S 8, H M 610025, I/A 2 (1.10.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO;FERRER PASTOR CESAR;PALLARES

Nombramientos. Apoderado: SCOTT JOHN MACLEAN. Datos registrales. T 33900 , F 139, S 8, H M 610025, I/A 4 ( 1.10.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Apo.Manc.: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIALORETO;FERRER PASTOR CESAR;PALLARES QUEROL RAMON;AGUILO GARCOA MAROA JOSE. Datos registrales. T 33900 ,F 140, S 8, H M 610025, I/A 5 ( 1.10.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información