Buscador CIF Logo

Actos BORME Kpmg Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Kpmg Sa

Actos BORME Kpmg Sa - A78446333

Tenemos registrados 118 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Kpmg Sa con CIF A78446333

馃敊 Perfil de Kpmg Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Kpmg Sa

05 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: GARCIA FERRER FERNANDO;GUINEA LOPEZ BORJA;PARRA MARTINEZ MANUEL;CUEVASGONZALEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 35408 , F 147, S 8, H M 75646, I/A 222 (28.11.23).

15 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUECKER EMBDEN BERNARDO UWE;PASTOR CABALLERO NATALIA. Nombramientos.Consejero: MARTIN RIA脩O LUIS ALBERTO;PEREZ PUERTA MARIA LUISA. Datos registrales. T 35408 , F 146, S 8, H M 75646,I/A 221 ( 7.11.23).

21 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: GUEDES COELHO TERESA CRISTINA;GUEDES COELHO TERESA CRISTINA;SOUTO DELIBES ANAMARIA. Datos registrales. T 35408 , F 146, S 8, H M 75646, I/A 220 (11.08.23).

19 de Julio de 2023
Nombramientos. Apoderado: VIDAURRETA HERRERA JAVIER. Datos registrales. T 35408 , F 145, S 8, H M 75646, I/A 219(12.07.23).

12 de Junio de 2023
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 35408 , F 145, S 8, H M 75646, I/A 218 ( 4.06.23).

09 de Mayo de 2023
Otros conceptos: Ratificado por la Junta General Ordinaria de accionistas del 30 de marzo de 2023, por plazo de 5 a帽os, elnombramiento por cooptaci贸n de Don Alberto Estrelles Domingo como consejero, que fue acordado por el consejo de administraci贸nen reuni贸n celebrada el d铆a 29 de septiembre de 2022. Datos registrales. T 35408 , F 144, S 8, H M 75646, I/A 216 (28.04.23).

Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 11潞 de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General,mediante una nueva e 铆ntegra redacci贸n de este. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.kpmg.es.Datos registrales. T 35408 , F 145, S 8, H M 75646, I/A 217 (28.04.23).

24 de Febrero de 2023
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 54.871,30 Euros. Desembolsado: 54.871,30 Euros. Resultante Suscrito: 751.736,81 Euros.Resultante Desembolsado: 751.736,81 Euros. Datos registrales. T 35408 , F 144, S 8, H M 75646, I/A 215 (17.02.23).

03 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: SOUTO DELIBES ANA MARIA. Datos registrales. T 35408 , F 143, S 8, H M 75646, I/A 213 (27.01.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: HERVAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ DE LA CALLE ALVARO MARIA. Datosregistrales. T 35408 , F 143, S 8, H M 75646, I/A 214 (27.01.23).

12 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA GRANDA CELSO. Secretario: GARCIA GRANDA CELSO. Nombramientos. Consejero:ESTRELLES DOMINGO ALBERTO. Secretario: ESTRELLES DOMINGO ALBERTO. Datos registrales. T 35408 , F 142, S 8, H M75646, I/A 212 ( 1.12.22).

09 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: HERRANZ PASCUAL MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 35408 , F 142, S 8, H M 75646, I/A211 (30.11.22).

05 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: ASLA GARCIA ENRIQUE;RIOPEREZ ORTA JORGE;MARTINEZ RAMON ANA;GARCIA GRANDACELSO;MENDOZA DIAZ AGUADO VICTOR;SANCHEZ LOPEZ OLGA. Apo.Sol.: GARCIA GRANDA CELSO. Datos registrales. T35408 , F 142, S 8, H M 75646, I/A 210 (28.11.22).

24 de Junio de 2022
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 35408 , F 141, S 8, H M 75646, I/A 209 (17.06.22).

03 de Mayo de 2022
Reelecciones. Secretario: GARCIA GRANDA CELSO. Consejero: GARCIA GRANDA CELSO;CANO FERRER JUAN JOSE.Presidente: CANO FERRER JUAN JOSE. Otros conceptos: Ratificado por la Junta General de accionistas celebrada el d铆a 23 demarzo de 2022 y por plazo de 5 a帽os, el nombramiento por cooptaci贸n de don Angel Crespo Rodrigo como consejero de la Sociedadque fue acordado por el Consejo de Administraci贸n en reuni贸n celebrada el d铆a 30 de septiembre de 2021. Ratificado por la JuntaGeneral de accionistas celebrada el d铆a 23 de marzo de 2022 y por plazo de 5 a帽os, el nombramiento por cooptaci贸n de don FranciscoUr铆a Fern谩ndez como consejero de la Sociedad que fue acordado por el Consejo de Administraci贸n el d铆a 30 de septiembre de 2021Ratificado por la Junta General de accionistas celebrada el d铆a 23 de marzo de 2022 y por plazo de 5 a帽os, el nombramiento porcooptaci贸n de don Pablo Bernad Ramoneda como consejero de la Sociedad que fue acordado por el Consejo de Administraci贸n enreuni贸n celebrada el d铆a 30 de septiembre de 2021.Ratificada por la Junta General de accionistas celebrada el d铆a 23 de marzo de2022 y por plazo de 5 a帽os, el nombramiento por cooptaci贸n de do帽a Mar铆a Lacarra Caminero como consejera de la Sociedad que fueacordado por el Consejo de Administraci贸n el d铆a 30 de septiembre de 2021. Datos registrales. T 35408 , F 140, S 8, H M 75646, I/A208 (25.04.22).

01 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Apo.Man.Soli: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Apo.Sol.:ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Apoderado: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Otros conceptos: Revocar lamodificaci贸n del poder conferido a don Hilario Albarrac铆n Santa Cruz, mediante escritura p煤blica otorgada el 29 de diciembre de 2016ante el Notario de Madrid don Antonio Luis Reina Guti茅rrez, con el n煤mero 10.898 de protocolo, que caus贸 la inscripci贸n n煤mero 161.Datos registrales. T 35408 , F 140, S 8, H M 75646, I/A 207 (22.02.22).

28 de Febrero de 2022
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 32.922,78 Euros. Desembolsado: 32.922,78 Euros. Resultante Suscrito: 696.865,51 Euros.Resultante Desembolsado: 696.865,51 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 35408 , F 139, S 8, H M 75646, I/A 206 (21.02.22).

05 de Enero de 2022
Revocaciones. Apoderado: ROSES NOGUER ALBERT;MARTIN TORRES ANGEL;LECHUGA CAMPILLO ANTONIO;VARGASGOMEZ BERNARDO;SERRANO BUFALA ELOY. Datos registrales. T 35408 , F 139, S 8, H M 75646, I/A 205 (29.12.21).

12 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJIGAS RIERA NATIVIDAD NOELLE;ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Presidente:ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Consejero: FERNANEZ VILLARAN ARA MARIA EUGENIA;ARIAS MENCHEN MIGUEL.Nombramientos. Consejero: LACARRA CAMINERO MARIA;CRESPO RODRIGO ANGEL;BERNAD RAMONEDA PABLO;URIAFERNANDEZ FRANCISCO. Presidente: CANO FERRER JUAN JOSE. Datos registrales. T 35408 , F 138, S 8, H M 75646, I/A 204 (3.11.21).

08 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: ZARATE MU脩OZ-REPISO MARTA. Datos registrales. T 35408 , F 137, S 8, H M 75646, I/A 203 (1.10.21).

05 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANO FERRER JUAN JOSE. Apo.Manc.: LACARRA CAMINERO MARIA;MARTELES GUTIERREZDEL ALAMO MARIA LORETO. Datos registrales. T 35408 , F 133, S 8, H M 75646, I/A 197 (28.09.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LACARRA CAMINERO MARIA. Apo.Manc.: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIALORETO;CANO FERRER JUAN JOSE. Datos registrales. T 35408 , F 134, S 8, H M 75646, I/A 198 (28.09.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO. Apo.Manc.: LACARRA CAMINEROMARIA;CANO FERRER JUAN JOSE. Datos registrales. T 35408 , F 135, S 8, H M 75646, I/A 199 (28.09.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: GUEDES COELHO TERESA CRISTINA. Datos registrales. T 35408 , F 136, S 8, H M 75646, I/A 200(28.09.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: BELTRAN ORTEGA ANTONIO. Datos registrales. T 35408 , F 137, S 8, H M 75646, I/A 201 (28.09.21).

Revocaciones. Apoderado: VALDES VERELST MARIA REYES. Nombramientos. Apo.Sol.: MONTALVO DE MARCOS DIEGO.Datos registrales. T 35408 , F 137, S 8, H M 75646, I/A 202 (28.09.21).

19 de Mayo de 2021
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 35408 , F 132, S 8, H M 75646, I/A 196 (12.05.21).

17 de Mayo de 2021
Reelecciones. Consejero: CU脩ADO GARCIA BERNALT FERNANDO;ARIAS MENCHEN MIGUEL. Otros conceptos: Ratificado porla junta de fecha 24/03/21 el nombramiento por cooptaci贸n de la consejera Do帽a Natalia Pastor Caballero DNI 16799012L, por sesi贸ndel Consejo de fecha 29/05/20. Datos registrales. T 35408 , F 132, S 8, H M 75646, I/A 195 (10.05.21).

17 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apoderado: TRAPE VILADOMAT MARIA MONTSERRAT;DEL POZO-ALMAZAN LOPEZ MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 35408 , F 131, S 8, H M 75646, I/A 194 (10.02.21).

19 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 35408 , F 131, S 8, H M 75646, I/A 193 (12.11.20).

23 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: SIERRA MU脩OZ NICOLAS JESUS. Datos registrales. T 35408 , F 130, S 8, H M 75646, I/A 191(16.07.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: TRAPE VILADOMAT MARIA MONTSERRAT. Nombramientos. Consejero: PASTOR CABALLERONATALIA. Datos registrales. T 35408 , F 131, S 8, H M 75646, I/A 192 (16.07.20).

04 de Junio de 2020
Reelecciones. Consejero: FERNANEZ VILLARAN ARA MARIA EUGENIA;HOHN DAVID. Datos registrales. T 35408 , F 129, S 8, HM 75646, I/A 189 (27.05.20).

Otros conceptos: Delegaci贸n de facultades en el consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 35408 , F 130, S 8, H M 75646,I/A 190 (28.05.20).

26 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: CAMPOS MARTINEZ ROCIO. Datos registrales. T 35408 , F 129, S 8, H M 75646, I/A 188 (19.02.20).

10 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: SERRATE URREA FERNANDO;GARCIA GRANDA CELSO;FERNANDEZ GONZALEZ ESTHER.Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GONZALEZ ESTHER. Datos registrales. T 35408 , F 128, S 8, H M 75646, I/A 186 (3.02.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GRANDA CELSO. Datos registrales. T 35408 , F 129, S 8, H M 75646, I/A 187 ( 3.02.20).

27 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: URIA FERNANDEZ FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: RUECKER EMBDEN BERNARDOUWE. Datos registrales. T 35408 , F 128, S 8, H M 75646, I/A 185 (20.01.20).

09 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 35408 , F 128, S 8, H M 75646, I/A 184 ( 2.08.19).

09 de Julio de 2019
Revocaciones. Apoderado: TECLESMAYER FERRERO SEGOR;TECLESMAYER FERRERO SEGOR. Nombramientos.Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ ESTHER. Datos registrales. T 35408 , F 127, S 8, H M 75646, I/A 183 ( 2.07.19).

25 de Abril de 2019
Reelecciones. Consejero: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Presidente: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Otrosconceptos: Reelegidos como consejeros por plazo de cinco a帽os don FRANCISCO GIBERT PIBERNAT y do帽a NATIVIDAD NOELLECAJIGAS RIERA, nombrados por cooptaci贸n por el consejo de administraci贸n el 28 de septiembre 2018 y el 19 de diciembre de 2018,respectivamente. Datos registrales. T 35408 , F 127, S 8, H M 75646, I/A 182 (16.04.19).

08 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANO FERRER JUAN JOSE. Datos registrales. T 35408 , F 126, S 8, H M 75646, I/A 181 (1.03.19).

07 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apoderado: FERRER PASTOR CESAR. Apo.Man.Soli: FAUS PEREZ IGNACIO. Apo.Sol.: PALOMO SANCHEZGEMA. Nombramientos. Apo.Sol.: GUEDES COELHO TERESA CRISTINA. Datos registrales. T 35408 , F 125, S 8, H M 75646,I/A 179 (28.02.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ MARTIN CAROLINA. Datos registrales. T 35408 , F 125, S 8, H M 75646, I/A 180(28.02.19).

19 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: FAUS PEREZ IGNACIO. Nombramientos. Consejero: CAJIGAS RIERA NATIVIDAD NOELLE.

11 de Enero de 2019
Revocaciones. Apoderado: DE HITA PLANELLA JOSE MARIA;RIVERO CRESPO JUAN. Datos registrales. T 35408 , F 124, S 8, HM 75646, I/A 176 ( 3.01.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SERRATE URREA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: GIBERT PIBERNAT FRANCISCO.Datos registrales. T 35408 , F 124, S 8, H M 75646, I/A 177 ( 3.01.19).

20 de Julio de 2018
Revocaciones. Apoderado: ROGER RULL FRANCISCO. Datos registrales. T 35408 , F 123, S 8, H M 75646, I/A 175 (13.07.18).

01 de Junio de 2018
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 148陋 EL NUEVO DOMICILIO SOCIAL, SIENDO EL CORRECTO:PASEO DE LA CASTELLANA 259 C DE MADRID. Datos registrales. T 26351 , F 41, S 8, H M 75646, I/A 148 (17.05.16).

09 de Mayo de 2018
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 35408 , F 123, S 8, H M 75646, I/A 174 (27.04.18).

07 de Mayo de 2018
Nombramientos. Consejero: TRAPE VILADOMAT MARIA MONTSERRAT. Datos registrales. T 35408 , F 123, S 8, H M 75646, I/A173 (26.04.18).

22 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: MORENO FAUSTE GREGORIO. Nombramientos. Apo.Sol.: NASARRE DE LETOSA LAGUARTADANIEL;MINKOVA PENEVA VERA;PALOMO SANCHEZ GEMA. Datos registrales. T 35408 , F 122, S 8, H M 75646, I/A 172(14.02.18).

22 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ LOPEZ OLGA. Nombramientos. Consejero: TRAPE VILADOMAT MARIAMONTSERRAT. Datos registrales. T 35408 , F 122, S 8, H M 75646, I/A 171 (13.12.17).

23 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: BELTRAN ORTEGA ANTONIO. Datos registrales. T 35408 , F 122, S 8, H M 75646, I/A 170(15.11.17).

10 de Octubre de 2017
Otros conceptos: Modificar los poderes otorgados a Do帽a Loreto Marteles Guti茅rrez, en escritura que caus贸 la inscripci贸n 159陋, encuanto a los apartados 12, 14 y 15 del citado poder. Datos registrales. T 35408 , F 121, S 8, H M 75646, I/A 169 ( 2.10.17).

14 de Julio de 2017
Revocaciones. Apoderado: ALONSO MARTINEZ MARIA GLORIA;CAMINA CARRASCO ANGEL;DEL CASTILLO CRESPO JOSEANTONIO;VILLARUBIA LOR GABRIEL;AGUINAGA CHURRUCA DIEGO. Apo.Man.Soli: AGUILO GARCIA MARIA JOSE;PALLARESQUEROL RAMON;ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO;MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO;FERRER PASTORCESAR;PALLARES QUEROL RAMONApo.Manc.: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Apoderado: ALBARRACIN SANTA CRUZHILARIO;AGUILO GARCIA MARIA JOSE;MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO;FERRER PASTORCESAR;PALLARES QUEROL RAMON. Apo.Sol.: PALLARES QUEROL RAMON. Datos registrales. T 35408 , F 121, S 8, H M75646, I/A 168 ( 6.07.17).

13 de Julio de 2017
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 99陋 EL PODER OTORGADO A AGUILLO GARCIA MARIA JOSE,SIENDO LO CORRECTO AGUILO GARCIA MARIA JOSE. Datos registrales. T 22251 , F 129, S 8, H M 75646, I/A 99 (31.12.08).

17 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Datos registrales. T 35408 , F 120, S 8, H M 75646, I/A 167 (8.05.17).

Revocaciones. Apoderado: AGUILO GARCIA MARIA JOSE;SCOTT JOHN MACLEAN;MACLEAN SCOTT JOHN;SOLIS CALBACHOAMPARO. Apo.Manc.: AGUILO GARCIA MARIA JOSE;SCOTT JOHN MACLEAN. Datos registrales. T 35408 , F 120, S 8, H M75646, I/A 166 ( 8.05.17).

25 de Abril de 2017
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 35408 , F 120, S 8, H M 75646, I/A 165 (17.04.17).

11 de Abril de 2017
Otros conceptos: Ratificados los consejeros Don Ignacio Faus Perez, Don Celso Garcia Granda, don Juan Jose Cano Ferrernombrados por cooptacion. Datos registrales. T 35408 , F 118, S 8, H M 75646, I/A 163 (31.03.17).

Cambio de objeto social. El objeto de la Sociedad es proveer a las entidades operativas espa帽olas que forman parte de la red KPMGde servicios de apoyo o soporte, recursos financieros, tecnol贸gicos, humanos, instalaciones,. Datos registrales. T 35408 , F 119, S 8,H M 75646, I/A 164 (31.03.17).

15 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apoderado: DURAN RODRIGUEZ VICENTE. Datos registrales. T 35408 , F 118, S 8, H M 75646, I/A 162 ( 7.03.17).

31 de Enero de 2017
Otros conceptos: Se declara que el auditor nombrado ha sido sustituido por "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia dela escritura de fusi贸n y segregaci贸n que caus贸 la inscripci贸n 1陋 de la hoja 624.626. Datos registrales. T 26351 , F 42, S 8, H M75646, I/A 150M (16.01.17).

27 de Enero de 2017
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ ZAPATERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 26351 , F 44, S 8, H M 75646, I/A 154(20.01.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SCOTT JOHN MACLEAN. Presidente: SCOTT JOHN MACLEAN. Consejero: GARCIA FERRERFERNANDO;PALLARES QUEROL RAMON. Secretario: PALLARES QUEROL RAMON. Nombramientos. Consejero: FAUS PEREZIGNACIO;GARCIA GRANDA CELSO;CANO FERRER JUAN JOSE. Presidente: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Secretario:GARCIA GRANDA CELSO. Datos registrales. T 26351 , F 44, S 8, H M 75646, I/A 155 (20.01.17).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA GRANDA CELSO. Datos registrales. T 35408 , F 114, S 8, H M 75646, I/A 156 (20.01.17).

Nombramientos. Apoderado: ZARATE MU脩OZ-REPISO MARTA. Datos registrales. T 35408 , F 114, S 8, H M 75646, I/A 157(20.01.17).

Nombramientos. Apoderado: BRETT ANDREW. Datos registrales. T 35408 , F 115, S 8, H M 75646, I/A 158 (20.01.17).

Nombramientos. Apoderado: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO. Apo.Manc.: FERNANDEZ-VILLARAN ARAMARIA EUGENIA;GARCIA GRANDA CELSO;BRETT ANDREW;FAUS PEREZ IGNACIO;ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO.Datos registrales. T 35408 , F 115, S 8, H M 75646, I/A 159 (20.01.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FAUS PEREZ IGNACIO. Apo.Manc.: FERNANDEZ-VILLARAN ARA MARIA EUGENIA;MARTELESGUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO;GARCIA GRANDA CELSO;BRETT ANDREW;ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO.Datos registrales. T 35408 , F 117, S 8, H M 75646, I/A 160 (20.01.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ-VILLARAN ARA MARIA EUGENIA;MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIALORETO;FERRER PASTOR CESAR;PALLARES QUEROL RAMON. Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ-VILLARAN ARAMARIA EUGENIA;MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO;FAUS PEREZ IGNACIO;GARCIA GRANDACELSO;BRETT ANDREW. Datos registrales. T 35408 , F 118, S 8, H M 75646, I/A 161 (20.01.17).

23 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: VALDES VERELST MARIA REYES. Datos registrales. T 26351 , F 43, S 8, H M 75646, I/A 151(15.09.16).

Nombramientos. Apoderado: ZARATE MU脩OZ-REPISO MARTA. Datos registrales. T 26351 , F 43, S 8, H M 75646, I/A 152(15.09.16).

Revocaciones. Apoderado: POCH VILAPLANA RAMON. Datos registrales. T 26351 , F 43, S 8, H M 75646, I/A 153 (15.09.16).

22 de Junio de 2016
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 26351 , F 42, S 8, H M 75646, I/A 150 (15.06.16).

31 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: PALLARES QUEROL RAMON;ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO;ZARATE MU脩OZ-REPISOMARTA. Datos registrales. T 26351 , F 42, S 8, H M 75646, I/A 149 (24.05.16).

26 de Mayo de 2016
Otros conceptos: Ratificado el nombramiento por cooptaci贸n como consejeros de D. Fernando Cu帽ado Garc铆a-Bernalt, D. MiguelArias Mench茅n y D. Fernando Serrate Urrea de la inscripci贸n 143& por la inscripci贸n 146&. Datos registrales. T 26351 , F 40, S 8, HM 75646, I/A 146 (17.05.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Apo.Manc.: FERNANDEZ-VILLARAN ARA MARIAEUGENIA;MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO;FERRER PASTOR CESAR;PALLARES QUEROL RAMON. Datosregistrales. T 26351 , F 40, S 8, H M 75646, I/A 147 (17.05.16).

Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 295C (MADRID). Datos registrales. T 26351 , F 41, S 8, H M 75646, I/A148 (17.05.16).

14 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO;REQUENA RODRIGUEZ ANGEL;REQUENA RODRIGUEZ ANGEL.

24 de Febrero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 60.358,43 Euros. Desembolsado: 60.358,43 Euros. Resultante Suscrito: 663.942,73 Euros.Resultante Desembolsado: 663.942,73 Euros. Datos registrales. T 26351 , F 38, S 8, H M 75646, I/A 144 (15.02.16).

21 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MENDOZA DIAZ AGUADO VICTOR;PEREZ BERMEJO FRANCISCO;FERRER PASTOR CESAR.Nombramientos. Consejero: CU脩ADO GARCIA BERNALT FERNANDO;ARIAS MENCHEN MIGUEL;SERRATE URREAFERNANDO. Datos registrales. T 26351 , F 37, S 8, H M 75646, I/A 143 (13.01.16).

26 de Agosto de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 38.644,30 Euros. Desembolsado: 38.644,30 Euros. Resultante Suscrito: 603.584,30 Euros.Resultante Desembolsado: 603.584,30 Euros. Datos registrales. T 26351 , F 35, S 8, H M 75646, I/A 141 (13.08.15).

Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 26351 , F 37, S 8, H M 75646, I/A 142 (13.08.15).

01 de Junio de 2015
Revocaciones. Apoderado: FORNIELES MELERO ANTONIO ENRIQUE;LAGEN VIDAL JUAN;FORNIELES MELERO ANTONIOENRIQUE;LEIVAR ARAGON JOSE IGNACIO;GIL REINA RAFAEL FRANCISCO;LLORENTE BASTARDO JUAN JOSE. Datosregistrales. T 26351 , F 33, S 8, H M 75646, I/A 137 (21.05.15).

P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 26351 , F 33, S 8, H M 75646, I/A 138 (21.05.15).

Otros conceptos: facultad al Consejo de Administraci贸n de la Sociedad, para que pueda acordar, en una o varias veces, el aumentodel capital social de la Sociedad hasta una cifra determinada en cada caso, con la limitaci贸n de que no puee ser superior a la mitad delcapital existente en el momento del acuerdo. Datos registrales. T 26351 , F 33, S 8, H M 75646, I/A 139 (21.05.15).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS ARTICULOS 1, 7, 9, 11, 12, 12BIS, 13, 14,15, 21, 22, 25 Y 26 Y CREADO EL NUEVO ARTICULO 14 BIS. . Cambio de objeto social. El objeto de la Sociedad es proveer a lasentidades operativas espa帽olas queforman parte de la red KPMG de servicios de apoyo o soporte, recursosfinancieros, tecnol贸gicos,humanos, instalaciones, y dem谩s recursos materiales, que sean necesarios para que dichas entidades puedan desarrollary cumplirsu.Datos registrales. T 26351 , F 34, S 8, H M 75646, I/A 140 (21.05.15).

15 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SL. Datos registrales. T 26351 , F 33, S 8, H M 75646, I/A 136 ( 8.01.15).

07 de Octubre de 2014
Nombramientos. Consejero: MENDOZA DIAZ AGUADO VICTOR;URIA FERNANDEZ FRANCISCO;SANCHEZ LOPEZOLGA;FERNANEZ VILLARAN ARA MARIA EUGENIA;PEREZ BERMEJO FRANCISCO;HOHN DAVID. Datos registrales. T 26351 , F31, S 8, H M 75646, I/A 135 (29.09.14).

08 de Septiembre de 2014
Modificaciones estatutarias. 6. Acciones/Participaciones.-. 12 bis. Adopcion de acuerdos.-. Datos registrales. T 26351 , F 31, S 8,H M 75646, I/A 134 (29.08.14).

19 de Agosto de 2014
Nombramientos. Consejero: GARCIA FERRER FERNANDO. Reelecciones. Consejero: FERRER PASTOR CESAR;PALLARESQUEROL RAMON. Secretario: PALLARES QUEROL RAMON. Datos registrales. T 26351 , F 31, S 8, H M 75646, I/A 133 ( 4.08.14).

19 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARTIN BLASCO JULIAN;LATORRE SAEZ JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 26351 , F 30, S8, H M 75646, I/A 131 (11.02.14).

Nombramientos. Consejero: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Datos registrales. T 26351 , F 30, S 8, H M 75646, I/A 132(11.02.14).

27 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ OSSORIO LABORDE FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 26351 , F 30, S 8, H M 75646,I/A 130 (19.12.13).

22 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SL. Datos registrales. T 26351 , F 30, S 8, H M 75646, I/A 129 (14.11.13).

06 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO;AGUILO GARCIA MARIA JOSE;MARTELES GUTIERREZ DELALAMO MARIA LORETO;FERRER PASTOR CESAR;PALLARES QUEROL RAMON. Datos registrales. T 26351 , F 29, S 8, H M75646, I/A 128 (28.10.13).

28 de Agosto de 2013
Revocaciones. Apoderado: PEREZ RUIZ JOSE LUIS;MIR ROMA JULIO;BORRAS PAMIES FEDERICO. Datos registrales. T 26351, F 29, S 8, H M 75646, I/A 127 (20.08.13).

03 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MADRID SL. Datos registrales. T 26351 , F 28, S 8, H M 75646, I/A 126 (22.09.12).

22 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apoderado: GARCIA LOZANO GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 26351 , F 28, S 8, H M 75646, I/A 124 (9.08.12).

Reelecciones. Consejero: SCOTT JOHN MACLEAN. Presidente: SCOTT JOHN MACLEAN. Datos registrales. T 26351 , F 28, S 8,H M 75646, I/A 125 ( 9.08.12).

29 de Junio de 2012
Revocaciones. Apoderado: GUILLEN PASTOR JOSE LUIS. Datos registrales. T 26351 , F 28, S 8, H M 75646, I/A 123 (19.06.12).

03 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: HERNAN CARRILLO VICTOR. Datos registrales. T 26351 , F 27, S 8, H M 75646, I/A 122 (22.03.12).

02 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: FERRER PUIG MIGUEL;SEBASTIAN DE ERICE SANCHEZ OCA脩A LUIS;ROSALES HERNANDEZJUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 26351 , F 27, S 8, H M 75646, I/A 120 (21.03.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA GRANDA CELSO. Otros conceptos: MODIFICADAS LAS FACULTADES MANCOMUNADASDE DO脩A MARIA JOSE AGUILO GARCIA Y DON HILARIO ALBARRACIN SANTA CRUZ, REFLEJADAS EN EL APARTADO "B" DELA INSCRIPCION 114&. Datos registrales. T 26351 , F 27, S 8, H M 75646, I/A 121 (22.03.12).

19 de Diciembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ JARE脩O DE LA PLAZA ANTONIO;GHOSH BASU DEBABRATA. Apo.Man.Soli: BORRASPAMIES FEDERICO;FORNIELES MELERO ANTONIO ENRIQUE. Apo.Manc.: FORNIELES MELERO ANTONIO. Datos registrales.T 26351 , F 26, S 8, H M 75646, I/A 119 ( 2.12.11).

25 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apoderado: MORENO CASAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 26351 , F 26, S 8, H M 75646, I/A 118 (15.03.11).

20 de Enero de 2011
Revocaciones. Apoderado: GARCIA POVEDANO JULIO;GUTIERREZ DE GARANDILLA GRAJALES FRANCISCO ADOLFO. Datosregistrales. T 26351 , F 26, S 8, H M 75646, I/A 117 (10.01.11).

27 de Octubre de 2010
Revocaciones. Apoderado: REQUENA RODRIGUEZ ANGEL;MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO. Otrosconceptos: MODIFICADOS LOS PODERES CONFERIDOS EN LA ESCRITURA ORIGEN DE LA INSCRIPCION 99& DE LA HOJAREGISTRAL. Datos registrales. T 26351 , F 25, S 8, H M 75646, I/A 116 (15.10.10).

21 de Julio de 2010
Nombramientos. Apoderado: TECLESMAYER FERRERO SEGOR. Datos registrales. T 26351 , F 24, S 8, H M 75646, I/A 115 (9.07.10).

19 de Julio de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTELES GUTIERREZ DEL ALAMO MARIA LORETO;FERRER PASTOR CESAR;PALLARESQUEROL RAMON. Apo.Manc.: AGUILO GARCIA MARIA JOSE;FORNIELES MELERO ANTONIO;ALBARRACIN SANTA CRUZHILARIO;GARCIA GRANDA CELSO;SCOTT JOHN MACLEAN. Datos registrales. T 26351 , F 24, S 8, H M 75646, I/A 114 (7.07.10).

22 de Abril de 2010
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ HERNANDEZ JESUS;WALTER NICOLET LUIS ALFREDO;SABAU GRAZIATI JAVIER.Apo.Sol.: ARANZABAL RODRIGUEZ GONZALO. Datos registrales. T 26351 , F 23, S 8, H M 75646, I/A 113 (13.04.10).

31 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: FORNIELES MELERO ANTONIO;REQUENA RODRIGUEZ ANGEL;BORRAS PAMIESFEDERICO;DEL CASTILLO CRESPO JOSE ANTONIO;GARCIA FERRER FERNANDO;GOMEZ JARE脩O DE LA PLAZAANTONIO;MORENO FAUSTE GREGORIO;RIOPEREZ ORTA JORGE;ABARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Secretario:ALBARRACIN SANTA CRUZ HILARIO. Consejero: SERRATE URREA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: FERRERPASTOR CESAR;PALLARES QUEROL RAMON. Secretario: PALLARES QUEROL RAMON. Datos registrales. T 26351 , F 22, S 8,H M 75646, I/A 112 (17.12.09).

14 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 26351 , F 22, S 8, H M75646, I/A 111 ( 1.12.09).

15 de Julio de 2009
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: KPMG EUROPE LLP. Datos registrales. T 26351 , F 22, S 8, H M 75646, I/A 110 (3.07.09).

27 de Mayo de 2009
Reelecciones. Auditor: ZOFIO AUDITORES SRL. Otros conceptos: =REELEGIDO= para el =ejercicio = en curso =1 de Julio de2.008 - 30 de Septiembre de 2.008,= como =AUDITOR DE CUENTAS=de la Sociedad, a la entidad ="ZOFIO AUDITORES S.R.L."=.Datos registrales. T 26351 , F 22, S 8, H M 75646, I/A 109 (18.05.09).

16 de Abril de 2009
Revocaciones. Apoderado: PEREZ LOZANO VALERIANO. Datos registrales. T 26351 , F 22, S 8, H M 75646, I/A 108 ( 2.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n