Actos BORME de Krata Sa
17 de Abril de 2023Fe de erratas: La inscripción correcta practicada con fecha 24/03/2023 es la inscripción 95ª y no la 92ª, ya que dicha inscripción 92ªfue practicada con fecha 07/12/2021. Datos registrales. T 6919 , F 32, S 8, H SE 24963, I/A 95 (24.03.23).
31 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: OLAVARRIA RODRIGUEZ ARANGO ANTONIO CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj:OLAVARRIA RODRIGUEZ ARANGO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 6919 , F 32, S 8, H SE 24963, I/A 92 (24.03.23).
10 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 6919 , F 32, S 8, H SE 24963, I/A 94 ( 1.02.23).
20 de Julio de 2022Reelecciones. Consejero: AMIANO GOITISOLO EMILIO;DE PABLO-ROMERO CARRANZA ANTONIO;AMIANO BERGARA IÑIGO.Cons.Del.Sol: DE PABLO-ROMERO CARRANZA ANTONIO. Consejero: RUFINO LAFFITTE FELIPE. Presidente: AMIANO BERGARAIÑIGO. SecreNoConsj: OLAVARRIA RODRIGUEZ ARANGO ANTONIO CARLOS. Datos registrales. T 6919 , F 31, S 8, H SE 24963,I/A 93 (12.07.22).
16 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: PAGAZAURTUNDUA MENA MARIA ANGELES;CENZANO CESTAFE DANIEL;BELLOT MIANAANNA;ABEIJON VAZQUEZ JAVIER;ELORRIAGA AGUIRRE ALAZNE. Otros conceptos: REVOCADO el PODER NO INSCRITO,otorgado a favor de don David Paramio Franco, mediante escritura otorgada el veintiséis de Septiembre de dos mil dieciocho, ante elNotario de Madrid, don Juan Aznar de la Haza, bajo el número 3371 de Protocolo. Datos registrales. T 6919 , F 31, S 8, H SE 24963,I/A 91 ( 3.12.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: RUFINO LAFFITTE FELIPE. Datos registrales. T 6919 , F 31, S 8, H SE 24963, I/A 92 ( 7.12.21).
27 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: ANAYA MOHINO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 6919 , F 30, S 8, H SE 24963, I/A 90(19.10.21).
16 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: LIMA GALLEGO EMILIO. Datos registrales. T 4989 , F 120, S 8, H SE 24963, I/A 89 ( 6.11.20).
11 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Presidente: AMIANO GOITISOLO EMILIO. Cons.Del.Sol: AMIANO GOITISOLO EMILIO;AMIANO BERGARAIÑIGO. Nombramientos. Presidente: AMIANO BERGARA IÑIGO. Datos registrales. T 4989 , F 120, S 8, H SE 24963, I/A 88 (3.08.20).
10 de Marzo de 2020Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 4989 , F 119, S 8, H SE 24963, I/A 87 ( 2.03.20).
25 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: OLAVARRIA RODRIGUEZ ARANGO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. SecreNoConsj:OLAVARRIA RODRIGUEZ ARANGO ANTONIO CARLOS. Datos registrales. T 4989 , F 119, S 8, H SE 24963, I/A 86 (17.01.19).
30 de Agosto de 2018Nombramientos. Consejero: RUFINO LAFFITTE FELIPE. Datos registrales. T 4989 , F 119, S 8, H SE 24963, I/A 85 (20.08.18).
31 de Agosto de 2017Reelecciones. Consejero: AMIANO GOITISOLO EMILIO;DE PABLO-ROMERO CARRANZA ANTONIO;AMIANO BERGARA IÑIGO.Presidente: AMIANO GOITISOLO EMILIO. Cons.Del.Sol: AMIANO GOITISOLO EMILIO;DE PABLO-ROMERO CARRANZAANTONIO;AMIANO BERGARA IÑIGO. SecreNoConsj: OLAVARRIA RODRIGUEZ ARANGO FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 4989 , F 118, S 8, H SE 24963, I/A 84 (21.08.17).
19 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 4989 , F 118, S 8, H SE 24963, I/A 83 (11.01.17).
20 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: FONT JIMENEZ ESPERANZA. Datos registrales. T 4989 , F 117, S 8, H SE 24963, I/A 81 ( 8.05.15).
Nombramientos. Apoderado: ELORRIAGA AGUIRRE ALAZNE. Datos registrales. T 4989 , F 118, S 8, H SE 24963, I/A 82 (8.05.15).
12 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: ABEIJON VAZQUEZ JAVIER. Datos registrales. T 4989 , F 117, S 8, H SE 24963, I/A 80 (20.11.14).
01 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: BELLOT MIANA ANNA. Datos registrales. T 4989 , F 117, S 8, H SE 24963, I/A 79 (20.11.14).
13 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: SANZ RIO MARIA PILAR;ANTONIO MARIN AREVALO;ANA PANDO LOPEZ;PUIG ALBA JOSERAMON;MOLINA BARRIENTOS PEDRO;LIMA GALLEGO EMILIO;DE PABLO-ROMERO CARRANZA ANTONIO;RUFINO LAFFITTEFELIPE;PEDRO SORIA CASADO;CENZANO CESTAFE DANIEL. Otros conceptos: Revocadas las facultades conferidas a favor deDON FELIPE RUFINO LAFFITTE y DON ANTONIO DE PABLO ROMERO CARRANZA, que fueron conferidas en Sevilla el díaveintinueve de mayo de dos mil uno , ante el notario Don Victorio Magariños Blanco , número 1.681 de protocolo. Datos registrales. T4989 , F 115, S 8, H SE 24963, I/A 78 ( 2.12.13).
09 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SVQ SL. Datos registrales. T 4989 , F 115, S 8, H SE 24963, I/A 77 (27.11.13).
13 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ MARTINEZ RICARDO JOSE;RAMIREZ COBOS JOSE;VAZQUEZ VERA MARIA PAZ;DELA CORTE DABRIO NURIA;MOLINA BARRIENTOS ANTONIO ANGEL. Datos registrales. T 4989 , F 115, S 8, H SE 24963, I/A 76 (5.12.12).
11 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DE PABLO-ROMERO CARRANZA ANTONIO;AMIANO BERGARA IÑIGO. Cons.Del.Sol: AMIANOGOITISOLO EMILIO;DE PABLO-ROMERO CARRANZA ANTONIO;AMIANO BERGARA IÑIGO. Consejero: AMIANO GOITISOLO
08 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: PUIG ALBA JOSE RAMON. Datos registrales. T 4989 , F 114, S 8, H SE 24963, I/A 73 (29.10.12).
Nombramientos. Apoderado: CENZANO CESTAFE DANIEL. Datos registrales. T 4989 , F 114, S 8, H SE 24963, I/A 74 (29.10.12).
01 de Junio de 2012Reelecciones. Consejero: AMIANO GOITISOLO EMILIO. Presidente: AMIANO GOITISOLO EMILIO. Datos registrales. T 4989 , F114, S 8, H SE 24963, I/A 72 (18.05.12).
26 de Marzo de 2012Revocaciones. Apoderado: PRETIUM S.L. Datos registrales. T 4989 , F 113, S 8, H SE 24963, I/A 71 (12.03.12).
14 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: MINGUELL OLIVAN RAMON. Datos registrales. T 4989 , F 113, S 8, H SE 24963, I/A 70 (28.10.11).
05 de Septiembre de 2011Nombramientos. Auditor: AUREN SEVILLA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4989 , F 113, S 8, H SE 24963, I/A 69(18.08.11).
26 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: LIMA GALLEGO EMILIO. Datos registrales. T 4989 , F 111, S 8, H SE 24963, I/A 67 (13.05.11).
Nombramientos. Apoderado: LIMA GALLEGO EMILIO. Datos registrales. T 4989 , F 112, S 8, H SE 24963, I/A 68 (13.05.11).
25 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO. Presidente: DE PABLO ROMERO CARRANZAANTONIO. Cons.Del.Sol: AMIANO BERGARA IÑIGO. Revocaciones. Apoderado: AMIANO GOITISOLO EMILIO;AMIANOGOITISOLO EMILIO;RUFINO LAFFITE FELIPE. Nombramientos. Presidente: AMIANO GOITISOLO EMILIO. Cons.Del.Sol: AMIANOGOITISOLO EMILIO;DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO;AMIANO BERGARA IÑIGO. Apo.Sol.: RUFINO LAFFITTE FELIPE.Datos registrales. T 4989 , F 111, S 8, H SE 24963, I/A 66 (15.06.10).
22 de Abril de 2010Revocaciones. Apoderado: MOLINA BARRIENTOS PEDRO. Datos registrales. T 4989 , F 110, S 8, H SE 24963, I/A 63 (12.04.10).
Nombramientos. Apoderado: MOLINA BARRIENTOS ANTONIO ANGEL. Datos registrales. T 4989 , F 110, S 8, H SE 24963, I/A64 (12.04.10).
29 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: RUFINO LAFFITE FELIPE. Presidente: AMIANO GOITISOLO EMILIO;DE PABLO ROMEROCARRANZA ANTONIO. Secretario: LIMA GALLEGO EMILIO. Nombramientos. Consejero: AMIANO BERGARA IÑIGO. Presidente:DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO. SecreNoConsj: OLAVARRIA RODRIGUEZ ARANGO FRANCISCO JAVIER.Cons.Del.Sol: AMIANO BERGARA IÑIGO. Datos registrales. T 4989 , F 109, S 8, H SE 24963, I/A 62 (18.01.10).
03 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: MENDEZ GALLART CONSUELO. Datos registrales. T 4989 , F 109, S 8, H SE 24963, I/A 61(22.10.09).
22 de Mayo de 2009Revocaciones. Apoderado: SILVA FERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4989 , F 109, S 8, H SE 24963, I/A 60 (12.05.09).