Actos BORME de Kripsol Aragon Sl
02 de Marzo de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1650 , F 222, S 8, H TO 36678, I/A 10 (22.02.18).
22 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAMOND ANDREW JOHN;DAVIS ROBERT MICHAEL;HALE CLARK RANDOLPH. Secretario:DIAMOND ANDREW JOHN. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Nombramientos.Adm. Solid.: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1628 , F 173, S 8, H TO 36678, I/A8 Y 9 (15.01.18).
28 de Diciembre de 2017Otros conceptos: Modificaci贸n no esencial del proyecto de fusi贸n de fecha 23/06/2017, excluyendo a "KRIPSOL INTERMARKMALAGA, SL" del per铆metro de la fusi贸n y el traslado del domicilio social de "SUGAR VALLEY, SL", "FIBERPOOL INTERNACIONAL,SL" y "HAYWARD POOL ACQUISITION, SL", a Yuncos, Toledo, Calle Felipe II. Datos registrales. T 1628 , F 172, S 8, H TO 36678,I/A 7 m (14.12.17).
13 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DECANALES ALMUDENA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Apo.Sol.:LOPEZ BLANCO ANGEL. Nombramientos. Apo.Sol.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Apo.Manc.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 171, S 8, H TO 36678, I/A 7 ( 6.02.17).
21 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Nombramientos. Consejero: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMONDANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario: DIAMOND ANDREW JOHN.Apo.Sol.: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1595 , F 65, S 8, H TO36678, I/A 4 (15.09.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARROFE PUJOL ALBERT;FABREGA RODRIGUEZ-RODA ANNA;SALA CLIMENT MARIATERESA;BIDAGUREN URBIETA MIREN;RIVERA GARCIA DIANA. Datos registrales. T 1628 , F 169, S 8, H TO 36678, I/A 5(15.09.16).
Revocaciones. Apoderado: ELIO LEVI. Apo.Man.Soli: ALMAGRO RECIO ANA-MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;GARCIASANCHEZ MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 169, S 8, H TO 36678, I/A 6 (15.09.16).
25 de Agosto de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORO GARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1595 , F 64, S 8, H TO 36678, I/A 3 (18.08.16).
03 de Noviembre de 2014Otros conceptos: Certificaci贸n expedida el 17 de septiembre de 2014 por el Registro Mercantil de Zaragoza para traslado dedomicilio social a esta provincia. Datos registrales. T 1595 , F 56, S 8, H TO 36678, I/A 1 (23.10.14).
Cambio de domicilio social. C/ FELIPE II, PARCELA 141 - POLIGONO INDUSTRIAL L (YUNCOS). Datos registrales. T 1595 , F64, S 8, H TO 36678, I/A 2 (23.10.14).
24 de Septiembre de 2014Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: KRIPSOL HIDRAULICA SL. Datos registrales. T 2807 , F 145, S 8, H Z 31391,BIS ,I/ 9 .(15.09.14).
17 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MELIDA LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: ALCAINE ZAPATA ISRAEL.Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 90.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:90.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 90.000,00 Euros. Datos registrales. T 2807 , F 145, S 8, H Z 31391,BIS , I/ 8 .(10.09.14).
06 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALMAGRO RECIO ANA-MARIA;MORO GARRUDO FERNANDO;ALCAINE ZAPATAISRAEL;GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Datos registrales. T 2807 , F 144, S 8, H Z 31391,BIS , I/ 7 .(22.04.13).