Buscador CIF Logo

Actos BORME Kripsol Export Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Kripsol Export Sl

Actos BORME Kripsol Export Sl - B80065311

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Toledo para Kripsol Export Sl con CIF B80065311

馃敊 Perfil de Kripsol Export Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Toledo

Actos BORME de Kripsol Export Sl

02 de Marzo de 2018
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1650 , F 224, S 8, H TO 6004, I/A 36 (22.02.18).

22 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH;DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario:DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Nombramientos.Adm. Solid.: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1628 , F 214, S 8, H TO 6004, I/A34-35 (15.01.18).

28 de Diciembre de 2017
Otros conceptos: Modificaci贸n no esencial del proyecto de fusi贸n de fecha 23/06/2017, excluyendo a "KRIPSOL INTERMARKMALAGA, SL" del per铆metro de la fusi贸n y el traslado del domicilio social de "SUGAR VALLEY, SL", "FIBERPOOL INTERNACIONAL,SL" y "HAYWARD POOL ACQUISITION, SL", a Yuncos, Toledo, Calle Felipe II. Datos registrales. T 1628 , F 213, S 8, H TO 6004,I/A 31 (14.12.17).

13 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Manc.: RODRIGUEZGONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Manc.: LOPEZBLANCO ANGEL. Apo.Sol.: LOPEZ BLANCO ANGEL. Nombramientos. Apo.Sol.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZDE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Apo.Manc.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 212, S 8, H TO 6004, I/A31-32 ( 6.02.17).

19 de Enero de 2017
Revocaciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1628 , F 212, S 8, H TO 6004, I/A 30(12.01.17).

21 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL;DANA GESTION SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario:PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Consejero: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH.Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario: DIAMOND ANDREW JOHN. Apo.Sol.: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMONDANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Datos registrales. T 1563 , F 62, S 8, H TO 6004, I/A 27 (15.09.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARROFE PUJOL ALBERT;FABREGA RODRIGUEZ-RODA ANNA;SALA CLIMENT MARIATERESA;BIDAGUREN URBIETA MIREN;RIVERA GARCIA DIANA. Datos registrales. T 1628 , F 210, S 8, H TO 6004, I/A 28(15.09.16).

Revocaciones. Apo.Sol.: ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Apo.Manc.: ALCAINE ZAPATAISRAEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINEZAPATA ISRAEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 210, S 8, H TO 6004, I/A 29 (15.09.16).

11 de Julio de 2016
Otros conceptos: CAMBIADO EL REPRESENTANTE PERSONA FISICA DE LA SOCIEDAD "DANA GESTION" PASANDO A SERDON ELIO LEVI, CON N.I.E. X0708018D. Datos registrales. T 1563 , F 62, S 8, H TO 6004, I/A 26 ( 4.07.16).

01 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1563 , F 62, S 8, H TO 6004, I/A 25 (23.11.15).

10 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAISSL;DANA GESTION SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organode Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1563 , F 62, S 8, H TO 6004, I/A 24 (3.08.15).

04 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: REAL SIDI SL;PRIMBRAIS SL;JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Presidente: JOIMAALBA SL. Nombramientos. Adm. Solid.: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1562 , F 101, S 8, H TO 6004, I/A 23(23.04.15).

23 de Febrero de 2015
Cambio de domicilio social. C/ FELIPE II 59-65 - POLIGONO INDUSTRIAL LA VILLA (YUNCOS). Datos registrales. T 1562 , F101, S 8, H TO 6004, I/A 22 (16.02.15).

03 de Noviembre de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Sol.: MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Man.Soli: MOROGARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1562 , F 101, S 8, H TO 6004, I/A 21 (23.10.14).

20 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;MOROGARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1562 , F 100, S 8, H TO 6004, I/A 20 (11.11.13).

17 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;RECIO PEREZ ANA-MARIA;GARCIA CLAVIJOMANUEL;DANA GESTION SL. Presidente: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE. Cons.Del.Sol: GARCIA CLAVIJO MANUEL.Secretario: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Nombramientos. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL;REAL SIDI SL. Presidente:JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Datos registrales. T 1562 , F 100, S 8, H TO 6004, I/A 19 ( 7.10.13).

13 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: LEVI ELIO. Nombramientos. Consejero: DANA GESTION SL. Datos registrales. T 1562 , F 100, S8, H TO 6004, I/A 18 ( 5.08.13).

12 de Julio de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 1562 , F 100, S 8, H TO 6004, I/A 17 ( 4.07.13).

22 de Marzo de 2013
Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1562 , F 100, S 8, H TO 6004, I/A 16(14.03.13).

04 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERREIRA SOTELO ROSA;ALCAINE GIL JESUS MARIA. Presidente: ALCAINE GIL JESUS MARIA.Nombramientos. Consejero: LEVI ELIO. Presidente: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE. Datos registrales. T 1466 , F77, S 8, H TO 6004, I/A 15 (25.02.13).

27 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: LEVI ELIO. Secretario: LEVI ELIO. Cons.Del.Sol: LEVI ELIO. Consejero: JIMENEZ ROMEROFRANCISCO. Nombramientos. Consejero: RECIO PEREZ ANA-MARIA;FERREIRA SOTELO ROSA. Presidente: ALCAINE GILJESUS MARIA. Secretario: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Fe de erratas: Rectificado el nombre del Consejero DON JOSE-MARIAALCAINE GIL nombrado enla escritura que motiv贸 la inscripci贸n 10& por el de DON JESUS-MARIA ALCAINE GIL. Datos registrales.T 1466 , F 76, S 8, H TO 6004, I/A 12 (16.12.10).

Revocaciones. Apoderado: LEVI ELIO;GARCIA CLAVIJO MANUEL;RECIO PEREZ ANA-MARIA. Datos registrales. T 1466 , F 76,S 8, H TO 6004, I/A 13 (16.12.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: ALMAGRO RECIO ANA MARIA;VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON;MORO GARRUDO

27 de Abril de 2010
Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1466 , F 76, S 8, H TO 6004, I/A 11(15.04.10).

18 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KRIPSOL GESTION SL. Nombramientos. Consejero: GARCIA CLAVIJO MANUEL;ALCAINE GILJOSE MARIA;ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;JIMENEZ ROMERO FRANCISCO;LEVI ELIO. Presidente: GARCIACLAVIJO MANUEL. Secretario: LEVI ELIO. Cons.Del.Sol: GARCIA CLAVIJO MANUEL;LEVI ELIO. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 719 , F 126, S 8, H TO6004, I/A 10 ( 5.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n