Actos BORME de Kripsol Export Sl
02 de Marzo de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1650 , F 224, S 8, H TO 6004, I/A 36 (22.02.18).
22 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH;DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario:DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Nombramientos.Adm. Solid.: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1628 , F 214, S 8, H TO 6004, I/A34-35 (15.01.18).
28 de Diciembre de 2017Otros conceptos: Modificaci贸n no esencial del proyecto de fusi贸n de fecha 23/06/2017, excluyendo a "KRIPSOL INTERMARKMALAGA, SL" del per铆metro de la fusi贸n y el traslado del domicilio social de "SUGAR VALLEY, SL", "FIBERPOOL INTERNACIONAL,SL" y "HAYWARD POOL ACQUISITION, SL", a Yuncos, Toledo, Calle Felipe II. Datos registrales. T 1628 , F 213, S 8, H TO 6004,I/A 31 (14.12.17).
13 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Manc.: RODRIGUEZGONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Manc.: LOPEZBLANCO ANGEL. Apo.Sol.: LOPEZ BLANCO ANGEL. Nombramientos. Apo.Sol.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZDE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Apo.Manc.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 212, S 8, H TO 6004, I/A31-32 ( 6.02.17).
19 de Enero de 2017Revocaciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1628 , F 212, S 8, H TO 6004, I/A 30(12.01.17).
21 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL;DANA GESTION SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario:PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Consejero: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH.Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario: DIAMOND ANDREW JOHN. Apo.Sol.: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMONDANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Datos registrales. T 1563 , F 62, S 8, H TO 6004, I/A 27 (15.09.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARROFE PUJOL ALBERT;FABREGA RODRIGUEZ-RODA ANNA;SALA CLIMENT MARIATERESA;BIDAGUREN URBIETA MIREN;RIVERA GARCIA DIANA. Datos registrales. T 1628 , F 210, S 8, H TO 6004, I/A 28(15.09.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Apo.Manc.: ALCAINE ZAPATAISRAEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINEZAPATA ISRAEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 210, S 8, H TO 6004, I/A 29 (15.09.16).
11 de Julio de 2016Otros conceptos: CAMBIADO EL REPRESENTANTE PERSONA FISICA DE LA SOCIEDAD "DANA GESTION" PASANDO A SERDON ELIO LEVI, CON N.I.E. X0708018D. Datos registrales. T 1563 , F 62, S 8, H TO 6004, I/A 26 ( 4.07.16).
01 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1563 , F 62, S 8, H TO 6004, I/A 25 (23.11.15).
10 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAISSL;DANA GESTION SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organode Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1563 , F 62, S 8, H TO 6004, I/A 24 (3.08.15).
04 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: REAL SIDI SL;PRIMBRAIS SL;JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Presidente: JOIMAALBA SL. Nombramientos. Adm. Solid.: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1562 , F 101, S 8, H TO 6004, I/A 23(23.04.15).
23 de Febrero de 2015Cambio de domicilio social. C/ FELIPE II 59-65 - POLIGONO INDUSTRIAL LA VILLA (YUNCOS). Datos registrales. T 1562 , F101, S 8, H TO 6004, I/A 22 (16.02.15).
03 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Sol.: MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Man.Soli: MOROGARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1562 , F 101, S 8, H TO 6004, I/A 21 (23.10.14).
20 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;MOROGARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1562 , F 100, S 8, H TO 6004, I/A 20 (11.11.13).
17 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;RECIO PEREZ ANA-MARIA;GARCIA CLAVIJOMANUEL;DANA GESTION SL. Presidente: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE. Cons.Del.Sol: GARCIA CLAVIJO MANUEL.Secretario: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Nombramientos. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL;REAL SIDI SL. Presidente:JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Datos registrales. T 1562 , F 100, S 8, H TO 6004, I/A 19 ( 7.10.13).
13 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LEVI ELIO. Nombramientos. Consejero: DANA GESTION SL. Datos registrales. T 1562 , F 100, S8, H TO 6004, I/A 18 ( 5.08.13).
12 de Julio de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 1562 , F 100, S 8, H TO 6004, I/A 17 ( 4.07.13).
22 de Marzo de 2013Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1562 , F 100, S 8, H TO 6004, I/A 16(14.03.13).
04 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: FERREIRA SOTELO ROSA;ALCAINE GIL JESUS MARIA. Presidente: ALCAINE GIL JESUS MARIA.Nombramientos. Consejero: LEVI ELIO. Presidente: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE. Datos registrales. T 1466 , F77, S 8, H TO 6004, I/A 15 (25.02.13).
27 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: LEVI ELIO. Secretario: LEVI ELIO. Cons.Del.Sol: LEVI ELIO. Consejero: JIMENEZ ROMEROFRANCISCO. Nombramientos. Consejero: RECIO PEREZ ANA-MARIA;FERREIRA SOTELO ROSA. Presidente: ALCAINE GILJESUS MARIA. Secretario: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Fe de erratas: Rectificado el nombre del Consejero DON JOSE-MARIAALCAINE GIL nombrado enla escritura que motiv贸 la inscripci贸n 10& por el de DON JESUS-MARIA ALCAINE GIL. Datos registrales.T 1466 , F 76, S 8, H TO 6004, I/A 12 (16.12.10).
Revocaciones. Apoderado: LEVI ELIO;GARCIA CLAVIJO MANUEL;RECIO PEREZ ANA-MARIA. Datos registrales. T 1466 , F 76,S 8, H TO 6004, I/A 13 (16.12.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALMAGRO RECIO ANA MARIA;VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON;MORO GARRUDO
27 de Abril de 2010Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1466 , F 76, S 8, H TO 6004, I/A 11(15.04.10).
18 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KRIPSOL GESTION SL. Nombramientos. Consejero: GARCIA CLAVIJO MANUEL;ALCAINE GILJOSE MARIA;ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;JIMENEZ ROMERO FRANCISCO;LEVI ELIO. Presidente: GARCIACLAVIJO MANUEL. Secretario: LEVI ELIO. Cons.Del.Sol: GARCIA CLAVIJO MANUEL;LEVI ELIO. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 719 , F 126, S 8, H TO6004, I/A 10 ( 5.03.09).