Buscador CIF Logo

Actos BORME Kripsol Gestion Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Kripsol Gestion Sl

Actos BORME Kripsol Gestion Sl - B45487188

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Toledo para Kripsol Gestion Sl con CIF B45487188

馃敊 Perfil de Kripsol Gestion Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Toledo

Actos BORME de Kripsol Gestion Sl

02 de Marzo de 2018
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1628 , F 180, S 8, H TO 16730, I/A 26 (22.02.18).

22 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH;DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario:DIAMOND ANDREW JOHN. Cons.Del.Sol: HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Nombramientos.Adm. Solid.: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1628 , F 180, S 8, H TO 16730, I/A 25 (15.01.18).

28 de Diciembre de 2017
Otros conceptos: Modificaci贸n no esencial del proyecto de fusi贸n de fecha 23/06/2017, excluyendo a "KRIPSOL INTERMARKMALAGA, SL" del per铆metro de la fusi贸n y el traslado del domicilio social de "SUGAR VALLEY, SL", "FIBERPOOL INTERNACIONAL,

13 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DECANALES ALMUDENA. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Manc.: LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Sol.: LOPEZ BLANCO ANGEL. Nombramientos. Apo.Sol.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Apo.Manc.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 178, S 8, H TO 16730, I/A23-24 ( 6.02.17).

19 de Enero de 2017
Revocaciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Aud.C.Con.: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datosregistrales. T 1628 , F 178, S 8, H TO 16730, I/A 22 (12.01.17).

04 de Octubre de 2016
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: HAYWARD POOL ACQUISITION SL. Datos registrales. T 1628 , F 178, S 8, H TO16730, I/A 21 (26.09.16).

21 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL UNEX SL;DANA GESTION SL;JOIMA ALBA SL;PRIMBRAISSL;REAL SIDI SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Consejero: DAVIS ROBERTMICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario: DIAMONDANDREW JOHN. Apo.Sol.: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN. Cons.Del.Sol: HALE CLARK RANDOLPH. Datosregistrales. T 1601 , F 65, S 8, H TO 16730, I/A 18 (15.09.16).

Revocaciones. Apoderado: ALCAINE GIL JESUS MARIA;LEVI ELIO;ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;GARCIACLAVIJO MANUEL;ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;RECIO PEREZ ANA-MARIA. Apo.Sol.: ALMAGRO RECIO ANAMARIA. Apo.Manc.: ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Apo.Sol.: ALCAINE ZAPATA ISRAEL;ALMAGRORECIO ANA-MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;GARCIA SANCHEZ DE PUERTA MIGUEL. Apo.Manc.: ALMAGRO RECIO ANA-MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;GARCIA SANCHEZ DE PUERTA MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZMIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZMIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 176, S 8, HTO 16730, I/A 19 (15.09.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARROFE PUJOL ALBERT;FABREGA RODRIGUEZ-RODA ANNA;SALA CLIMENT MARIATERESA;BIDAGUREN URBIETA MIREN;RIVERA GARCIA DIANA. Datos registrales. T 1628 , F 178, S 8, H TO 16730, I/A 20(15.09.16).

11 de Julio de 2016
Otros conceptos: CAMBIADO EL REPRESENTANTE PERSONA FISICA DE LA SOCIEDAD "DANA GESTION" PASANDO A SERDON ELIO LEVI, CON N.I.E. X0708018D. Datos registrales. T 1601 , F 65, S 8, H TO 16730, I/A 17 ( 4.07.16).

19 de Enero de 2016
Nombramientos. Aud.C.Con.: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1601 , F 65, S 8, H TO 16730, I/A 16(11.01.16).

14 de Agosto de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: ALMAGRO RECIO ANA-MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;GARCIA SANCHEZ DE PUERTA MIGUEL.Apo.Manc.: ALMAGRO RECIO ANA-MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;GARCIA SANCHEZ DE PUERTA MIGUEL. Datosregistrales. T 1601 , F 64, S 8, H TO 16730, I/A 15 ( 6.08.15).

10 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCAINE GIL JESUS MARIA;GARCIA CLAVIJO MANUEL;LEVI ELIO;ALMAGRO SANCHEZ DEPUERTA VICENTE;JIMENEZ ROMERO FRANCISCO. Presidente: ALCAINE GIL JESUS MARIA. Cons.Del.Sol: ALCAINE GIL JESUSMARIA. Secretario: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Cons.Del.Sol: LEVI ELIO;JIMENEZ ROMERO FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL;REAL SIDI SL;DANA GESTION SL;CORPORACION EMPRESARIAL UNEX SL.Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Datos registrales. T 1601 , F 64, S 8, H TO 16730, I/A 14 ( 3.08.15).

23 de Febrero de 2015
Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1465 , F 74, S 8, H TO 16730, I/A 13(16.02.15).

03 de Noviembre de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Sol.: MORO GARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1465 ,F 74, S 8, H TO 16730, I/A 12 (23.10.14).

27 de Marzo de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.642.130,38 Euros. Resultante Suscrito: 10.162.530,08 Euros. Datos registrales. T 1465 , F 73, S8, H TO 16730, I/A 11 (20.03.14).

04 de Marzo de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 1465 , F 73, S 8, H TO 16730, I/A 10 (25.02.13).

29 de Abril de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: ALMAGRO RECIO ANA MARIA. Apo.Manc.: ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATAISRAEL;MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Sol.: ALCAINE ZAPATA ISRAEL;MORO GARRUDO FERNANDO;VAZQUEZ PEREZJOSE RAMON. Datos registrales. T 1465 , F 73, S 8, H TO 16730, I/A 9 (18.04.11).

11 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE. Cons.Del.Sol: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTAVICENTE. Nombramientos. Consejero: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Secretario: GARCIA CLAVIJO MANUEL. Otros conceptos:Modificado el art铆culo 9, a帽adido un nuevo art铆culo 9 BIS ymodificado el art铆culo 12 de los Estatutos sociales. Datos registrales. T1174 , F 221, S 8, H TO 16730, I/A 8 (26.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n