Actos BORME de Kripsol Hidraulica Sl
02 de Marzo de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1650 , F 220, S 8, H TO 6008, I/A 30 (22.02.18).
22 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH;DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario:DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Nombramientos.Adm. Solid.: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1628 , F 200, S 8, H TO 6008, I/A28-29 (15.01.18).
28 de Diciembre de 2017Otros conceptos: Modificaci贸n no esencial del proyecto de fusi贸n de fecha 23/06/2017, excluyendo a "KRIPSOL INTERMARKMALAGA, SL" del per铆metro de la fusi贸n y el traslado del domicilio social de "SUGAR VALLEY, SL", "FIBERPOOL INTERNACIONAL,SL" y "HAYWARD POOL ACQUISITION, SL", a Yuncos, Toledo, Calle Felipe II. Datos registrales. T 1628 , F 199, S 8, H TO 6008,I/A 27 m (14.12.17).
13 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCOANGEL.Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Nombramientos. Apo.Sol.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Manc.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datosregistrales. T 1628 , F 198, S 8, H TO 6008, I/A 27 ( 6.02.17).
19 de Enero de 2017Revocaciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1628 , F 198, S 8, H TO 6008, I/A 26(12.01.17).
29 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Sol.: MORO GARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1628 ,F 198, S 8, H TO 6008, I/A 25 (19.09.16).
21 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DANA GESTION SL;JOIMA ALBA SL;REAL SIDI SL;CORPORACION EMPRESARIAL UNEXSL;PRIMBRAIS SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Consejero: DAVIS ROBERTMICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario: DIAMONDANDREW JOHN. Apo.Sol.: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH.Datos registrales. T 1519 , F 209, S 8, H TO 6008, I/A 22 (15.09.16).
Revocaciones. Apoderado: LEVI ELIO;FRANCO CASARRUBIOS MARIA DEL CARMEN. Apo.Manc.: FRANCO CASARRUBIOSMARIA DEL CARMEN;ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Apo.Sol.: ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Apo.Manc.: ALMAGRO RECIO ANA MARIA.Apo.Sol.: ALMAGRO RECIO ANA MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DECANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 196, S 8, H TO 6008, I/A 23 (15.09.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARROFE PUJOL ALBERT;FABREGA RODRIGUEZ-RODA ANNA;SALA CLIMENT MARIATERESA;BIDAGUREN URBIETA MIREN;RIVERA GARCIA DIANA. Datos registrales. T 1628 , F 198, S 8, H TO 6008, I/A 24(15.09.16).
21 de Octubre de 2015Otros conceptos: CAMBIADO EL REPRESENTANTE PERSONA FISICA DEL CONSEJERO REAL SIDI SL. Datos registrales. T1519 , F 209, S 8, H TO 6008, I/A 21 (13.10.15).
26 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: BITU MARIA OCTAVIANA;ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;RECIO PEREZ ANA-MARIA. Presidente: BITU MARIA OCTAVIANA. Secretario: RECIO PEREZ ANA-MARIA. Nombramientos. Consejero: JOIMA ALBASL;PRIMBRAIS SL;REAL SIDI SL;DANA GESTION SL;CORPORACION EMPRESARIAL UNEX SL. Presidente: JOIMA ALBA SL.Secretario: PRIMBRAIS SL. Otros conceptos: Modificado el art铆culo 19潞 de los estatutos sociales. Cambio de domicilio social. C/FELIPE II 59-65 - POLIGONO INDUSTRIAL LA VILLA (YUNCOS). Datos registrales. T 1519 , F 208, S 8, H TO 6008, I/A 20(15.06.15).
03 de Marzo de 2015Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1519 , F 208, S 8, H TO 6008, I/A 19(23.02.15).
13 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: ZAMARRON FRAILE JUAN-MANUEL. Datos registrales. T 1519 , F 208, S 8, H TO 6008, I/A 18(23.12.13).
04 de Marzo de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 1519 , F 208, S 8, H TO 6008, I/A 17 (25.02.13).
08 de Enero de 2013Revocaciones. Apoderado: VALLEZ BALBUENA FELIX. Datos registrales. T 1519 , F 208, S 8, H TO 6008, I/A 16 (20.12.12).
28 de Noviembre de 2011Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1519 , F 208, S 8, H TO 6008, I/A 15(17.11.11).
09 de Agosto de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON;MORO GARRUDO FERNANDO;ALCAINE ZAPATAISRAEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA. Apo.Manc.: MORO GARRUDO FERNANDO;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;ALMAGRO RECIOANA MARIA. Datos registrales. T 1519 , F 207, S 8, H TO 6008, I/A 14 (28.07.11).