Actos BORME de Kripsol Iberica Sl
02 de Marzo de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1628 , F 186, S 8, H TO 27369, I/A 13 (22.02.18).
22 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH;DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario:DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Nombramientos.Adm. Solid.: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1628 , F 186, S 8, H TO 27369, I/A 12 (15.01.18).
28 de Diciembre de 2017Otros conceptos: Modificaci贸n no esencial del proyecto de fusi贸n de fecha 23/06/2017, excluyendo a "KRIPSOL INTERMARKMALAGA, SL" del per铆metro de la fusi贸n y el traslado del domicilio social de "SUGAR VALLEY, SL", "FIBERPOOL INTERNACIONAL,SL" y "HAYWARD POOL ACQUISITION, SL", a Yuncos, Toledo, Calle Felipe II. Datos registrales. T 1628 , F 185, S 8, H TO 27369,I/A 11 m (14.12.17).
13 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Manc.: RODRIGUEZGONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Manc.: LOPEZBLANCO ANGEL. Apo.Sol.: LOPEZ BLANCO ANGEL. Nombramientos. Apo.Sol.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZDE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Apo.Manc.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 184, S 8, H TO 27369, I/A 11 ( 6.02.17).
04 de Octubre de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: HAYWARD POOL ACQUISITION SL. Datos registrales. T 1628 , F 184, S 8, H TO27369, I/A 10 (26.09.16).
21 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Nombramientos. Secretario: DIAMOND ANDREW JOHN. Consejero:DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Apo.Sol.:DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1414 , F 67, S 8, H TO 27369, I/A 7(15.09.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA CLAVIJO MANUEL;ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE;RECIO PEREZ ANA.Apoderado: RAMIREZ RUIZ PEDRO PABLO. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZDE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DECANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 182, S 8, H TO 27369, I/A 8 (15.09.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARROFE PUJOL ALBERT;FABREGA RODRIGUEZ-RODA ANNA;SALA CLIMENT MARIATERESA;BIDAGUREN URBIETA MIREN;RIVERA GARCIA DIANA. Datos registrales. T 1628 , F 184, S 8, H TO 27369, I/A 9(15.09.16).
12 de Julio de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 238.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.142.000,00 Euros. Datos registrales. T 1414 , F67, S 8, H TO 27369, I/A 6 (30.06.11).
19 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ RUIZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 1414 , F 67, S 8, H TO 27369, I/A 5 (10.01.11).