Actos BORME de Kripsol Piscinas Sa
02 de Marzo de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1628 , F 206, S 8, H TO 6006, I/A 20 (22.02.18).
22 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH;DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario:DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Nombramientos.Adm. Solid.: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1628 , F 206, S 8, H TO 6006, I/A 19 (15.01.18).
28 de Diciembre de 2017Otros conceptos: Modificaci贸n no esencial del proyecto de fusi贸n de fecha 23/06/2017, excluyendo a "KRIPSOL INTERMARKMALAGA, SL" del per铆metro de la fusi贸n y el traslado del domicilio social de "SUGAR VALLEY, SL", "FIBERPOOL INTERNACIONAL,SL" y "HAYWARD POOL ACQUISITION, SL", a Yuncos, Toledo, Calle Felipe II. Datos registrales. T 1628 , F 207, S 8, H TO 6006,I/A 18 m (14.12.17).
13 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Sol.: RODRIGUEZGONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Sol.: LOPEZBLANCO ANGEL. Apo.Manc.: LOPEZ BLANCO ANGEL. Nombramientos. Apo.Sol.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZGONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Apo.Manc.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DECANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 206, S 8, H TO 6006, I/A 18 ( 6.02.17).
19 de Enero de 2017Revocaciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1628 , F 206, S 8, H TO 6006, I/A 17(12.01.17).
21 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KRIPSOL GESTION SL. Nombramientos. Consejero: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMONDANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario: DIAMOND ANDREW JOHN.Apo.Sol.: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1577 , F 6, S 8, H TO6006, I/A 14 (15.09.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARROFE PUJOL ALBERT;FABREGA RODRIGUEZ-RODA ANNA;SALA CLIMENT MARIATERESA;BIDAGUREN URBIETA MIREN;RIVERA GARCIA DIANA. Datos registrales. T 1628 , F 203, S 8, H TO 6006, I/A 15(15.09.16).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA CLAVIJO MANUEL;LEVI ELIO. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Manc.: ALMAGRORECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINEZAPATA ISRAEL. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL.Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCOANGEL.Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Datos registrales. T 1628 , F 203, S 8, H TO 6006, I/A 16 (15.09.16).
16 de Marzo de 2015Cambio de domicilio social. C/ FELIPE II, 59-65 - POLIGONO INDUSTRIAL LA VILLA (YUNCOS). Datos registrales. T 1577 , F 6,S 8, H TO 6006, I/A 13 ( 9.03.15).
02 de Enero de 2015Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1577 , F 6, S 8, H TO 6006, I/A 12(23.12.14).
29 de Julio de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Manc.: MORO GARRUDO FERNANDO;MORO GARRUDOFERNANDO. Datos registrales. T 1577 , F 5, S 8, H TO 6006, I/A 11 (21.07.14).
20 de Noviembre de 2013Cambio de domicilio social. C/ DOS 91 - POLIGONO INDUSTRIAL LA FRONTERA (UGENA). Datos registrales. T 1577 , F 6, S 8,H TO 6006, I/A 10 (12.11.13).
26 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;MOROGARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 3707 , F 163, S 8, H M 63122, I/A 11 (19.09.13).
30 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANAMARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;MORO GARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 3707 , F 162, S 8, H M 63122, I/A 10(22.04.13).
29 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Nombramientos. Adm. Unico: KRIPSOL GESTION SL. Representan:ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Datos registrales. T 3707 , F 161, S 8, H M 63122, I/A 9 (19.04.13).
22 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ PEREZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 3707 , F 161, S 8, H M 63122, I/A 8 (14.02.13).
03 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALMAGRO RECIO ANA MARIA;MORO GARRUDO FERNANDO. Apo.Sol.: VAZQUEZ PEREZ JOSERAMON. Datos registrales. T 3707 , F 160, S 8, H M 63122, I/A 7 (18.04.11).
29 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALMAGRO SANCHEZ DE PUERTA VICENTE. Cambio de domicilio social. C/ PUERTO COTOS13, POLIGONO INDUSTRIAL LAS NIEVES (MOSTOLES). Datos registrales. T 3707 , F 158, S 8, H M 63122, I/A 6 (16.06.09).
18 de Marzo de 2009P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KRIPSOL GESTION SL. Nombramientos. Adm. Unico:ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Datos registrales. T 491 , F 28, S 8, H TO 6006, I/A 8 ( 5.03.09).