Buscador CIF Logo

Actos BORME Krones Iberica Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Krones Iberica Sa

Actos BORME Krones Iberica Sa - A08711251

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Krones Iberica Sa con CIF A08711251

🔙 Perfil de Krones Iberica Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Krones Iberica Sa

12 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: FORNE I NAYACH XAVIER. Datos registrales. T 38265 , F 38, S 8, H M 680883, I/A 14 ( 5.08.22).

16 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: RODL & PARTNER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 38265 , F 38, S 8, H M 680883, I/A 13 ( 8.11.21).

23 de Septiembre de 2021
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 81, OFICINA 1301 (MADRID). Datos registrales. T 38265 , F 37, S 8, HM 680883, I/A 12 (16.09.21).

21 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RICKER THOMAS. Nombramientos. Adm. Unico: HOLLER KLAUS. Datos registrales. T 38265 ,F 37, S 8, H M 680883, I/A 11 (14.06.21).

13 de Julio de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PLANET VICENTE LEONOR;GONZALEZ GIL GUILLERMO;FRANZ SCHECK. Nombramientos.Apoderado: FORNE I NAYACH XAVIER;GONZALEZ GIL GUILLERMO;KNOLL TINO RUDOLF. Datos registrales. T 38265 , F 36, S8, H M 680883, I/A 9 ( 6.07.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: KNOLL TINO RUDOLF. Datos registrales. T 38265 , F 36, S 8, H M 680883, I/A 10 ( 6.07.20).

02 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: FRANZ SCHECK. Datos registrales. T 38265 , F 36, S 8, H M 680883, I/A 8 (25.11.19).

29 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: RODL & PARTNER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 38265 , F 35, S 8, H M 680883, I/A 7 (22.11.19).

21 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: FRANZ SCHECK. Datos registrales. T 38265 , F 35, S 8, H M 680883, I/A 6 (14.11.19).

11 de Julio de 2019
Revocaciones. Apoderado: FRANZ SCHECK. Datos registrales. T 38265 , F 35, S 8, H M 680883, I/A 5 ( 4.07.19).

12 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: PLANET VICENTE LEONOR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PLANET VICENTELEONOR;GONZALEZ GIL GUILLERMO;FRANZ SCHECK. Datos registrales. T 38265 , F 34, S 8, H M 680883, I/A 4 ( 5.02.19).

06 de Febrero de 2019
Reelecciones. Auditor: RODL & PARTNER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 38265 , F 34, S 8, H M 680883, I/A 3 (29.01.19).

22 de Octubre de 2018
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 6. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. AVDABURGOS 19 6 - IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 38265 , F 34, S 8, H M 680883, I/A 2 (15.10.18).

12 de Julio de 2018
Revocaciones. APODERADO: GONZALEZ GIL GUILLERMO. APODERAD.SOL: JOHANN PAUL HINTERWIMMER. APODERADO:PLANET VICENTE LEONOR;KLAUS BERND FISCHER;BORRIES M BIAGOSCH;BORRIES M BIAGOSCH. Datos registrales. T39252 , F 48, S 8, H B 56878, I/A 57 ( 3.07.18).

29 de Mayo de 2018
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO DECIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 39252 , F 48, S 8, H B 56878, I/A 56 (22.05.18).

Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: JOHANN RAINULF DIEPOLD;CHRISTOPH KLENK;THOMAS RICKER. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: THOMAS RICKER. ADM.UNICO: THOMAS RICKER. Datos registrales. T 39252 , F 47, S 8, H B 56878, I/A 55(22.05.18).

18 de Noviembre de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: GONZALEZ GIL GUILLERMO. Datos registrales. T 39252 , F 46, S 8, H B 56878, I/A 54 (8.11.16).

24 de Febrero de 2016
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CHRISTOPH KLENK. Datos registrales. T 39252 , F 46, S 8, H B 56878, I/A 53 (17.02.16).

28 de Diciembre de 2015
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: JOHANN RAINULF DIEPOLD. Datos registrales. T 39252 , F 45, S 8, H B 56878, I/A 50(16.12.15).

Revocaciones. AUDIT.CUENT.: J DURAN & P MARINAS AUDITORES ASOCIADOS SCACJC. Datos registrales. T 39252 , F 45, S8, H B 56878, I/A 51 (16.12.15).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: RODL & PARTNER AUDITORES SA. Datos registrales. T 39252 , F 46, S 8, H B 56878, I/A 52(16.12.15).

26 de Septiembre de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: GONZALEZ GIL GUILLERMO. Datos registrales. T 39252 , F 45, S 8, H B 56878, I/A 49(18.09.14).

20 de Diciembre de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: J DURAN & P MARINAS AUDITORES ASOCIADOS SCACJC. Datos registrales. T 39252 , F 45,S 8, H B 56878, I/A 48 (13.12.13).

18 de Septiembre de 2013
Revocaciones. APODERADO: BORRIES M BIAGOSCH. Datos registrales. T 39252 , F 44, S 8, H B 56878, I/A 47 ( 6.09.13).

22 de Mayo de 2013
Nombramientos. APODERADO: GONZALEZ GIL GUILLERMO. Datos registrales. T 39252 , F 44, S 8, H B 56878, I/A 46(14.05.13).

22 de Noviembre de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: J DURAN & P MARINAS AUDITORES ASOCIADOS SCACJC. Datos registrales. T 39252 , F 44,S 8, H B 56878, I/A 45 (13.11.12).

16 de Diciembre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: J DURAN AND P MARINAS AUDITORES ASOCIADOS. Datos registrales. T 39252 , F 43, S 8, HB 56878, I/A 44 ( 1.12.11).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: J DURAN AND P MARINAS AUDITORES ASOCIADOS. Datos registrales. T 39252 , F 43, S 8, HB 56878, I/A 43 ( 1.12.11).

28 de Abril de 2011
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CHRISTOPH KLENK. Datos registrales. T 39252 , F 43, S 8, H B 56878, I/A 42 (15.04.11).

03 de Enero de 2011
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: HANS JURGEN THAUS. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: JOHANN RAINULF DIEPOLD. Datosregistrales. T 39252 , F 43, S 8, H B 56878, I/A 41 (22.12.10).

18 de Marzo de 2010
Nombramientos. APODERADO: PLANET VICENTE LEONOR. Datos registrales. T 39252 , F 42, S 8, H B 56878, I/A 40 ( 8.03.10).

04 de Diciembre de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: J DURAN AND P MARINAS AUDITORES ASOCIADOS. Datos registrales. T 39252 , F 42, S 8, HB 56878, I/A 39 (25.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información