Buscador CIF Logo

Actos BORME Kronotex Spain Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Kronotex Spain Sl

Actos BORME Kronotex Spain Sl - B98390461

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Kronotex Spain Sl con CIF B98390461

🔙 Perfil de Kronotex Spain Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Kronotex Spain Sl

13 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER;MACICIOR TELLECHEA JAVIER;BANKOV NIKOLAYLAZAROV;PEREZ ESTEBANEZ JULIA;GARCIA RUIZ NOELIA. Datos registrales. T 724, L 515, F 48, S 8, H BU 14698, I/A 31 (4.12.23).

Nombramientos. Apo.Manc.: MACICIOR TELLECHEA JAVIER;MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER;PLAZA IBEASDANIEL;PEREZ ESTEBANEZ JULIA;GARCIA RUIZ NOELIA;RAMIREZ ORTEGA MONICA. Datos registrales. T 724, L 515, F 48, S8, H BU 14698, I/A 32 ( 4.12.23).

Revocaciones. Apo.Manc.: ROMERO POZO MARIA TERESA;ROMERO POZO MARIA TERESA. Apo.Sol.: ROMERO POZO MARIATERESA. Apo.Manc.: ROMERO POZO MARIA TERESA. Apo.Sol.: ROMERO POZO MARIA TERESA. Datos registrales. T 724, L515, F 48, S 8, H BU 14698, I/A 33 ( 4.12.23).

Nombramientos. Apo.Manc.: PLAZA IBEAS DANIEL. Datos registrales. T 814, L 605, F 30, S 8, H BU 14698, I/A 34 ( 4.12.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: PLAZA IBEAS DANIEL. Datos registrales. T 814, L 605, F 30, S 8, H BU 14698, I/A 35 ( 4.12.23).

05 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: MARIN SOLIS ESTEFANIA. Datos registrales. T 724, L 515, F 48, S 8, H BU 14698, I/A 30 (29.09.23).

11 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MARIN SOLIS ESTEFANIA;GARCIA RUIZ NOELIA. Datos registrales. T 724, L 515, F 48, S 8, H BU14698, I/A 29 ( 5.05.23).

08 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: PLAZA IBEAS DANIEL. Apo.Sol.: PLAZA IBEAS DANIEL. Apo.Manc.: PLAZA IBEAS DANIEL. Datosregistrales. T 724, L 515, F 47, S 8, H BU 14698, I/A 28 (28.04.23).

09 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA RUIZ NOELIA. Apo.Sol.: GARCIA RUIZ NOELIA;ROMERO POZO MARIA TERESA. Datosregistrales. T 724, L 515, F 47, S 8, H BU 14698, I/A 27 ( 3.02.23).

10 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: FRANCO PORRAS JESUS ALFONSO;FRANCO PORRAS JESUS ALFONSO;FRANCO PORRASJESUS ALFONSO. Apo.Sol.: FRANCO PORRAS JESUS ALFONSO. Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ ESTEBANEZ JULIA.Datos registrales. T 724, L 515, F 46, S 8, H BU 14698, I/A 26 ( 4.10.22).

07 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: PEREZ ESTEBANEZ JULIA. Datos registrales. T 724, L 515, F 45, S 8, H BU 14698, I/A 25 (1.07.22).

03 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER;MACICIOR TELLECHEA JAVIER;GARCIA FERNANDEZPEDRO IGNACIO;FRANCO PORRAS JESUS ALFONSO. Datos registrales. T 724, L 515, F 45, S 8, H BU 14698, I/A 24 (25.02.22).

02 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 724, L 515, F 45, S 8, H BU 14698, I/A 23 (26.11.21).

05 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: COLLEN NEIL LESLIE;PARDO ECHARRI IÑIGO;NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;NAVARROGARCIA GUTIERREZ CARLOS;NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;COLLENNEIL LESLIE;COLLEN NEIL LESLIE. Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO POZO MARIA TERESA. Apo.Sol.: ROMERO POZOMARIA TERESA;PLAZA IBEAS DANIEL. Apo.Manc.: ROMERO POZO MARIA TERESA;PLAZA IBEAS DANIEL;MARTINEZ NADALFRANCISCO JAVIER;MACICIOR TELLECHEA JAVIER;FRANCO PORRAS JESUS ALFONSO;BANKOV NIKOLAY LAZAROV. Datosregistrales. T 724, L 515, F 44, S 8, H BU 14698, I/A 22 (29.10.21).

07 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;NAVARROGARCIA GUTIERREZ CARLOS. Datos registrales. T 724, L 515, F 43, S 8, H BU 14698, I/A 21 ( 1.10.19).

08 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO POZO MARIA TERESA. Datos registrales. T 724, L 515, F 43, S 8, H BU 14698, I/A 18(30.04.19).

21 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA ORTEGA SONIA;GARCIA ORTEGA SONIA. Nombramientos. Apo.Manc.: PARDO ECHARRIIÑIGO;PLAZA IBEAS DANIEL. Datos registrales. T 724, L 515, F 43, S 8, H BU 14698, I/A 17 (14.03.18).

03 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA ORTEGA SONIA;NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;COLLEN NEIL LESLIE;BANKOVNIKOLAY LAZAROV;FRANCO PORRAS JESUS ALFONSO. Apo.Man.Soli: MACICIOR TELLECHEA JAVIER;MARTINEZ NADALFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 700, L 491, F 116, S 8, H BU 14698, I/A 16 (28.12.16).

Nombramientos. Apo.Manc.: FRANCO PORRAS JESUS ALFONSO. Datos registrales. T 700, L 491, F 117, S 8, H BU 14698, I/A17 (28.12.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: MORENO DEL FRESNO JAVIER. Apo.Sol.: MORENO DEL FRESNO JAVIER. Apo.Man.Soli: MORENODEL FRESNO JAVIER;MORENO DEL FRESNO JAVIER. Apo.Sol.: MORENO DEL FRESNO JAVIER. Apo.Man.Soli: MORENO DELFRESNO JAVIER. Datos registrales. T 700, L 491, F 117, S 8, H BU 14698, I/A 18 (28.12.16).

21 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MORENO DEL FRESNO JAVIER. Nombramientos. Adm. Mancom.: MACICIOR TELLECHEAJAVIER. Datos registrales. T 700, L 491, F 116, S 8, H BU 14698, I/A 15 (15.12.16).

15 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;GARCIA ORTEGA SONIA;COLLEN NEIL LESLIE;BANKOVNIKOLAY LAZAROV. Apo.Man.Soli: MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER;MORENO DEL FRESNO JAVIER. Datos registrales.T 700, L 491, F 114, S 8, H BU 14698, I/A 14 ( 8.03.16).

08 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: MORENO DEL FRESNO JAVIER. Apo.Sol.: MORENO DEL FRESNO JAVIER;MORENO DEL FRESNOJAVIER. Datos registrales. T 700, L 491, F 113, S 8, H BU 14698, I/A 13 ( 2.02.16).

22 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS.Apo.Man.Soli: MORENO DEL FRESNO JAVIER. Apo.Manc.: COLLEN NEIL LESLIE;BANKOV NIKOLAY LAZAROV. Datosregistrales. T 674, L 465, F 45, S 8, H BU 14698, I/A 10 (15.12.15).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KRONOSPAN HOLDINGS SPAIN SL. Nombramientos. Adm. Mancom.: MORENO DEL FRESNOJAVIER;MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 700, L 491, F 113, S 8, H BU 14698, I/A 11 (15.12.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO DEL FRESNO JAVIER;MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 700, L491, F 113, S 8, H BU 14698, I/A 12 (15.12.15).

30 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS. Apo.Man.Soli: MARTINEZ NADAL FRANCISCOJAVIER;MORENO DEL FRESNO JAVIER. Apo.Manc.: BANKOV NIKOLAY LAZAROV. Datos registrales. T 674, L 465, F 45, S 8, HBU 14698, I/A 9 (24.09.15).

03 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER;MORENO DELFRESNO JAVIER;BANKOV NIKOLAY LAZAROV. Apo.Sol.: MARTINEZ NADAL FRANCISCO JAVIER;MORENO DEL FRESNOJAVIER. Datos registrales. T 674, L 465, F 44, S 8, H BU 14698, I/A 8 (28.10.14).

27 de Enero de 2014
Fe de erratas: Queda rectificado el artículo 14º de los Estatutos sociales, en el sentido que se añade la excepción que el ejercicio2012, cerrará a 31 de diciembre. Datos registrales. T 655, L 446, F 91, S 8, H BU 14698, I/A 7 (21.01.14).

18 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO DEL FRESNO JAVIER. Apo.Manc.: NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;RUIZORTEGA ADRIAN;MORENO DEL FRESNO JAVIER;SPYROU SPIROS;BANKOV NIKOLAY LAZAROV. Apo.Sol.: RUIZ ORTEGAADRIAN;MORENO DEL FRESNO JAVIER. Datos registrales. T 655, L 446, F 90, S 8, H BU 14698, I/A 6 (12.12.13).

18 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: NAVARRO GARCIA GUTIERREZ CARLOS;RUIZ ORTEGA ADRIAN;SPYROU SPIROS;BANKOVNIKOLAY LAZAROV. Datos registrales. T 655, L 446, F 89, S 8, H BU 14698, I/A 5 (11.12.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información