Actos BORME de Krugercorporation Sa
16 de Diciembre de 2022Reelecciones. Consj.Domini: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN. Presidente: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN. Con.Ind.:PLATARD DE QUENIN CAMON CARLOS. Secretario: GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. Con.Ind.: GUERREROGONZALEZ SHEIM FRANCISCO. MiCoAudi: PLATARD DE QUENIN CAMON CARLOS;GUERRERO GONZALEZ SHEIMFRANCISCO. SeCoAudi: GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. MeCoNoRe: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN.PreComNomRe: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN. MeCoNoRe: GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. SeCoNoRe:GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. Datos registrales. T 36661 , F 132, S 8, H M 628363, I/A 19 ( 9.12.22).
14 de Marzo de 2022Nombramientos. Aud.C.Con.: RODL & PARTNER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36661 , F 132, S 8, H M 628363, I/A 18 (7.03.22).
21 de Julio de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 101.189,18 Euros. Resultante Suscrito: 2.838.659,53 Euros. Datos registrales. T 36661 ,F 130, S 8, H M 628363, I/A 17 (14.07.21).
04 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: GORDILLO TOBAR FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: GORDILLO TOBAR FRANCISCO JAVIER.MiCoAudi: GORDILLO TOBAR FRANCISCO JAVIER. PreCoAudi: GORDILLO TOBAR FRANCISCO JAVIER. MeCoNoRe: GORDILLOTOBAR FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: KRUGER RIVADENEIRA PETER-IVAN. Vicepresid.: KRUGERRIVADENEIRA PETER-IVAN. MiCoAudi: KRUGER RIVADENEIRA PETER-IVAN. MeCoNoRe: KRUGER RIVADENEIRA PETER-IVAN. PreCoAudi: KRUGER RIVADENEIRA PETER-IVAN. Datos registrales. T 36661 , F 128, S 8, H M 628363, I/A 15 (26.02.20).
Nombramientos. Apoderado: KRUGER RIVADENEIRA PETER-IVAN. Datos registrales. T 36661 , F 129, S 8, H M 628363, I/A 16(26.02.20).
09 de Octubre de 2019Cambio de domicilio social. AVDA DE ITALIA 16 (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 36661 , F 128, S 8, H M628363, I/A 14 ( 2.10.19).
01 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ MORENO DE GUERRA MARTA ROSARIO. Datos registrales. T 36661 , F 127, S 8, H M628363, I/A 13 (25.07.19).
21 de Marzo de 2019Cambio de domicilio social. C/ LUCHANA 21 1潞 - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 36661 , F 127, S 8, H M 628363, I/A12 (14.03.19).
19 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: MONASTERIO INDABURU JAVIER;ICABALZETA ANGULO JUAN RAMON. Datos registrales. T36661 , F 125, S 8, H M 628363, I/A 11 (10.10.18).
13 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN. Nombramientos. Consejero: KRUGER TERAN ERNESTOIVAN. Consj.Domini: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN. Presidente: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN. Consejero: PLATARD DEQUENIN CAMON CARLOS;GORDILLO TOBAR FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: GORDILLO TOBAR FRANCISCO JAVIER.Cons.Ext.Ind: GORDILLO TOBAR FRANCISCO JAVIER. Consejero: GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. Secretario:GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. Cons.Ext.Ind: GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. MiCoAudi: GORDILLOTOBAR FRANCISCO JAVIER. PreCoAudi: GORDILLO TOBAR FRANCISCO JAVIER. MiCoAudi: PLATARD DE QUENIN CAMONCARLOS;GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. SeCoAudi: GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. MeCoNoRe:KRUGER TERAN ERNESTO IVAN. PreComNomRe: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN. MeCoNoRe: GORDILLO TOBARFRANCISCO JAVIER;GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. SeCoNoRe: GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO.Modificaciones estatutarias. Se modifica los estatutos sociales.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comisi贸n deAuditor铆a. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comisi贸n de Nombramientos y Retribuciones. Seaprueba el Reglamento de la Junta General de la sociedad. Se acuerda el Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Cambio dedomicilio social. C/ CASTILLO DE FUENSALDA脩A 4 - PUERTA 233 (ROZAS DE MADRID (LAS)). P谩gina web de la sociedad.Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.krugercorporation.com. Datos registrales. T 34938 , F 59, S 8, H M 628363, I/A 10 (5.02.18).
05 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: SALLES CARCELLER MANUEL. Datos registrales. T 34938 , F 59, S 8, H M 628363, I/A 9 (27.11.17).
14 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: GUERRERO GONZALEZ SHEIM FRANCISCO. Datos registrales. T 34938 , F 57, S 8, H M 628363,I/A 8 ( 3.11.17).
20 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MORENO DE GUERRA MARTA ROSARIO. Datos registrales. T 34938 , F 57, S 8, H M628363, I/A 7 (12.06.17).
06 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GORDILLO TOBAR FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 34938 , F 57, S 8, H M 628363, I/A 6(25.05.17).
06 de Febrero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 126.413,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.939.848,71 Euros. Datos registrales. T 34938 , F 56, S 8,H M 628363, I/A 5 (27.01.17).
18 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN;SALLES CARCELLER MANUEL. Nombramientos. Adm.Unico: KRUGER TERAN ERNESTO IVAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 34938 , F 55, S 8, H M 628363, I/A 3 (10.01.17).
Nombramientos. Apoderado: SALLES CARCELLER MANUEL. Datos registrales. T 34938 , F 55, S 8, H M 628363, I/A 4(10.01.17).