Buscador CIF Logo

Actos BORME Krustagroup Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Krustagroup Sa

Actos BORME Krustagroup Sa - A21008560

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Huelva para Krustagroup Sa con CIF A21008560

馃敊 Perfil de Krustagroup Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Huelva

Actos BORME de Krustagroup Sa

07 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: LIZARRIBAR SANS JUAN ANTONIO;SUAREZ GARMENDIA ELIAS;PASCUAL SUAREZ MANUELFRANCISCO. Con.Delegado: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Presidente: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Nombramientos.Consejero: SUAREZ GARMENDIA ELIAS;PASCUAL SUAREZ MANUEL FRANCISCO;LIZARRIBAR SANS JUAN ANTONIO;SUAREZGARMENDIA ELIAS. Presidente: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Datos registrales. T 595 , F 86, S 8, H H 9261, I/A 86 (14.02.23).

17 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL. Datos registrales. T 595 , F 85, S 8, H H 9261, I/A 85 ( 5.01.23).

07 de Abril de 2022
Otros conceptos: Acuerdo de refundici贸n del texto 铆ntegro de los Estatutos sociaels. Datos registrales. T 595 , F 83, S 8, H H 9261,I/A 84 (21.03.22).

14 de Febrero de 2022
Reelecciones. Auditor: UNIAUDIT JRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 595 , F 83, S 8, H H 9261, I/A 83 (31.01.22).

24 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL. Datos registrales. T 595 , F 82, S 8, H H 9261, I/A 82 (11.12.20).

11 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apoderado: MUGICA NARVAIZA PABLO. Dir. General: MUGICA NARVAIZA PABLO. Datos registrales. T 595 , F82, S 8, H H 9261, I/A 81 (22.07.20).

21 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: SUAREZ VILLA AMADOR. Secretario: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Presidente: SUAREZ VILLAAMADOR. Nombramientos. Presidente: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. SecreNoConsj: CA脩ADAS BOUWEN ANTONIO. Datosregistrales. T 595 , F 82, S 8, H H 9261, I/A 80 (25.06.20).

28 de Mayo de 2019
Nombramientos. Dir. General: MUGICA NARVAIZA PABLO. Dir.Adm.: LIZARRIBAR SANS JUAN ANTONIO. Director: PASCUALSUAREZ MANUEL FRANCISCO. D. Comercial: ECHEVERRIA MENDIZABAL IGNACIO;TUREGANO LARREY FELIPE.Con.Delegado: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Datos registrales. T 595 , F 81, S 8, H H 9261, I/A 79 (17.05.19).

23 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL. Datos registrales. T 595 , F 81, S 8, H H 9261, I/A 77 (11.01.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CELAYA MARTINEZ RUBEN. Nombramientos. Consejero: LIZARRIBAR SANS JUAN ANTONIO.Reelecciones. Consejero: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Presidente: SUAREZ VILLA AMADOR. Secretario: SUAREZ GARMENDIAELIAS. Consejero: SUAREZ VILLA AMADOR;PASCUAL SUAREZ MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 595 , F 81, S 8, H H9261, I/A 78 (11.01.18).

18 de Enero de 2018
Revocaciones. Apoderado: CELAYA MARTINEZ RUBEN. Datos registrales. T 595 , F 81, S 8, H H 9261, I/A 76 ( 9.01.18).

06 de Junio de 2017
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL. Datos registrales. T 595 , F 80, S 8, H H 9261, I/A 75 (22.05.17).

22 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: LIZARRIBAR SANS JUAN ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: LIZARRIBAR SANS JUANANTONIO. Datos registrales. T 595 , F 80, S 8, H H 9261, I/A 74 (15.09.16).

15 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT JRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 595 , F 80, S 8, H H 9261, I/A 73 (30.12.15).

04 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: PASCUAL CONDON MANUEL. Consejero: PASCUAL CONDON MANUEL. Nombramientos.Consejero: PASCUAL SUAREZ MANUEL FRANCISCO. Reelecciones. Consejero: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Presidente:SUAREZ VILLA AMADOR. Consejero: CELAYA MARTINEZ RUBEN. Secretario: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Consejero: SUAREZVILLA AMADOR. Datos registrales. T 595 , F 79, S 8, H H 9261, I/A 72 (27.10.15).

30 de Abril de 2015
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT JRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 595 , F 79, S 8, H H 9261, I/A 71 (15.04.15).

14 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: PONCE FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 595 , F 79, S 8, H H 9261, I/A 70 ( 7.05.14).

26 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT JRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 595 , F 79, S 8, H H 9261,H , I/ 70 .(17.12.13).

Otros conceptos: DE CONFORMIDAD CON LA DISP. ADICIONAL CUARTA, p谩rrafo tercero del Apartado 2 de la Ley Concursal,QUEDA DEPOSITADA la SOLICITUD de HOMOLOGACION DE ACUERDO DE REFINANCIACION, de las sociedades "GRUPOAMASUA, S.A" y "KRUSTAGROUP, S.L.U.", admitida a tr谩mite por el JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA. Datos registrales. T 595, F 79, S 8, H H 9261,H , I/ 70 .D.)18212313.

23 de Enero de 2013
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT JRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 595 , F 78, S 8, H H 9261,H , I/ 68 .( 4.01.13).

10 de Febrero de 2012
Reelecciones. Consejero: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Presidente: SUAREZ VILLA AMADOR. Vicepresid.: PASCUAL CONDONMANUEL. Consejero: CELAYA MARTINEZ RUBEN. Secretario: SUAREZ GARMENDIA ELIAS. Consejero: SUAREZ VILLAAMADOR;PASCUAL CONDON MANUEL. Datos registrales. T 595 , F 78, S 8, H H 9261,H , I/ 67 .(27.01.12).

27 de Enero de 2012
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT JRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 595 , F 77, S 8, H H 9261,H , I/ 66 .(16.01.12).

24 de Enero de 2011
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT JRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 595 , F 77, S 8, H H 9261,H , I/ 65 .( 3.01.11).

26 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apoderado: MUGICA MENDIZABAL JOSE MANUEL;PASCUAL CONDON JESUS SALVADOR. Datos registrales. T595 , F 76, S 8, H H 9261,H , I/ 62 .(16.02.10).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.000.420,71 Euros. Desembolsado: 5.000.420,71 Euros. Resultante Suscrito: 11.010.541,75 Euros.Resultante Desembolsado: 11.010.541,75 Euros. Datos registrales. T 595 , F 76, S 8, H H 9261,H , I/ 63 .(16.02.10).

Cambio de domicilio social. C/ ALONSO DE OJEDA 11 (HUELVA). Datos registrales. T 595 , F 77, S 8, H H 9261,H , I/ 64.(16.02.10).

21 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT JRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 595 , F 76, S 8, H H 9261,H , I/ 61 .( 3.12.09).

07 de Diciembre de 2009
Revocaciones. Apoderado: SANAHUJA MARTIN MARIANO. Datos registrales. T 595 , F 76, S 8, H H 9261,H , I/ 60 .(23.11.09).

16 de Junio de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: SERRANO CABALLERO MARIA JOSE;ECHEVERRIA MENDIZABAL IGNACIO. Nombramientos.Apoderado: ECHEVERRIA MENDIZABAL IGNACIO. Datos registrales. T 595 , F 75, S 8, H H 9261,H , I/ 58 .( 1.06.09).

Nombramientos. Apoderado: MUGICA NARVAIZA PABLO. Datos registrales. T 595 , F 75, S 8, H H 9261,H , I/ 59 .( 1.06.09).

31 de Marzo de 2009
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: KRUSTASUR SA. Datos registrales. T 595 , F 74, S 8, H H 9261,H , I/ 57.(16.03.09).

02 de Marzo de 2009
Nombramientos. Auditor: UNIAUDIT JRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 595 , F 74, S 8, H H 9261,H , I/ 56 .(31.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n