Buscador CIF Logo

Actos BORME Ksh Galdos Spanish Holdings Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ksh Galdos Spanish Holdings Sl

Actos BORME Ksh Galdos Spanish Holdings Sl - B86407202

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ksh Galdos Spanish Holdings Sl con CIF B86407202

🔙 Perfil de Ksh Galdos Spanish Holdings Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ksh Galdos Spanish Holdings Sl

22 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ VAZQUEZ RAUL-JESUS. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ ENRIQUEZPEDRO. Cambio de domicilio social. AVDA DEL DOCTOR ARCE 14 (MADRID). Datos registrales. T 36236 , F 23, S 8, H M535135, I/A 22 (15.06.23).

Revocaciones. Apo.Manc.: WATERHOUSE ROBERT RICHARD. Apo.Sol.: MUÑOZ SANTIAGO ANTONIO MIGUEL. Apo.Man.Soli:GONZALEZ VAZQUEZ RAUL-JESUS;HOLLOWAY CHRISTOPHER RICHARD. Nombramientos. Apoderado: VELAZQUEZ MILLANHUGO;HOLLOWAY CHRISTOPHER RICHARD;RODRIGUEZ ENRIQUEZ PEDRO;MUÑOZ SANTIAGO ANTONIO MIGUEL. Datosregistrales. T 36236 , F 24, S 8, H M 535135, I/A 23 (15.06.23).

12 de Abril de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GSA SPAIN CORE BIDCO SL. Datos registrales. T 36236 , F 22, S8, H M 535135, I/A 19 ( 5.04.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MITCHELL TIMOTHY WILLIAM. SecreNoConsj: MUÑOZ SANTIAGO ANTONIO MIGUEL.VsecrNoConsj: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ VAZQUEZ RAUL-JESUS.SecreNoConsj: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. VsecrNoConsj: MUÑOZ SANTIAGO ANTONIO MIGUEL. Cambio de domiciliosocial. C/ SANTA ENGRACIA 6, 1º IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 36236 , F 22, S 8, H M 535135, I/A 20 ( 5.04.21).

Revocaciones. Apo.Manc.: MITCHELL TIMOTHY WILLIAM. Datos registrales. T 36236 , F 23, S 8, H M 535135, I/A 21 ( 5.04.21).

05 de Abril de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GSAF MADRID HOLDCO SL. Datos registrales. T 36236 , F 22, S8, H M 535135, I/A 18 (25.03.21).

02 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: MITCHELL TIMOTHY WILLIAM;WATERHOUSE ROBERT RICHARD. Apo.Sol.: MUÑOZ SANTIAGOANTONIO MIGUEL. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VAZQUEZ RAUL-JESUS;HOLLOWAY CHRISTOPHER RICHARD. Datos registrales.T 36236 , F 21, S 8, H M 535135, I/A 17 (25.10.18).

30 de Noviembre de 2017
Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 10 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 36236 , F 21, S 8, H M535135, I/A 16 (22.11.17).

16 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: MITCHELL TIMOTHY WILLIAM. Nombramientos. Presidente: HOLLOWAY CHRISTOPHERRICHARD. Datos registrales. T 36236 , F 21, S 8, H M 535135, I/A 15 ( 6.11.17).

31 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: TAYLOR MATTHEW;STORGAARD THOMAS. Presidente: TAYLOR MATTHEW. Nombramientos.Consejero: WATERHOUSE ROBERT RICHARD;MITCHELL TIMOTHY WILLIAM. Presidente: MITCHELL TIMOTHY WILLIAM. Datosregistrales. T 29743 , F 53, S 8, H M 535135, I/A 13 (23.08.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: MITCHELL TIMOTHY WILLIAM. Datos registrales. T 36236 , F 20, S 8, H M 535135, I/A 1 (23.08.17).

09 de Mayo de 2017
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: KSH NETHERLANDS INTERMEDIATE ONE BV. Datos registrales.T 29743 , F 53, S 8, H M 535135, I/A 12 (28.04.17).

18 de Abril de 2017
Nombramientos. VsecrNoConsj: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Datos registrales. T 29743 , F 53, S 8, H M 535135, I/A 11 (6.04.17).

12 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO;GALLEANI DESIREE-MACARENA. Datos registrales. T 29743 ,F 53, S 8, H M 535135, I/A 10 ( 1.12.16).

27 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEC SZYMON. Presidente: DEC SZYMON. Nombramientos. Consejero: STORGAARD THOMAS.Presidente: TAYLOR MATTHEW. Datos registrales. T 29743 , F 52, S 8, H M 535135, I/A 9 (16.03.15).

24 de Marzo de 2015
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 24. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 29743 , F 52, S 8, H M535135, I/A 8 (13.03.15).

10 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GLOBAL VITARA SL. Representan: GILA LORENZO CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj:MUÑOZ SANTIAGO ANTONIO MIGUEL. Consejero: TAYLOR MATTHEW;DEC SZYMON;HOLLOWAY CHRISTOPHER RICHARD.Presidente: DEC SZYMON. Con.Delegado: HOLLOWAY CHRISTOPHER RICHARD. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 29743 , F 51, S 8, H M 535135, I/A7 ( 2.04.13).

15 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: MUÑOZ SANTIAGO ANTONIO MIGUEL;HOLLOWAY CHRISTOPHER RICHARD. Datos registrales.T 29743 , F 50, S 8, H M 535135, I/A 6 (31.10.12).

06 de Noviembre de 2012
Ampliación de capital. Capital: 700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 703.000,00 Euros. Datos registrales. T 29743 , F 49, S 8, HM 535135, I/A 5 (24.10.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información