Buscador CIF Logo

Actos BORME La Cornisa Del Rio Real Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera La Cornisa Del Rio Real Sociedad Anonima

Actos BORME La Cornisa Del Rio Real Sociedad Anonima - A82690496

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para La Cornisa Del Rio Real Sociedad Anonima con CIF A82690496

馃敊 Perfil de La Cornisa Del Rio Real Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de La Cornisa Del Rio Real Sociedad Anonima

06 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ SAINZ MARCO ANTONIO;PEREZ IBA脩EZ CESAR;SIERRA ORTA OSCAR;PASCUALMARTINEZ RICARDO;CASTELLANA ABOGADOS DESPACHO SL. Secretario: SIERRA ORTA OSCAR. Presidente: PASCUALMARTINEZ RICARDO. Consejero: BLAZQUEZ FRANCO VIRGINIA. Representan: CONDE SARO LUIS. Nombramientos.Liquidador: ACTIVOS EN RENTA GRUPO CORPORATIVO SA. Representan: SIERRA ORTA OSCAR. Disoluci贸n. Voluntaria.Extinci贸n. Datos registrales. T 39030 , F 27, S 8, H M 259594, I/A 25 (29.09.20).

14 de Enero de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.491.285,89 Euros. Resultante Suscrito: 63.299,46 Euros. Datos registrales. T 39030 , F26, S 8, H M 259594, I/A 24 ( 3.01.20).

06 de Mayo de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 388.839,54 Euros. Resultante Suscrito: 2.554.585,35 Euros. Datos registrales. T 39030 ,F 25, S 8, H M 259594, I/A 23 (25.04.19).

24 de Diciembre de 2018
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 81 6潞 - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 15452 , F 220, S 8, H M 259594, I/A22 (13.12.18).

05 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Consejero: BLAZQUEZ FRANCO VIRGINIA. Reelecciones. Consejero: HERNANDEZ SAINZ MARCOANTONIO;PEREZ IBA脩EZ CESAR;SIERRA ORTA OSCAR;PASCUAL MARTINEZ RICARDO;CASTELLANA ABOGADOSDESPACHO SL. Secretario: SIERRA ORTA OSCAR. Presidente: PASCUAL MARTINEZ RICARDO. Datos registrales. T 15452 , F220, S 8, H M 259594, I/A 21 (29.08.18).

20 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: BLAZQUEZ ORODEA LUIS. Apo.Manc.: BLAZQUEZ ORODEA LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.:BLAZQUEZ FRANCO VIRGINIA. Datos registrales. T 15452 , F 219, S 8, H M 259594, I/A 20 (13.04.18).

13 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: BLAZQUEZ ORODEA LUIS. Presidente: BLAZQUEZ ORODEA LUIS. Nombramientos. Presidente:PASCUAL MARTINEZ RICARDO. Datos registrales. T 15452 , F 218, S 8, H M 259594, I/A 19 ( 2.06.17).

16 de Octubre de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.577.965,11 Euros. Resultante Suscrito: 2.943.424,89 Euros. Datos registrales. T 15452, F 217, S 8, H M 259594, I/A 18 ( 7.10.15).

30 de Junio de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: BLAZQUEZ ORODEA LUIS;PASCUAL MARTINEZ RICARDO;HERNANDEZ SAINZ MARCOANTONIO;CONDE SARO LUIS;SIERRA ORTA OSCAR. Datos registrales. T 15452 , F 216, S 8, H M 259594, I/A 17 (22.06.15).

09 de Enero de 2015
Cambio de domicilio social. PLAZA DE LAS SALESAS 11 1潞 - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 15452 , F 216, S 8, H M259594, I/A 16 (30.12.14).

26 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTELLANA ABOGADOS DESPACHO SL. Secretario: CASTELLANA ABOGADOS DESPACHOSL. Consejero: HERNANDEZ SAINZ MARCO ANTONIO;BLAZQUEZ ORODEA LUIS MIGUEL;PEREZ IBA脩EZ CESAR.Cons.Del.Man: BLAZQUEZ ORODEA LUIS MIGUEL;PEREZ IBA脩EZ CESAR. Presidente: BLAZQUEZ ORODEA LUIS MIGUEL.Nombramientos. Consejero: BLAZQUEZ ORODEA LUIS;HERNANDEZ SAINZ MARCO ANTONIO;PEREZ IBA脩EZ CESAR;SIERRAORTA OSCAR;PASCUAL MARTINEZ RICARDO;CASTELLANA ABOGADOS DESPACHO SL. Secretario: SIERRA ORTA OSCAR.Presidente: BLAZQUEZ ORODEA LUIS. Datos registrales. T 15452 , F 215, S 8, H M 259594, I/A 15 (18.09.13).

20 de Junio de 2011
Reelecciones. Consejero: BLAZQUEZ ORODEA LUIS MIGUEL;PEREZ IBA脩EZ CESAR. Cons.Del.Man: BLAZQUEZ ORODEA LUISMIGUEL;PEREZ IBA脩EZ CESAR. Presidente: BLAZQUEZ ORODEA LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 15452 , F 110, S 8, H M259594, I/A 14 ( 8.06.11).

29 de Enero de 2010
Nombramientos. Consejero: CASTELLANA ABOGADOS DESPACHO SL. Secretario: CASTELLANA ABOGADOS DESPACHO SL.Consejero: HERNANDEZ SAINZ MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 15452 , F 110, S 8, H M 259594, I/A 13 (19.01.10).

08 de Enero de 2010
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: HERNANDEZ BAJO JOSE LUIS ANGEL. Consejero: HERNANDEZ BAJO JOSE LUIS ANGEL.Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ SAINZ MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 15452 , F 109, S 8, H M 259594, I/A 12(28.12.09).

27 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Presidente: SANCHEZ RICO BRUNET JOSE ANTONIO. Consejero: SANCHEZ RICO BRUNET JOSE ANTONIO.Cons.Del.Man: SANCHEZ RICO BRUNET JOSE ANTONIO. Secretario: BLAZQUEZ ORODEA LUIS MIGUEL. Nombramientos.Consejero: CASTELLANA ABOGADOS DESPACHO SL. Representan: CONDE SARO LUIS. Presidente: BLAZQUEZ ORODEA LUISMIGUEL. Secretario: CASTELLANA ABOGADOS DESPACHO SL. Datos registrales. T 15452 , F 109, S 8, H M 259594, I/A 11(15.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n