Actos BORME de La Palentina Sa
25 de Enero de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 484 , F 94, S 8, H P 179, I/A 83 (19.01.23).
18 de Octubre de 2022Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD POR EL PLAZO DE SEIS MESES, PORABSORCION POR " HARINERA LA META SA" ( Mercantil de Barcelona", de conformidad con el art潞 231 del Reglamento del RegistroMercantil. Datos registrales. T 484 , F 94, S 8, H P 179, I/A N (10.10.22).
23 de Diciembre de 2021Nombramientos. Auditor: RSM SPAIN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 484 , F 94, S 8, H P 179, I/A 82 (16.12.21).
12 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ DIEZ VANESSA. Datos registrales. T 484 , F 94, S 8, H P 179, I/A 81 ( 4.08.20).
15 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: SUMMA INVESTMENTS SOLUTIONS SA. Datos registrales. T 484 , F 93, S 8, H P 179, I/A 80 (9.07.20).
22 de Abril de 2020Reelecciones. Consejero: BALAGUE SERRA JOSEP MARIA;PEDROS RIASOL JOSEP;ARNAU RIUS SEBASTIA. Presidente:BALAGUE SERRA JOSEP MARIA. Con.Delegado: BALAGUE SERRA JOSEP MARIA. SecreNoConsj: REBES GONZALEZ NANDINBONAVENTURA. Datos registrales. T 484 , F 92, S 8, H P 179, I/A 79 (16.04.20).
29 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ROS BLANCO ANGEL;ROS BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 484 , F 92, S 8, H P 179, I/A 78(22.05.19).
10 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ BRISO JOSE JULIO;FERNANDEZ POLO IVAN. Datos registrales. T 484 , F 91, S 8, H P179, I/A 76 ( 3.04.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ POLO IVAN. Datos registrales. T 484 , F 91, S 8, H P 179, I/A 77 ( 3.04.19).
02 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: IMAFIEL AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 484 , F 91, S 8, H P 179, I/A 75 (26.10.18).
07 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CHIA FORRADELLAS CARMINA. Datos registrales. T 411 , F 69, S 8, H P 179, I/A 74 (31.01.18).
15 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ROS BLANCO ANGEL;ROS BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 411 , F 69, S 8, H P 179, I/A 73 (2.12.16).
25 de Noviembre de 2015Reelecciones. Auditor: IMAFIEL AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 411 , F 69, S 8, H P 179, I/A 72 (17.11.15).
25 de Agosto de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HARINERA TALAVERANA 2006 SL. Datos registrales. T 411 , F 68, S 8, H P 179,I/A 71 (18.08.15).
23 de Diciembre de 2014Reelecciones. Consejero: BALAGUE SERRA JOSEP MARIA;PEDROS RIASOL JOSEP;ARNAU RIUS SEBASTIA. Presidente:BALAGUE SERRA JOSEP MARIA. Con.Delegado: BALAGUE SERRA JOSEP MARIA. SecreNoConsj: REBES GONZALEZ NANDINBONAVENTURA. Otros conceptos: ARTICULO 9. DURACION DE CARGO.Los miembros del consejo de administraci贸ndesempe帽ar谩n su cargo por un plazo de seis a帽os, sin perjuicio de su reelecci贸n, as铆 como de la facultad de la junta General deproceder en cualquier tiempo y momento a la destituci贸n de los mismos de conformidad a lo. Datos registrales. T 411 , F 44, S 8, H P179, I/A 70 (15.12.14).
26 de Febrero de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.047.042,06 Euros. Resultante Suscrito: 1.428.132,26 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 2.057.667,74 Euros. Desembolsado: 2.057.667,74 Euros. Resultante Suscrito: 3.485.800,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 3.485.800,00 Euros. Datos registrales. T 411 , F 43, S 8, H P 179, I/A 69 (18.02.13).
16 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: PEDROS RIASOL JOSEP. Nombramientos. Presidente: BALAGUE SERRA JOSE MARIA.Apo.Sol.: PEDROS RIASOL JOSEP. Datos registrales. T 411 , F 42, S 8, H P 179, I/A 68 ( 6.11.12).
31 de Octubre de 2012Nombramientos. Auditor: IMAFIEL AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 411 , F 42, S 8, H P 179, I/A 67 (22.10.12).
24 de Agosto de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.299.996,95 Euros. Desembolsado: 2.299.996,95 Euros. Resultante Suscrito: 3.475.174,32 Euros.Resultante Desembolsado: 3.475.174,32 Euros. Datos registrales. T 411 , F 41, S 8, H P 179, I/A 66 (12.08.11).
12 de Enero de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: HARINERA LA META SA. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: LA AVEJU SL. Datos registrales. T 411 , F 41, S 8, H P 179, I/A 65 (31.12.10).
01 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: VELASCO CRESPO ENRIQUE;JUNCO ALMODOVAR MANUEL;ARROYO ORDO脩EZ JESUSJERONIMO. Presidente: ARROYO ORDO脩EZ JESUS JERONIMO. Cons.Del.Sol: ARROYO ORDO脩EZ JESUS JERONIMO.Consejero: LASTRA MARCOS IGNACIO JESUS. Secretario: VELASCO CALDERON BERNARDO. Cons.Del.Sol: VELASCOCALDERON BERNARDO. Consejero: VELASCO CALDERON BERNARDO. Auditor: JCS ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORESSA. Nombramientos. Consejero: PEDROS RIASOL JOSEP;BALAGUE SERRA JOSE MARIA;ARNAU RIUS SEBASTIA. Presidente:PEDROS RIASOL JOSEP. SecreNoConsj: REBES GONZALEZ NANDIN BONAVENTURA. Con.Delegado: BALAGUE SERRA JOSEMARIA. Auditor: PONT MESTRES AUDITORES ASOCIADOS SA. Otros conceptos: Refundici贸n total de todos los estatutossociales. Datos registrales. T 411 , F 40, S 8, H P 179, I/A 64 (20.11.09).
27 de Marzo de 2009Nombramientos. Auditor: JCS ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES SA. Datos registrales. T 411 , F 39, S 8, H P 179, I/A 63(18.03.09).