Buscador CIF Logo

Actos BORME La Palette Rouge Iberica Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera La Palette Rouge Iberica Sa

Actos BORME La Palette Rouge Iberica Sa - A82208828

Tenemos registrados 45 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para La Palette Rouge Iberica Sa con CIF A82208828

馃敊 Perfil de La Palette Rouge Iberica Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de La Palette Rouge Iberica Sa

22 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: GOUBE XAVIER GASTON MARIE;ROLLAND FRANCOIS;GOUBE XAVIER GASTON MARIE. Datosregistrales. T 36199 , F 23, S 8, H M 235181, I/A 92 (12.05.23).

01 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: VILLA BLANDON RICARDO. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ HERNANDEZ FRANCISCO.Datos registrales. T 36199 , F 22, S 8, H M 235181, I/A 91 (22.02.23).

13 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36199 , F 22, S 8, H M 235181, I/A 90 ( 2.12.21).

11 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: GOUBE XAVIER GASTON MARIE. Datos registrales. T 36199 , F 22, S 8, H M 235181, I/A 89 ( 4.10.21).

22 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apoderado: ROLLAND FRANCOIS;BACHMAN JOHANNES CORNELIS LEONARDUS MARIA. Datos registrales. T36199 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 88 (14.03.21).

16 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apoderado: VIVERO GONZALEZ MARIA;ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS;ROQUERO GARCIA CASALCARLOS. Apo.Manc.: PEREZ FERNANDEZ FERNANDO. Apo.Sol.: ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS;VIVERO GONZALEZMARIA DE LOS ANGELES. Apoderado: PEREZ FERNANDEZ FERNANDO. Apo.Sol.: ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS;VIVEROGONZALEZ MARIA. Apo.Manc.: PEREZ FERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 36199 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 87 (8.10.20).

19 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE. Datos registrales. T 36199 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 86(12.02.20).

22 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SCHERINGA GERT JOHAN. Nombramientos. Adm. Unico: DOMINGUEZ HERRERA JAVIER.Datos registrales. T 36199 , F 20, S 8, H M 235181, I/A 85 (15.10.19).

09 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: VALGA脩ON DOMINGUEZ ALVARO ANTONIO;VALGA脩ON VILLANUEVA ALVARO;CARAZOGONZALEZ LUCIANO. Datos registrales. T 36199 , F 20, S 8, H M 235181, I/A 84 ( 2.09.19).

18 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: REMANE AMADEU ANIFO ABDUL;REMANE AMADEU ANIFO ABDUL;REMANE AMADEU ANIFOABDUL;REMANE AMADEU ANIFO ABDUL. Datos registrales. T 36199 , F 20, S 8, H M 235181, I/A 83 (11.06.19).

04 de Junio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: DOMINGUEZ HERRERA JAVIER. Datos registrales. T 36199 , F 18, S 8, H M 235181, I/A 82(28.05.19).

28 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: BACHMAN JOHANNES CORNELIS LEONARDUS MARIA. Datos registrales. T 36199 , F 16, S 8, HM 235181, I/A 81 (21.03.19).

15 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: REDONDO BARDERA ALICIA. Apo.Manc.: CARABE ALVAREZ GERMAN. Nombramientos. Apo.Sol.:GOUBE XAVIER GASTON MARIE;GOMEZ TOLEDANO VERONICA. Datos registrales. T 36199 , F 13, S 8, H M 235181, I/A 80 (8.03.19).

01 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CARABE ALVAREZ GERMAN;SCHERINGA GERT JOHAN. Nombramientos. Adm. Unico:SCHERINGA GERT JOHAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 36199 , F 13, S 8, H M 235181, I/A 79 (22.02.19).

11 de Diciembre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36199 , F 13, S 8, H M 235181, I/A 78 ( 3.12.18).

28 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: BENAZZO FABIO. Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 74, seg煤n acuerdo de 21 de juniode 2017, se revocan los poderes a favor de don Fabio Benazzo otorgados ante el notario de Madrid, don Segismundo Alvarez RolloVillanova, el d铆a 6 de marzo de 2013, protocolo 900, que caus贸 la inscripci贸n 58陋. Datos registrales. T 36199 , F 13, S 8, H M235181, I/A 77 (19.12.17).

20 de Septiembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: CAMPOS VILELA LUIS ANTONIO. Otros conceptos: Trasladado el domicilio de la sucursal enPortugal, a partir del 1 de septiembre de 2017, a la Avenida D.Joao II.Lote 1.07.2.1. 1潞 piso, Ala B - Parque das NaCoes-1998-014Lisboa (Portugal). Datos registrales. T 36199 , F 12, S 8, H M 235181, I/A 75 ( 8.09.17).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MOLINA CORTES ALVARO. Apo.Manc.: MOLINA CORTES ALVARO. Apoderado: MOLINA CORTESALVARO. Apo.Manc.: MOLINA CORTES ALVARO. Datos registrales. T 36199 , F 12, S 8, H M 235181, I/A 76 ( 8.09.17).

24 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apoderado: BENAZZO FABIO. Nombramientos. Apoderado: BENAZZO FABIO;ROLLAND FRANCOIS;GOUBEXAVIER GASTON MARIE;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE. Datos registrales. T 28302 , F 29, S 8, H M 235181, I/A 74 ( 8.08.17).

24 de Marzo de 2017
Cambio de domicilio social. AVDA ARROYO DEL SANTO, NUMERO 4-6, 3陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 28302 , F28, S 8, H M 235181, I/A 73 (15.03.17).

28 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ TOLEDANO VERONICA. Apo.Manc.: CARABE ALVAREZ GERMAN;MOLINA CORTESALVARO;PEREZ FERNANDEZ FERNANDO;MANZANERO RUIZ ROBERTO. Datos registrales. T 28302 , F 28, S 8, H M 235181,I/A 72 (19.12.16).

24 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: ROENIGER SERVIN PAUL. Apo.Sol.: RUBIO BELLOD CARMEN. Apoderado: BALLESTER PEREZ DECASTRO EVA;ROENIGER SERVIN PAUL. Apo.Sol.: ROENIGER SERVIN PAUL;RUBIO BELLOD CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: MANZANERO RUIZ ROBERTO. Datos registrales. T 28302 , F 27, S 8, H M 235181, I/A 71 (16.11.16).

23 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: REMANE AMADEU ANIFO ABDUL;CARABE ALVAREZ GERMAN;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE.Con.Delegado: CARABE ALVAREZ GERMAN. Cons.Del.Sol: SCHERINGA GERT JOHAN. Presidente: SCHERINGA GERT JOHAN.Consejero: SCHERINGA GERT JOHAN. Secretario: ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS. VsecrNoConsj: VIVERO GONZALEZMARIA. Nombramientos. Adm. Solid.: CARABE ALVAREZ GERMAN. Auditor: DELOITTE SL. Adm. Solid.: SCHERINGA GERTJOHAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datosregistrales. T 28302 , F 26, S 8, H M 235181, I/A 69 (15.12.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS;VIVERO GONZALEZ MARIA;RUBIO BELLOD CARMEN. Datosregistrales. T 28302 , F 27, S 8, H M 235181, I/A 70 (15.12.15).

03 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: DA COSTA DOS SANTOS JOSE JOAQUIN. Nombramientos. Apoderado: REMANE AMADEU ANIFOABDUL;ARRAIANO HENRIQUES ANDREIA CRISTINA;CARVALHO GUERREIRO FLAVIO. Datos registrales. T 28302 , F 25, S 8, HM 235181, I/A 68 (26.10.15).

27 de Noviembre de 2014
Otros conceptos: Cambio de la Sucursal de la Sociedad en Italia. Nueva direcci贸n: Via Mecenate , 90, 20138 , Milano (Italia). Datos

Revocaciones. Rep.SUC.: MULDER FOLKERT WILHELMUS. Nombramientos. Rep.SUC.: SCHERINGA GERT JOHAN. Otrosconceptos: Se hace constar que no se revocan los poderes de don Folkert Wilhemus Mulder, otorgados en virtud de escrituraautorizada por el Notario de Madrid, don Ignacio Manrique Plaza el 2 de diciembre de 2013 con n煤mero de protocolo 3814 por noconstar inscrito .Art 11 RRM. Datos registrales. T 28302 , F 24, S 8, H M 235181, I/A 66 (17.11.14).

24 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Cons.Del.Sol: SCHERINGA GERT JOHAN. Consejero: SCHERINGA GERT JOHAN. Datos registrales. T 28302 ,F 23, S 8, H M 235181, I/A 63 (14.11.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MULDER FOLKER WILHELMUS. Presidente: MULDER FOLKER WILHELMUS. Con.Delegado:

Revocaciones. Rep.SUC.: MULDER FOLKERT WILHELMUS. Nombramientos. Rep.SUC.: SCHERINGA GERT JOHAN. Datosregistrales. T 28302 , F 24, S 8, H M 235181, I/A 65 (14.11.14).

28 de Abril de 2014
Nombramientos. Con.Delegado: CARABE ALVAREZ GERMAN. Datos registrales. T 28302 , F 23, S 8, H M 235181, I/A 62(21.04.14).

19 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. R.L.C.Perma.: FLORENT WILLEMS PETER JAN. Con.Delegado: CARABE ALVAREZ GERMAN. R.L.C.Perma.:CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON;FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON.Revocaciones. Apoderado: FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON;FLORENT WILLEMSPETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Nombramientos. Rep.SUC.: MULDER FOLKERTWILHELMUS;MULDER FOLKERT WILHELMUS. Reelecciones. Consejero: REMANE AMADEU ANIFO ABDUL;CARABE ALVAREZGERMAN;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE. Datos registrales. T 28302 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 61 (11.03.14).

12 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Con.Delegado: CORNELIUS SELLESLAGS LOUISPHILEMON. Consejero: FLORENT WILLEMS PETER JAN. Con.Delegado: FLORENT WILLEMS PETER JAN. Presidente: FLORENTWILLEMS PETER JAN. Nombramientos. Consejero: MULDER FOLKER WILHELMUS. Presidente: MULDER FOLKERWILHELMUS. Con.Delegado: MULDER FOLKER WILHELMUS. Datos registrales. T 28302 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 60 (4.02.14).

12 de Abril de 2013
Revocaciones. Apoderado: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Apo.Manc.: CARABE ALVAREZ GERMAN. Apoderado: CARABEALVAREZ GERMAN;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE;CARABE ALVAREZ GERMAN;ROLLAND FRANCOIS;WOLF TILO TORSTENWIGAND;GOUBE XAVIER GASTON MARIA;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE. Apo.Sol.: CARABE ALVAREZ GERMAN.Nombramientos. Apoderado: GOUBE XAVIER GASTON MARIA;ROLLAND FRANCOIS;GAY FRANCOIS JEANANTOINE;BENAZZO FABIO. Datos registrales. T 28302 , F 20, S 8, H M 235181, I/A 58 ( 4.04.13).

Nombramientos. R.L.C.Perma.: FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Apoderado:FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Datos registrales. T 28302 , F 20, S 8, H M235181, I/A 59 ( 4.04.13).

11 de Abril de 2013
Nombramientos. R.L.C.Perma.: FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Apoderado:FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Datos registrales. T 28302 , F 19, S 8, H M235181, I/A 57 ( 3.04.13).

05 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Consejero: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Nombramientos.Consejero: FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Con.Delegado: FLORENT WILLEMSPETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON;CARABE ALVAREZ GERMAN. Presidente: FLORENT WILLEMS PETERJAN. Datos registrales. T 28302 , F 19, S 8, H M 235181, I/A 56 (26.03.13).

27 de Marzo de 2013
Modificaciones estatutarias. Creado el articulo 5 bis y modificados los articulos 9, 10,11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 26 y 27 de losEstatutos sociales . Datos registrales. T 28302 , F 17, S 8, H M 235181, I/A 55 (19.03.13).

01 de Marzo de 2013
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28302 , F 17, S 8, H M 235181, I/A 54 (22.02.13).

06 de Febrero de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28302 , F 17, S 8, H M 235181, I/A53 (25.01.12).

23 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: ESPINHO CORSINO DE MATOS CARLOS MANUEL. Apo.Man.Soli: LEMAITRE THIERRY JEANNICOLAS. Datos registrales. T 28302 , F 16, S 8, H M 235181, I/A 51 (11.11.11).

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12.Modificaci贸n Art. 22. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T28302 , F 16, S 8, H M 235181, I/A 52 (11.11.11).

13 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Presidente: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Consejero: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Datos registrales. T28302 , F 16, S 8, H M 235181, I/A 50 (26.08.11).

28 de Abril de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28302 , F 16, S 8, H M 235181, I/A49 (14.04.11).

14 de Diciembre de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARABE ALVAREZ GERMAN. Nombramientos. Apo.Sol.: CARABE ALVAREZ GERMAN. Datosregistrales. T 26156 , F 77, S 8, H M 235181, I/A 48 (29.11.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n