Actos BORME de La Palette Rouge Iberica Sa
22 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: GOUBE XAVIER GASTON MARIE;ROLLAND FRANCOIS;GOUBE XAVIER GASTON MARIE. Datosregistrales. T 36199 , F 23, S 8, H M 235181, I/A 92 (12.05.23).
01 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: VILLA BLANDON RICARDO. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ HERNANDEZ FRANCISCO.Datos registrales. T 36199 , F 22, S 8, H M 235181, I/A 91 (22.02.23).
13 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36199 , F 22, S 8, H M 235181, I/A 90 ( 2.12.21).
11 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GOUBE XAVIER GASTON MARIE. Datos registrales. T 36199 , F 22, S 8, H M 235181, I/A 89 ( 4.10.21).
22 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: ROLLAND FRANCOIS;BACHMAN JOHANNES CORNELIS LEONARDUS MARIA. Datos registrales. T36199 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 88 (14.03.21).
16 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: VIVERO GONZALEZ MARIA;ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS;ROQUERO GARCIA CASALCARLOS. Apo.Manc.: PEREZ FERNANDEZ FERNANDO. Apo.Sol.: ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS;VIVERO GONZALEZMARIA DE LOS ANGELES. Apoderado: PEREZ FERNANDEZ FERNANDO. Apo.Sol.: ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS;VIVEROGONZALEZ MARIA. Apo.Manc.: PEREZ FERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 36199 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 87 (8.10.20).
19 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE. Datos registrales. T 36199 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 86(12.02.20).
22 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SCHERINGA GERT JOHAN. Nombramientos. Adm. Unico: DOMINGUEZ HERRERA JAVIER.Datos registrales. T 36199 , F 20, S 8, H M 235181, I/A 85 (15.10.19).
09 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: VALGA脩ON DOMINGUEZ ALVARO ANTONIO;VALGA脩ON VILLANUEVA ALVARO;CARAZOGONZALEZ LUCIANO. Datos registrales. T 36199 , F 20, S 8, H M 235181, I/A 84 ( 2.09.19).
18 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: REMANE AMADEU ANIFO ABDUL;REMANE AMADEU ANIFO ABDUL;REMANE AMADEU ANIFOABDUL;REMANE AMADEU ANIFO ABDUL. Datos registrales. T 36199 , F 20, S 8, H M 235181, I/A 83 (11.06.19).
04 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: DOMINGUEZ HERRERA JAVIER. Datos registrales. T 36199 , F 18, S 8, H M 235181, I/A 82(28.05.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: BACHMAN JOHANNES CORNELIS LEONARDUS MARIA. Datos registrales. T 36199 , F 16, S 8, HM 235181, I/A 81 (21.03.19).
15 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: REDONDO BARDERA ALICIA. Apo.Manc.: CARABE ALVAREZ GERMAN. Nombramientos. Apo.Sol.:GOUBE XAVIER GASTON MARIE;GOMEZ TOLEDANO VERONICA. Datos registrales. T 36199 , F 13, S 8, H M 235181, I/A 80 (8.03.19).
01 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CARABE ALVAREZ GERMAN;SCHERINGA GERT JOHAN. Nombramientos. Adm. Unico:SCHERINGA GERT JOHAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 36199 , F 13, S 8, H M 235181, I/A 79 (22.02.19).
11 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36199 , F 13, S 8, H M 235181, I/A 78 ( 3.12.18).
28 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: BENAZZO FABIO. Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 74, seg煤n acuerdo de 21 de juniode 2017, se revocan los poderes a favor de don Fabio Benazzo otorgados ante el notario de Madrid, don Segismundo Alvarez RolloVillanova, el d铆a 6 de marzo de 2013, protocolo 900, que caus贸 la inscripci贸n 58陋. Datos registrales. T 36199 , F 13, S 8, H M235181, I/A 77 (19.12.17).
20 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apoderado: CAMPOS VILELA LUIS ANTONIO. Otros conceptos: Trasladado el domicilio de la sucursal enPortugal, a partir del 1 de septiembre de 2017, a la Avenida D.Joao II.Lote 1.07.2.1. 1潞 piso, Ala B - Parque das NaCoes-1998-014Lisboa (Portugal). Datos registrales. T 36199 , F 12, S 8, H M 235181, I/A 75 ( 8.09.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MOLINA CORTES ALVARO. Apo.Manc.: MOLINA CORTES ALVARO. Apoderado: MOLINA CORTESALVARO. Apo.Manc.: MOLINA CORTES ALVARO. Datos registrales. T 36199 , F 12, S 8, H M 235181, I/A 76 ( 8.09.17).
24 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: BENAZZO FABIO. Nombramientos. Apoderado: BENAZZO FABIO;ROLLAND FRANCOIS;GOUBEXAVIER GASTON MARIE;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE. Datos registrales. T 28302 , F 29, S 8, H M 235181, I/A 74 ( 8.08.17).
24 de Marzo de 2017Cambio de domicilio social. AVDA ARROYO DEL SANTO, NUMERO 4-6, 3陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 28302 , F28, S 8, H M 235181, I/A 73 (15.03.17).
28 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ TOLEDANO VERONICA. Apo.Manc.: CARABE ALVAREZ GERMAN;MOLINA CORTESALVARO;PEREZ FERNANDEZ FERNANDO;MANZANERO RUIZ ROBERTO. Datos registrales. T 28302 , F 28, S 8, H M 235181,I/A 72 (19.12.16).
24 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: ROENIGER SERVIN PAUL. Apo.Sol.: RUBIO BELLOD CARMEN. Apoderado: BALLESTER PEREZ DECASTRO EVA;ROENIGER SERVIN PAUL. Apo.Sol.: ROENIGER SERVIN PAUL;RUBIO BELLOD CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: MANZANERO RUIZ ROBERTO. Datos registrales. T 28302 , F 27, S 8, H M 235181, I/A 71 (16.11.16).
23 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: REMANE AMADEU ANIFO ABDUL;CARABE ALVAREZ GERMAN;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE.Con.Delegado: CARABE ALVAREZ GERMAN. Cons.Del.Sol: SCHERINGA GERT JOHAN. Presidente: SCHERINGA GERT JOHAN.Consejero: SCHERINGA GERT JOHAN. Secretario: ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS. VsecrNoConsj: VIVERO GONZALEZMARIA. Nombramientos. Adm. Solid.: CARABE ALVAREZ GERMAN. Auditor: DELOITTE SL. Adm. Solid.: SCHERINGA GERTJOHAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datosregistrales. T 28302 , F 26, S 8, H M 235181, I/A 69 (15.12.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS;VIVERO GONZALEZ MARIA;RUBIO BELLOD CARMEN. Datosregistrales. T 28302 , F 27, S 8, H M 235181, I/A 70 (15.12.15).
03 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apoderado: DA COSTA DOS SANTOS JOSE JOAQUIN. Nombramientos. Apoderado: REMANE AMADEU ANIFOABDUL;ARRAIANO HENRIQUES ANDREIA CRISTINA;CARVALHO GUERREIRO FLAVIO. Datos registrales. T 28302 , F 25, S 8, HM 235181, I/A 68 (26.10.15).
27 de Noviembre de 2014Otros conceptos: Cambio de la Sucursal de la Sociedad en Italia. Nueva direcci贸n: Via Mecenate , 90, 20138 , Milano (Italia). Datos
Revocaciones. Rep.SUC.: MULDER FOLKERT WILHELMUS. Nombramientos. Rep.SUC.: SCHERINGA GERT JOHAN. Otrosconceptos: Se hace constar que no se revocan los poderes de don Folkert Wilhemus Mulder, otorgados en virtud de escrituraautorizada por el Notario de Madrid, don Ignacio Manrique Plaza el 2 de diciembre de 2013 con n煤mero de protocolo 3814 por noconstar inscrito .Art 11 RRM. Datos registrales. T 28302 , F 24, S 8, H M 235181, I/A 66 (17.11.14).
24 de Noviembre de 2014Nombramientos. Cons.Del.Sol: SCHERINGA GERT JOHAN. Consejero: SCHERINGA GERT JOHAN. Datos registrales. T 28302 ,F 23, S 8, H M 235181, I/A 63 (14.11.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MULDER FOLKER WILHELMUS. Presidente: MULDER FOLKER WILHELMUS. Con.Delegado:
Revocaciones. Rep.SUC.: MULDER FOLKERT WILHELMUS. Nombramientos. Rep.SUC.: SCHERINGA GERT JOHAN. Datosregistrales. T 28302 , F 24, S 8, H M 235181, I/A 65 (14.11.14).
28 de Abril de 2014Nombramientos. Con.Delegado: CARABE ALVAREZ GERMAN. Datos registrales. T 28302 , F 23, S 8, H M 235181, I/A 62(21.04.14).
19 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. R.L.C.Perma.: FLORENT WILLEMS PETER JAN. Con.Delegado: CARABE ALVAREZ GERMAN. R.L.C.Perma.:CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON;FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON.Revocaciones. Apoderado: FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON;FLORENT WILLEMSPETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Nombramientos. Rep.SUC.: MULDER FOLKERTWILHELMUS;MULDER FOLKERT WILHELMUS. Reelecciones. Consejero: REMANE AMADEU ANIFO ABDUL;CARABE ALVAREZGERMAN;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE. Datos registrales. T 28302 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 61 (11.03.14).
12 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Con.Delegado: CORNELIUS SELLESLAGS LOUISPHILEMON. Consejero: FLORENT WILLEMS PETER JAN. Con.Delegado: FLORENT WILLEMS PETER JAN. Presidente: FLORENTWILLEMS PETER JAN. Nombramientos. Consejero: MULDER FOLKER WILHELMUS. Presidente: MULDER FOLKERWILHELMUS. Con.Delegado: MULDER FOLKER WILHELMUS. Datos registrales. T 28302 , F 21, S 8, H M 235181, I/A 60 (4.02.14).
12 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Apo.Manc.: CARABE ALVAREZ GERMAN. Apoderado: CARABEALVAREZ GERMAN;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE;CARABE ALVAREZ GERMAN;ROLLAND FRANCOIS;WOLF TILO TORSTENWIGAND;GOUBE XAVIER GASTON MARIA;GAY FRANCOIS JEAN ANTOINE. Apo.Sol.: CARABE ALVAREZ GERMAN.Nombramientos. Apoderado: GOUBE XAVIER GASTON MARIA;ROLLAND FRANCOIS;GAY FRANCOIS JEANANTOINE;BENAZZO FABIO. Datos registrales. T 28302 , F 20, S 8, H M 235181, I/A 58 ( 4.04.13).
Nombramientos. R.L.C.Perma.: FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Apoderado:FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Datos registrales. T 28302 , F 20, S 8, H M235181, I/A 59 ( 4.04.13).
11 de Abril de 2013Nombramientos. R.L.C.Perma.: FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Apoderado:FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Datos registrales. T 28302 , F 19, S 8, H M235181, I/A 57 ( 3.04.13).
05 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Consejero: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Nombramientos.Consejero: FLORENT WILLEMS PETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON. Con.Delegado: FLORENT WILLEMSPETER JAN;CORNELIUS SELLESLAGS LOUIS PHILEMON;CARABE ALVAREZ GERMAN. Presidente: FLORENT WILLEMS PETERJAN. Datos registrales. T 28302 , F 19, S 8, H M 235181, I/A 56 (26.03.13).
27 de Marzo de 2013Modificaciones estatutarias. Creado el articulo 5 bis y modificados los articulos 9, 10,11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 26 y 27 de losEstatutos sociales . Datos registrales. T 28302 , F 17, S 8, H M 235181, I/A 55 (19.03.13).
01 de Marzo de 2013Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28302 , F 17, S 8, H M 235181, I/A 54 (22.02.13).
06 de Febrero de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28302 , F 17, S 8, H M 235181, I/A53 (25.01.12).
23 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: ESPINHO CORSINO DE MATOS CARLOS MANUEL. Apo.Man.Soli: LEMAITRE THIERRY JEANNICOLAS. Datos registrales. T 28302 , F 16, S 8, H M 235181, I/A 51 (11.11.11).
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12.Modificaci贸n Art. 22. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T28302 , F 16, S 8, H M 235181, I/A 52 (11.11.11).
13 de Septiembre de 2011Reelecciones. Presidente: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Consejero: WOLF TILO TORSTEN WIGAND. Datos registrales. T28302 , F 16, S 8, H M 235181, I/A 50 (26.08.11).
28 de Abril de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28302 , F 16, S 8, H M 235181, I/A49 (14.04.11).
14 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARABE ALVAREZ GERMAN. Nombramientos. Apo.Sol.: CARABE ALVAREZ GERMAN. Datosregistrales. T 26156 , F 77, S 8, H M 235181, I/A 48 (29.11.10).