Actos BORME de La Pontezuela Sl
08 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ GARCIA ALICIA. Datos registrales. T 29298 , F 171, S 8, H M 13726, I/A 41 ( 1.10.20).
05 de Marzo de 2020Cambio de domicilio social. C/ CONDE DE PE脩ALVER 45 6潞 (MADRID). Datos registrales. T 29298 , F 170, S 8, H M 13726, I/A40 (27.02.20).
20 de Diciembre de 2018Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3. MODIFICACION DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 29298 , F 170, S 8, H M 13726, I/A 39 (13.12.18).
09 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: DE PABLO DE LA IGLESIA JESUS. Datos registrales. T 29298 , F 168, S 8, H M 13726, I/A 35(29.09.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: GILA SANCHEZ BARBA PEDRO;HERNANDEZ COBO PATRICIA;DE PABLO DE LA IGLESIA JESUS.Datos registrales. T 29298 , F 168, S 8, H M 13726, I/A 36 (29.09.17).
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ-PINTADO RODRIGUEZ DE SEGOVIA RAQUEL;SANCHEZ GESTIDO MONTSERRAT.Apo.Manc.: VILLA MARTINEZ JOSE LUIS;PE脩A ALONSO ROSA MARIA;GALLO CAMPOS ELENA. Datos registrales. T 29298 , F170, S 8, H M 13726, I/A 37 (29.09.17).
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. C/DOCTOR ESQUERDO 136 (MADRID). Datos registrales. T 29298 , F 170, S 8, H M 13726, I/A 38 (29.09.17).
13 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: VILLA MARTINEZ JOSE LUIS;PE脩A ALONSO ROSA MARIA;CUERVO JUAN ANGEL-LUIS. Datosregistrales. T 29298 , F 167, S 8, H M 13726, I/A 34 (30.11.16).
31 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: VILLA MARTINEZ JOSE LUIS;PE脩A ALONSO ROSA MARIA;GALLO CAMPOS ELENA. Datosregistrales. T 29298 , F 166, S 8, H M 13726, I/A 33 (24.10.16).
26 de Abril de 2016Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Datos registrales. T 29298 , F165, S 8, H M 13726, I/A 32 (18.04.16).
25 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GESTIDO MONTSERRAT. Datos registrales. T 29298 , F 165, S 8, H M 13726, I/A 31(15.04.16).
19 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ COBO PATRICIA. Datos registrales. T 29298 , F 164, S 8, H M 13726, I/A 29 (11.02.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: VILLA MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 29298 , F 164, S 8, H M 13726, I/A 30 (11.02.16).
13 de Noviembre de 2015Cambio de domicilio social. C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW 1 (MADRID). Datos registrales. T 29298 , F 164, S8, H M 13726, I/A 28 ( 3.11.15).
18 de Diciembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 626.049,68 Euros. Resultante Suscrito: 4.679.926,90 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: Art铆culo 5潞. Capital Social. Datos registrales. T 29298 , F 163, S 8, H M 13726, I/A 27 (10.12.14).
07 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: RECIO GARRIDO DAVID. Datos registrales. T 29298 , F 163, S 8, H M 13726, I/A 26 (27.02.14).
03 de Enero de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GOMEZ-PINTADO Y RODRIGUEZ DE SEGOVIA JUAN ANTONIO.Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.084.694,71 Euros. Resultante Suscrito: 4.053.877,22 Euros. Datos registrales. T 29298 , F 162, S8, H M 13726, I/A 25 (20.12.13).
12 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: RECIO GARRIDO DAVID. Datos registrales. T 29298 , F 162, S 8, H M 13726, I/A 24 ( 4.12.13).
24 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: VILLA MARTINEZ JOSE LUIS;PE脩A ALONSO ROSA MARIA;CUERVO JUAN ANGEL-LUIS. Datosregistrales. T 22146 , F 207, S 8, H M 13726, I/A 23 (11.01.12).
18 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GOMEZ-PINTADO FERNANDEZ ATANASIO;GOMEZ PINTADO RODRIGUEZ DE SEGOVIA JUANANTONIO Nombramientos. Adm. Unico: GOMEZ PINTADO RODRIGUEZ DE SEGOVIA JUAN ANTONIO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 22146 ,F 207, S 8, H M 13726, I/A 22 ( 7.11.11).
25 de Enero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 211.395,74 Euros. Resultante Suscrito: 1.969.182,51 Euros. Datos registrales. T 22146 , F 207, S 8,H M 13726, I/A 21 (13.01.11).
19 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: GOMEZ-PINTADO RODRIGUEZ DE SEGOVIA RAQUEL. Datos registrales. T 22146 , F 205, S 8, HM 13726, I/A 20 ( 6.05.10).
19 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ-PINTADO FERNANDEZ ATANASIO. Presidente: GOMEZ-PINTADO FERNANDEZATANASIO. Cons.Del.Sol: GOMEZ-PINTADO FERNANDEZ ATANASIO. Consejero: GOMEZ-PINTADO Y RODRIGUEZ DE SEGOVIAJUAN ANTONIO. Secretario: GOMEZ-PINTADO Y RODRIGUEZ DE SEGOVIA JUAN ANTONIO. Cons.Del.Sol: GOMEZ-PINTADO YRODRIGUEZ DE SEGOVIA JUAN ANTONIO. Consejero: GOMEZ-PINTADO RODRIGUEZ DE SEGOVIA RAQUEL. Vicepresid.:GOMEZ-PINTADO RODRIGUEZ DE SEGOVIA RAQUEL. Cons.Del.Sol: GOMEZ-PINTADO RODRIGUEZ DE SEGOVIA RAQUEL.Nombramientos. Adm. Solid.: GOMEZ-PINTADO FERNANDEZ ATANASIO;GOMEZ PINTADO RODRIGUEZ DE SEGOVIA JUANANTONIO Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradoressolidarios. Datos registrales. T 22146 , F 204, S 8, H M 13726, I/A 19 ( 7.04.10).