Buscador CIF Logo

Actos BORME La Propagadora Del Gas Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera La Propagadora Del Gas Sa

Actos BORME La Propagadora Del Gas Sa - A08000028

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para La Propagadora Del Gas Sa con CIF A08000028

馃敊 Perfil de La Propagadora Del Gas Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de La Propagadora Del Gas Sa

20 de Septiembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: TOTUSAUS CALVE JORDI;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;BARCAS LEWKOWICZ HILA;TOTUSAUSCALVE JORDI;BASOLAS TENA ANTONIO;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;JARDON CAVERO ANA MARIA;JUAN FERRERROSA;TOTUSAUS CALVE JORDI;TREPAT FONT RAMON;BARCAS LEWKOWICZ HILA;MAYOR BELLOSTA MARTA;LOMBARDIAESCUDERO ALMUDENA;GARCIA ESTEBAN JAVIER;VELASCO MIRANDA IRENE;GOMEZ FERRER BALTASAR;VELASCOMIRANDA IRENE. Apo.Sol.: GURPIDE HERMOSILLA MARIA MERCEDES;SOLANA FONTANALS ARIADNA;MORENO CEREZOMONICA.Apo.Man.Soli: HIGUERAS RABADAN MARIA DEL VALLE;LOPEZ CERVERA NOEMI;TOTUSAUS CALVE JORDI.Apoderado: ALCANTARA BRAVO MARIA MACARENA. Datos registrales. T 36627 , F 109, S 8, H M 657096, I/A 19 (13.09.23).

20 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BOADA PORTILLO MARTA. Nombramientos. Adm. Unico: AGUIRRE GONZALEZ JOAQUIN.Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Cambio de objeto social. Participar, financiar yadministrar sociedades. Tomar cantidades a cr茅dito, recibir anticipos o cualquier otra forma de pr茅stamo, cr茅dito, con o sin inter茅s y engeneral realizar cualesquiera transacciones financieras, en concreto permutas financieras, compraventa a plazo, al contado, etc.Datos registrales. T 36627 , F 108, S 8, H M 657096, I/A 18 (13.06.23).

07 de Diciembre de 2021
Cambio de domicilio social. AVDA DE AMERICA 38 (MADRID). Datos registrales. T 36627 , F 108, S 8, H M 657096, I/A 17(29.11.21).

23 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTIZ PERDICES IGNACIO;DIAZ DE TERAN LOPEZ MARIA. Datos registrales. T 36627 , F 107, S 8,H M 657096, I/A 16 (16.09.21).

08 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: ALCANTARA BRAVO MARIA MACARENA. Datos registrales. T 36627 , F 107, S 8, H M 657096, I/A15 ( 1.06.21).

13 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARCO NOAIN MARIA CRISTINA. Nombramientos. Adm. Unico: BOADA PORTILLO MARTA.Datos registrales. T 36627 , F 107, S 8, H M 657096, I/A 14 ( 5.11.20).

16 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER;GOMEZ FEBREL BALTASAR;BERENGUER MARSALENRIQUE;MARTINEZ CASTRO SERGIO CARLOS;TREPAT FONT RAMON;JUAN FERRER ROSA;FERNANDEZ ROSELLOEVA;BARCAS LEWKOWICZ DANIELA HILA;TOTUSAUS CALVE JORDI;VELASCO MIRANDA IRENE;PRIETO CORRALESTERESA;PIQUEMAL JEROME GEORGES LOUIS;LOPEZ CERVERA NOEMI;MARCOS MU脩OZ NURIA;LOPEZ GOMEZ-CAROJULIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ FERNANDEZ STEVEN;GANUZA FERNANDEZ DE ARROYABEJON;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;BARCAS LEWKOWICZ HILA;DESEFF RODRIGUEZ GABRIEL ALEJANDRO;HIGUERASRABADAN MARIA DEL VALLE;TREPAT FONT RAMON;GOMEZ FEBREL BALTASAR;JUAN FERRER ROSA;PIQUEMAL JEROMEGEORGES LOUIS;VELASCO MIRANDA IRENE;PRIETO CORRALES TERESA;LOPEZ CERVERA NOEMI;MARCOS MU脩OZNURIA;LOPEZ GOMEZ-CARO JULIO;TOTUSAUS CALVE JORDI. Datos registrales. T 36627 , F 106, S 8, H M 657096, I/A 13 (8.10.20).

05 de Junio de 2020
Revocaciones. Apoderado: FELIP FONT JOAN;FELIP FONT JOAN;FELIP FONT JOAN;RIVERO ARANDA JUAN JOSE;FLOREZASTORGA JAVIER. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL;PERIS CAMINERO ANA MARIA;PRIETO MONTERRUBIOELOY;LEMA CIRONE GABRIEL;MARCO NOAIN MARIA CRISTINA. Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZCARLOS JAVIER;GOMEZ FEBREL BALTASAR;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;MARTINEZ CASTRO SERGIO CARLOS;TREPATFONT RAMON;JUAN FERRER ROSA;FERNANDEZ ROSELLO EVA;BARCAS LEWKOWICZ DANIELA HILA;TOTUSAUS CALVEJORDI;VELASCO MIRANDA IRENE;PRIETO CORRALES TERESA;PIQUEMAL JEROME GEORGES LOUIS;LOPEZ CERVERANOEMI;MARCOS MU脩OZ NURIA;LOPEZ GOMEZ-CARO JULIO. Datos registrales. T 36627 , F 105, S 8, H M 657096, I/A 12(29.05.20).

20 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL;PERIS CAMINERO ANA MARIA;PRIETO MONTERRUBIOELOY;LEMA CIRONE GABRIEL;MARCO NOAIN MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 36627 , F 104, S 8, H M 657096, I/A 11(13.03.20).

04 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: EGEA KRAUEL JOSE MARIA;PE脩ARRUBIA SANCHEZ SALVADOR. Datos registrales. T 36627 , F104, S 8, H M 657096, I/A 10 (25.10.19).

02 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: MARCO NOAIN MARIACRISTINA. Datos registrales. T 36627 , F 104, S 8, H M 657096, I/A 9 (26.07.19).

12 de Septiembre de 2018
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Objeto social.-. REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..Cambio de objeto social. 1 .- La producci贸n, la distribuci贸n y el suministro del alumbrado, calefacci贸n y fuerza motriz por el gas uotros medios. 2 . - La fabricaci贸n, venta, alquiler y reparaci贸n de los aparatos y utensilios destinados a fomentar el consumo del gas. 3.- La preparaci贸n y realizaci贸n de estudios de car谩ct. Datos registrales. T 36627 , F 101, S 8, H M 657096, I/A 8 ( 4.09.18).

03 de Agosto de 2018
Revocaciones. Apoderado: MENENDEZ FERNANDEZ JAUME. Datos registrales. T 36627 , F 101, S 8, H M 657096, I/A 7(27.07.18).

23 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apoderado: FLOREZ ASTORGA JAVIER. Datos registrales. T 36627 , F 101, S 8, H M 657096, I/A 6 (15.03.18).

16 de Febrero de 2018
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 36627 , F 100, S 8, H M 657096, I/A 5 ( 9.02.18).

08 de Enero de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ FEBREL BALTASAR;MARCOS MU脩OZ NURIA;PARRA ROMERO MARIA-INMACULADA.Datos registrales. T 36627 , F 99, S 8, H M 657096, I/A 4 (28.12.17).

05 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: JUAN FERRER ROSA. Datos registrales. T 36627 , F 99, S 8, H M 657096, I/A 3 (27.12.17).

23 de Noviembre de 2017
Cambio de domicilio social. AVDA DE SAN LUIS 77 (MADRID). Datos registrales. T 36627 , F 99, S 8, H M 657096, I/A 2

17 de Julio de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 37699 , F 70, S 8, H B58088, I/A 85 ( 7.07.17).

18 de Julio de 2016
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 37699 , F68, S 8, H B 58088, I/A 84 ( 8.07.16).

07 de Octubre de 2015
Nombramientos. ADM.UNICO: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 37699 , F 68, S 8, H B 58088, I/A83 (29.09.15).

04 de Mayo de 2015
Revocaciones. APODERADO: GALLART GABAS ANTONIO. Datos registrales. T 37699 , F 68, S 8, H B 58088, I/A 81 (24.04.15).

Nombramientos. APODERAD.SOL: MORENO CEREZO MONICA;MARTINEZ GARCIA SUSANA. Datos registrales. T 37699 , F68, S 8, H B 58088, I/A 82 (24.04.15).

09 de Febrero de 2015
Nombramientos. APODERAD.SOL: GURPIDE HERMOSILLA MARIA MERCEDES;SOLANA FONTANALS ARIADNA. Datosregistrales. T 37699 , F 67, S 8, H B 58088, I/A 80 (30.01.15).

09 de Enero de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 37699 , F 67, S 8, H B58088, I/A 79 (30.12.14).

07 de Diciembre de 2012
Nombramientos. APODERADO: VELASCO MIRANDA IRENE. Datos registrales. T 37699 , F 67, S 8, H B 58088, I/A 78 (27.11.12).

17 de Agosto de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 9.723.480,00 Euros. Desembolsado: 9.723.480,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.880.000,00 Euros.

15 de Abril de 2011
Nombramientos. APODERADO: MENENDEZ FERNANDEZ JAUME;GOMEZ FEBREL BALTASAR. Datos registrales. T 37699 , F66, S 8, H B 58088, I/A 76 ( 6.04.11).

18 de Marzo de 2011
Revocaciones. APODERADO: YBERN ARTOLA PEDRO. Datos registrales. T 37699 , F 65, S 8, H B 58088, I/A 75 ( 8.03.11).

21 de Junio de 2010
Nombramientos. ADM.UNICO: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 37699 , F 65, S 8, H B 58088, I/A74 ( 9.06.10).

04 de Enero de 2010
Nombramientos. APODERADO: GALLART GABAS ANTONIO;EGEA KRAUEL JOSE MARIA;FELIP FONT JOAN;BERENGUERMARSAL ENRIQUE;JARDON CAVERO ANA MARIA;PE脩ARRUBIA SANCHEZ SALVADOR;GALAN GANCHEGUI JOSE LUIS;JUANFERRER ROSA;RIVERO ARANDA JUAN JOSE;TOTUSAUS CALVE JORDI;TREPAT FONT RAMON;BARCAS LEWKOWICZHILA;MAYOR BELLOSTA MARTA;LOMBARDIA ESCUDERO ALMUDENA;GARCIA ESTEBAN JAVIER;VELASCO MIRANDA IRENE.Datos registrales. T 37699 , F 64, S 8, H B 58088, I/A 73 (22.12.09).

27 de Noviembre de 2009
Nombramientos. APODERADO: BASOLAS TENA ANTONIO. Datos registrales. T 37699 , F 63, S 8, H B 58088, I/A 72 (18.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n