Actos BORME de La Sagra Brew Sl
18 de Diciembre de 2023Cambio de denominaci贸n social. MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY SPAIN SL. Datos registrales. T 1772 , F 38, S 8, HTO 37894, I/A 23 (11.12.23).
13 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA SANCHEZ CARLOS;OSCAR GARCIA SANCHEZ. Presidente: OSCAR GARCIA SANCHEZ.Con.Delegado: GARCIA SANCHEZ CARLOS. Nombramientos. Presidente: ROGER SIMO GARCIA. Consejero: IGNACIO YUSTY
10 de Noviembre de 2023Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: LA SAGRA MC SL. Datos registrales. T 1684 , F 36, S 8, H TO 37894, I/A21 ( 2.11.23).
22 de Marzo de 2023Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1684 , F 36, S 8, H TO 37894,I/A 19 (14.03.23).
05 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: MCFARLAND RYAN ANDREW. Nombramientos. Consejero: LEE LAURA KATHERINE. Datosregistrales. T 1684 , F 36, S 8, H TO 37894, I/A 18 (28.06.22).
16 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: RILEY ANITA MARY. Vicepresid.: RILEY ANITA MARY. Nombramientos. Consejero: MCFARLANDRYAN ANDREW. Datos registrales. T 1684 , F 15, S 8, H TO 37894, I/A 17 ( 6.11.20).
03 de Diciembre de 2019Cambio de objeto social. CNAE 1105. Explotaci贸n, por cuenta propia o ajena de bares, cafeter铆as, pubs, restaurantes y toda clasede establecimientos dedicados al ramo de la hosteler铆a. Cesi贸n del derecho explotaci贸n de bienes y servicios de la Sociedad a tercerospara comercializar y vender sus productos, y otros. Datos registrales. T 1684 , F 34, S 8, H TO 37894, I/A 15 (26.11.19).
Otros conceptos: Modificadas las facultades del Consejero Delegado. Datos registrales. T 1684 , F 15, S 8, H TO 37894, I/A 16(26.11.19).
08 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ALONSO DREGI RAFAEL. Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ RETUERTA JUANANTONIO. Nombramientos. Apoderado: BREWELL LIAM;BREWELL LIAM. Secretario: YUSTY PAZOS IGNACIO. Datosregistrales. T 1638 , F 207, S 8, H TO 37894, I/A 14 ( 1.04.19).
05 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL OLMO PI脩ERO JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: SIMO GARCIA ROGER. Datosregistrales. T 1638 , F 207, S 8, H TO 37894, I/A 13 (25.06.18).
21 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MORALEDA CONEJO RAMON. Nombramientos. VsecrNoConsj: CA脩ADAS BOUWENANTONIO. Datos registrales. T 1638 , F 207, S 8, H TO 37894, I/A 12 (12.06.18).
12 de Abril de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.320.900,00 Euros. Datos registrales. T 1638 , F 207, S 8,H TO 37894, I/A 11 ( 3.04.18).
28 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL COLOMER ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: DEL OLMO PI脩ERO JOSE MANUEL.Datos registrales. T 1638 , F 207, S 8, H TO 37894, I/A 10 (18.12.17).
16 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: NEBOT MILLET EDUARDO. VsecrNoConsj: SALAR ARCUSA CARMEN. Nombramientos.SecreNoConsj: ALONSO DREGI RAFAEL. VsecrNoConsj: MORALEDA CONEJO RAMON. Datos registrales. T 1638 , F 206, S 8, HTO 37894, I/A 9 ( 6.11.17).
01 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: VYE BRETT. Vicepresid.: VYE BRETT. Nombramientos. Consejero: RILEY ANITA MARY.Vicepresid.: RILEY ANITA MARY. Datos registrales. T 1638 , F 206, S 8, H TO 37894, I/A 8 (23.05.17).
25 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA SANCHEZ CARLOS. Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ OSCAR;GARCIARODRIGUEZ DAVID;GARCIA SANCHEZ SERGIO;GARCIA SANCHEZ DAVID. Nombramientos. Consejero: GARCIA SANCHEZCARLOS;GARCIA SANCHEZ OSCAR;GIL COLOMER ENRIQUE;VYE BRETT. Presidente: GARCIA SANCHEZ OSCAR. Vicepresid.:VYE BRETT. SecreNoConsj: NEBOT MILLET EDUARDO. VsecrNoConsj: SALAR ARCUSA CARMEN. Ampliaci贸n de capital.Capital: 180.900,00 Euros. Resultante Suscrito: 720.900,00 Euros. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Modificaci贸n de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 1617 , F 209, S 8, HTO 37894, I/A 4 (18.04.17).
Nombramientos. Con.Delegado: GARCIA SANCHEZ CARLOS. Datos registrales. T 1638 , F 205, S 8, H TO 37894, I/A 5(18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RETUERTA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1638 , F 205, S 8, H TO 37894, I/A 6(18.04.17).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1638 , F 206, S 8, H TO 37894, I/A 7 (18.04.17).
28 de Abril de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 130.539,00 Euros. Resultante Suscrito: 540.000,00 Euros. Datos registrales. T 1615 , F 87, S 8, HTO 37894, I/A 3 (14.04.16).
29 de Diciembre de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 1.01.16. Objeto social: CNAE1105.compraventa, explotaci贸n, comercio al por mayor,comercio al por menor, almacenamiento, conservaci贸n, importaci贸n, exportaci贸n, crianza, elaboraci贸n, fabricaci贸n, transporte ydistribuci贸n de cualquier producto alimenticio, bebidas alcoh贸licas y no alcoh贸licas, de cualquier graduaci贸n. Domicilio: AVDA DE LAINDUSTRIA - NAVE 155.A POLIGONO INDUST (NUMANCIA DE LA SAGRA). Capital: 409.461,00 Euros. Declaraci贸n deunipersonalidad. Socio 煤nico: DAVIYUN SL. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA SANCHEZ CARLOS. Datos registrales. T1615 , F 82, S 8, H TO 37894, I/A 1 (21.12.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ OSCAR;GARCIA RODRIGUEZ DAVID;GARCIA SANCHEZ SERGIO;GARCIASANCHEZ DAVID. Datos registrales. T 1615 , F 86, S 8, H TO 37894, I/A 2 (21.12.15).