Buscador CIF Logo

Actos BORME La Union Alcoyana Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera La Union Alcoyana Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros

Actos BORME La Union Alcoyana Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros - G03007770

Tenemos registrados 46 Actos BORME del Registro Mercantil de Alicante para La Union Alcoyana Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros con CIF G03007770

馃敊 Perfil de La Union Alcoyana Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alicante

Actos BORME de La Union Alcoyana Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros

26 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM. Apo.Sol.: PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM. Datos registrales. T 4191 , F161, S 8, H A 1365, I/A 134 (17.05.23).

22 de Mayo de 2023
Nombramientos. Con.Ind.: PUCHE DE LA HORRA JOSE GABRIEL. Datos registrales. T 4191 , F 161, S 8, H A 1365, I/A 132(11.05.23).

19 de Mayo de 2023
Reelecciones. Consejero: SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Vicesecret.: SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 4191 , F161, S 8, H A 1365, I/A 131 ( 9.05.23).

13 de Abril de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: RICO FERRER ENRIQUE. Vicepresid.: RICO FERRER ENRIQUE. Datos registrales. T 4191 , F161, S 8, H A 1365, I/A 130 ( 3.04.23).

25 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: LATORRE FONT GUILLERMO. Apo.Sol.: LATORRE FONT GUILLERMO;LATORRE FONTGUILLERMO;LATORRE FONT GUILLERMO;LATORRE FONT GUILLERMO. Datos registrales. T 4191 , F 160, S 8, H A 1365, I/A129 (17.08.22).

16 de Junio de 2022
Reelecciones. Con.Ind.: GRAU GARCIA LEON. Datos registrales. T 4191 , F 160, S 8, H A 1365, I/A 127 ( 8.06.22).

17 de Junio de 2021
Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4191 , F 160, S 8, H A 1365, I/A 125 ( 8.06.21).

31 de Mayo de 2021
Reelecciones. Consejero: MATARREDONA SOLER FRANCISCO JAVIER. Secretario: MATARREDONA SOLER FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 4191 , F 160, S 8, H A 1365, I/A 124 (21.05.21).

01 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: ALENTADO GADEA JORGE. Apo.Sol.: ALENTADO GADEA JORGE;ALENTADO GADEA JORGE.Datos registrales. T 4191 , F 160, S 8, H A 1365, I/A 123 (24.08.20).

27 de Agosto de 2020
Reelecciones. Consejero: ESPINOS PEREZ DESAMPARADOS;RICO FERRER ENRIQUE. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Vicepresid.: RICO FERRER ENRIQUE. Datos registrales. T 4191 , F 159, S 8, HA 1365, I/A 122 (20.08.20).

21 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: ORTEGA COLOMER LEOCADIO. Datos registrales. T 4191 , F 159, S 8, H A 1365, I/A 121(13.08.20).

26 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Apoderado: MARTINEZ BELTRAN RAFAEL;ORTOLA JULIA FRANCISCO JAVIER;ALENTADO GADEAJORGE;CRESPO SALOM PASCUAL JAVIER. Datos registrales. T 4191 , F 159, S 8, H A 1365, I/A 120 (18.11.19).

22 de Noviembre de 2019
Fe de erratas: Error en el segundo apellido del apoderado nombrado en la inscripci贸n 89陋, siendo su identidad correcta: MORCILLOMORCILO, JUAN CARLOS, con NIF 21653487E Error en el segundo apellido del apoderado nombrado en la inscripci贸n 89陋, siendo suidentidad correcta GARCIA GARCIA, INOCENCIO con NIF 22997062Y. Datos registrales. T 3397 , F 160, S 8, H A 1365, I/A 89 (4.07.12).

Revocaciones. Apoderado: MONTAVA MOLINA JAIME MANUEL;RICO GRAU JUAN;JORDA LLOPIS FRANCISCO;RICO ALBERTENRIQUE JORGE;HARO GAVILAN RAUL;RICO ALBERT VICENTE;SAEZ AU脩ON BENITO. Apo.Manc.: JORDA LLOPISFRANCISCO;HARO GAVILAN RAUL;GARCIA CALATAYUD VICENTE;RICO ALBERT VICENTE. Apoderado: GARCIA CALATAYUDVICENTE;RICHART PRATS MIGUEL. Apo.Sol.: SEMPERE PASTOR JUAN CARLOS. Apoderado: RICO ALBERT ENRIQUEJORGE;RICO ALBERT ENRIQUE JORGE. Apo.Sol.: RICO ALBERT ENRIQUE JORGE. Apo.Manc.: SILVESTRE GARCIARAFAEL;GRAU MULLOR LEON. Apo.Sol.: MORCILLO MORCILO JUAN CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: RICO ALBERTENRIQUE JORGE. Apo.Manc.: RICO ALBERT VICENTE. Apo.Sol.: RICO ALBERT VICENTE;RICO ALBERT VICENTE;RICO ALBERTVICENTE. Apo.Manc.: LATORRE FONT GUILLERMO. Apo.Sol.: LATORRE FONT GUILLERMO;LATORRE FONTGUILLERMO;LATORRE FONT GUILLERMO;LATORRE FONT GUILLERMO;RICHART PRATS MIGUEL;MIRA RODRIGUEZARACELI. Apo.Manc.: ALENTADO GADEA JORGE. Apo.Sol.: ALENTADO GADEA JORGE;ALENTADO GADEA JORGE. Apo.Manc.:SEGURA GISBERT JORGE. Apo.Sol.: SEGURA GISBERT JORGE;LOPEZ JUAN ROBERTO;FERRER ANDRES GUILLERMO;RICOGRAU JUAN;ABELLAN SORIANO MARIA ANGELES;SEMPERE PASTOR JUAN CARLOS;GARCIA GARCIA INOCENCIO;GARCIACORTELL MARIA TERESA;ESTEVE LLORENS RAUL;NADAL GALIANA MARIA JESUS;LOPEZ JUAN JUAN JOSE;ORTEGACOLOMER LEOCADIO;MORCILLO MORCILO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4191 , F 157, S 8, H A 1365, I/A 119 (15.11.19).

31 de Julio de 2019
Nombramientos. Con.Delegado: RICO ALBERT ENRIQUE JORGE. Datos registrales. T 4191 , F 157, S 8, H A 1365, I/A 118(23.07.19).

30 de Julio de 2019
Nombramientos. Vicepresid.: RICO FERRER ENRIQUE. Datos registrales. T 4191 , F 156, S 8, H A 1365, I/A 117 (22.07.19).

25 de Julio de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4191 , F 156, S 8, H A 1365, I/A116 (17.07.19).

23 de Julio de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4191 , F 156, S 8, H A 1365, I/A115 (15.07.19).

16 de Julio de 2019
Reelecciones. Consejero: MATAIX ARA脩O ANA MARIA. Presidente: MATAIX ARA脩O ANA MARIA. Cons.Ejecuti: RICO ALBERTENRIQUE JORGE. Datos registrales. T 4191 , F 156, S 8, H A 1365, I/A 114 ( 8.07.19).

26 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RICO FERRER ENRIQUE. Con.Ind.: PASCUAL BERNABEU MONICA. Nombramientos.Consejero: RICO ALBERT ENRIQUE JORGE. Otros conceptos: Modificaci贸n de la totalidad de los estatutos sociales. P谩gina webde la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: https://www.unionalcoyana.com. Datos registrales. T 3807 , F 22, S 8, H A1365, I/A 113 (18.02.19).

28 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Vicesecret.: SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Nombramientos.Consejero: SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Vicesecret.: SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 3807 , F 22, S 8, H A1365, I/A 111 (18.05.18).

15 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3807 , F 22, S 8, H A 1365, I/A 110( 6.11.17).

07 de Junio de 2017
Reelecciones. Con.Ind.: GRAU GARCIA LEON. Datos registrales. T 3807 , F 22, S 8, H A 1365, I/A 109 (30.05.17).

03 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GRAU MULLOR LEON. Secretario: GRAU MULLOR LEON. Vicesecret.: MATARREDONA SOLERFRANCISCO JAVIER. Consejero: PASCUAL BERNABEU MONICA;SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Nombramientos. Secretario:MATARREDONA SOLER FRANCISCO JAVIER. Vicesecret.: SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Con.Ind.: GRAU GARCIALEON;PASCUAL BERNABEU MONICA;SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 3807 , F 22, S 8, H A 1365, I/A 108(23.12.16).

09 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3807 , F 21, S 8, H A 1365, I/A 107( 1.09.16).

23 de Mayo de 2016
Nombramientos. Vicepresid.: PASCUAL BERNABEU MONICA. Consejero: PASCUAL BERNABEU MONICA. Reelecciones.Consejero: MATARREDONA SOLER FRANCISCO JAVIER. Vicesecret.: MATARREDONA SOLER FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 3807 , F 21, S 8, H A 1365, I/A 106 (11.05.16).

26 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL ALBERO RAFAEL. Vicepresid.: PASCUAL ALBERO RAFAEL. Nombramientos.Consejero: PASCUAL BERNABEU MONICA. Vicepresid.: PASCUAL BERNABEU MONICA. Datos registrales. T 3807 , F 21, S 8, HA 1365, I/A 105 (18.08.15).

25 de Junio de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3807 , F 21, S 8, H A 1365, I/A 104(17.06.15).

10 de Junio de 2015
Revocaciones. Apoderado: CONCA MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 3807 , F 21, S 8, H A 1365, I/A 103 ( 2.06.15).

05 de Junio de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: RICO ALBERT ENRIQUE JORGE. Apo.Manc.: SILVESTRE GARCIA RAFAEL;GRAU MULLOR LEON.Datos registrales. T 3807 , F 20, S 8, H A 1365, I/A 102 (28.05.15).

22 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RICO FERRER ENRIQUE. Nombramientos. Con.Delegado: RICO FERRER ENRIQUE.Reelecciones. Consejero: ESPINOS PEREZ DESAMPARADOS;RICO FERRER ENRIQUE. Datos registrales. T 3807 , F 20, S 8, HA 1365, I/A 101 (14.05.15).

17 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apoderado: RICO ALBERT ENRIQUE JORGE. Datos registrales. T 3397 , F 162, S 8, H A 1365, I/A 100(10.10.14).

11 de Agosto de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3397 , F 162, S 8, H A 1365, I/A 99( 1.08.14).

02 de Junio de 2014
Reelecciones. Consejero: MATAIX ARA脩O ANA MARIA. Presidente: MATAIX ARA脩O ANA MARIA. Datos registrales. T 3397 , F162, S 8, H A 1365, I/A 98 (23.05.14).

24 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: CHIVA VENTURA JOAQUIN. Datos registrales. T 3397 , F 162, S 8, H A 1365, I/A 97 (14.03.14).

21 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: VICENS COMPANY ENRIQUE. Datos registrales. T 3397 , F 162, S 8, H A 1365, I/A 96 (14.03.14).

06 de Junio de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3397 , F 162, S 8, H A 1365, I/A 95(29.05.13).

29 de Mayo de 2013
Reelecciones. Consejero: SILVESTRE GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 3397 , F 162, S 8, H A 1365, I/A 94 (21.05.13).

14 de Noviembre de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3397 , F 161, S 8, H A 1365, I/A 93(31.10.12).

08 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apoderado: RICO ALBERT ENRIQUE JORGE. Datos registrales. T 3397 , F 161, S 8, H A 1365, I/A 92(27.09.12).

16 de Julio de 2012
Nombramientos. Apoderado: RICHART PRATS MIGUEL. Datos registrales. T 3397 , F 161, S 8, H A 1365, I/A 90 ( 5.07.12).

13 de Julio de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA CORTELL MARIA TERESA;ABELLAN SORIANO MARIA ANGELES;MORCILLO MORCILLOJUAN CARLOS;SEMPERE PASTOR JUAN CARLOS;GARCIA GACIA INOCENCIO. Datos registrales. T 3397 , F 160, S 8, H A1365, I/A 89 ( 4.07.12).

24 de Mayo de 2012
Reelecciones. Consejero: GRAU MULLOR LEON. Secretario: GRAU MULLOR LEON. Datos registrales. T 3397 , F 160, S 8, H A1365, I/A 88 (11.05.12).

17 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: LOZANO TOLSA FERNANDO. Apoderado: LOZANO TOLSA FERNANDO. Datos registrales. T3397 , F 160, S 8, H A 1365, I/A 87 ( 5.01.12).

23 de Agosto de 2011
Reelecciones. Consejero: MATARREDONA SOLER FRANCISCO JAVIER. Vicesecret.: MATARREDONA SOLER FRANCISCOJAVIER. Consejero: PASCUAL ALBERO RAFAEL. Vicepresid.: PASCUAL ALBERO RAFAEL. Datos registrales. T 3397 , F 160, S 8,H A 1365, I/A 85 ( 9.08.11).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3397 , F 160, S 8, H A 1365, I/A 86(10.08.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n