Actos BORME de La Veneciana Iberiaglass Sl
29 de Diciembre de 2015Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 199, S 8, H PO 33954, I/A 77 (21.12.15).
08 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABEZAS PRIETO ALEJANDRO. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 199, S 8, H PO 33954, I/A 76(28.05.15).
20 de Enero de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SAINT GOBAIN CRISTALERIA SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 3826, L 3826, F 199, S 8, H PO 33954, I/A 75 (12.01.15).
11 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILARI脩O TABOADA ALFONSO. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 198, S 8, H PO 33954, I/A 74 (2.12.14).
10 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 198, S 8, H PO33954, I/A 73 ( 1.09.14).
26 de Mayo de 2014Revocaciones. Apoderado: MARCOS SANCHEZ FRANCISCO-MANUEL. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 198, S 8, H PO33954, I/A 72 (15.05.14).
22 de Mayo de 2014Fe de erratas: SE RECTIFICA la inscripci贸n 69&, en el sentido de que existe en la escritura un error en el orden de los apellidos delapoderado designado, siendo el orden correcto GONZALEZ FONSECA, siendo por tanto el APODERADO designado en dichainscripci贸n DON JOSE RODRIGO GONZALEZ FONSECA. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 198, S 8, H PO 33954, I/A 71(13.05.14).
29 de Abril de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA CORCOLES JORGE;CRESPO GUTIERREZ ANIBAL. Datos registrales. T 3826, L 3826, F198, S 8, H PO 33954, I/A 69 (21.04.14).
23 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: TORRES SILVA CARLOS. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 196, S 8, H PO 33954, I/A 68(11.04.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FONSECA GONZALEZ JOSE RODRIGO. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 197, S 8, H PO33954, I/A 69 (11.04.14).
19 de Marzo de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: MIER SUAREZ GONZALO. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO 33954, I/A 67(12.03.14).
27 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARABANTES SANCHEZ SANTIAGO. Revocaciones. Apoderado: CARABANTES SANCHEZSANTIAGO. Nombramientos. Adm. Unico: GARRABE NAVARRO ANTONIO. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO33954, I/A 66 (18.12.13).
22 de Noviembre de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO33954, I/A 65 (13.11.13).
13 de Marzo de 2013Revocaciones. Apoderado: CALABIA DEL CAMPO RAMON. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO 33954, I/A 64(28.02.13).
14 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO33954, I/A 63 ( 3.01.13).
02 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: MU脩OZ FERRER MARTA. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 8, S 8, H PO 33954, I/A 62(22.10.12).
09 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: LAZARO MARTINEZ JORGE. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 6, S 8, H PO 33954, I/A 58(27.09.12).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ESLAVA EVA-MARIA. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 6, S 8, H PO 33954, I/A 59(27.09.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARMENA CUERVA AURORA. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 6, S 8, H PO 33954, I/A 60(27.09.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLARDO CODORRO VICTORIANO. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 7, S 8, H PO 33954,I/A 61 (27.09.12).
04 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ESLAVA EVA-MARIA. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 5, S 8, H PO 33954, I/A 57(20.04.12).
20 de Febrero de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LUCAS DIEZ MARIANO. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 224, S 8, H PO 33954, I/A 56 (8.02.12).
07 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 224, S 8, H PO33954, I/A 53 (24.10.11).
Revocaciones. Apoderado: FRUTOS HERNANZ BENITO JUAN. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 224, S 8, H PO 33954, I/A 54(24.10.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FRUTOS HERNANZ BENITO JUAN. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 224, S 8, H PO 33954, I/A55 (24.10.11).
27 de Octubre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: MADERA GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 222, S 8, H PO 33954, I/A 52(18.10.11).
17 de Octubre de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 222, S 8, H PO33954, I/A 51 ( 1.10.11).
05 de Julio de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILARI脩O TABOADA ALFONSO. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 221, S 8, H PO 33954, I/A50 (23.06.11).
11 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: ESTEVEZ ALVAREZ GERMAN. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 220, S 8, H PO 33954, I/A 49(27.04.11).
13 de Abril de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ-NESPRAL AMADO DIEGO. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 220, S 8, H PO33954, I/A 48 (31.03.11).
11 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ POZO LUIS. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 216, S 8, H PO 33954, I/A 44(31.01.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEZ ALVAREZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 217, S 8, H PO 33954, I/A 45(31.01.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA DEL HOYO JOSE. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 218, S 8, H PO 33954, I/A 46(31.01.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRESPO GUTIERREZ ANIBAL. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 219, S 8, H PO 33954, I/A 47(31.01.11).
17 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: HURTADO MARJALIZO FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 3636, L 3636, F 215, S 8, HPO 33954, I/A 43 ( 3.12.10).
26 de Octubre de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO DE CAYEUX ANDRES JUAN. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 224, S 8, H PO33954, I/A 41 (15.10.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCOS SANCHEZ VICENTE. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 225, S 8, H PO 33954, I/A 42(15.10.10).
28 de Julio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRUTOS HERNANZ BENITO JUAN. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 222, S 8, H PO 33954,I/A 40 (16.07.10).
23 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOMBARDIA MARTINEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 222, S 8, H PO 33954,I/A 39 ( 9.12.09).
25 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: VARELA CONDE JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 64, S 8, H PO 33954, I/A35 (13.11.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 219, S 8, H PO33954, I/A 36 (13.11.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIER SUAREZ GONZALO. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 220, S 8, H PO 33954, I/A 37(13.11.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA FERNANDEZ JULIO. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 221, S 8, H PO 33954, I/A 38(13.11.09).
24 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 64, S 8, H PO33954, I/A 34 (11.11.09).
20 de Noviembre de 2009Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: UNION CRISTALERA PORTAGLAS SL. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 64, S8, H PO 33954, I/A 33 ( 9.11.09).
25 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 64, S 8, H PO33954, I/A 31 (13.08.09).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 64, S 8, H PO33954, I/A 32 (13.08.09).
17 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ POZO LUIS. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 62, S 8, H PO 33954, I/A 29 (3.06.09).
Nombramientos. Apoderado: CALABIA DEL CAMPO RAMON. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 63, S 8, H PO 33954, I/A 30 (3.06.09).
20 de Febrero de 2009Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: UNION CRISTALERA PORTAGLAS SL. Datos registrales. T 2907, L 2907, F 62, S8, H PO 33954, I/A 28 (10.02.09).