Actos BORME de Labcatal Iberica Sl
19 de Junio de 2023Cambio de domicilio social. C/ ULISES 16-18 8 (MADRID). Datos registrales. T 40903 , F 70, S 8, H M 62726, I/A 30 (12.06.23).
16 de Febrero de 2022Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 64-66, 7潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 40903 , F 69, S 8, H M 62726,I/A 28 ( 9.02.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: DEL CASTILLO GONZALEZ EMILIO. Datos registrales. T 40903 , F 70, S 8, H M 62726, I/A 29 ( 9.02.22).
22 de Diciembre de 2020Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 23 de los Estatutos suprimiendo la retribuci贸n del cargo de administrador. Datosregistrales. T 40903 , F 69, S 8, H M 62726, I/A 27 (15.12.20).
17 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAZALLA COBO FRANCISCO;CA脩EQUE VAZQUEZ CRISTINA. Nombramientos. Apo.Sol.:CAZALLA COBO FRANCISCO. Datos registrales. T 12789 , F 209, S 8, H M 62726, I/A 24 (10.11.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: GROSSI STEPHANE. Datos registrales. T 12789 , F 210, S 8, H M 62726, I/A 25 (10.11.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: DEL CASTILLO GONZALEZ EMILIO. Datos registrales. T 40903 , F 68, S 8, H M 62726, I/A 26(10.11.20).
28 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apoderado: SUCK MONDUC ISABELLE;REDONDO BARDERA ALICIA;RUBIO BELLOD CARMEN;MONDUC MAX-MAXIME;MONDUC MAX MAXIME. Apo.Sol.: TIERCELIN PHILIPPE MICHEL MARCEL. Datos registrales. T 12789 , F 208, S 8, H M62726, I/A 23 (21.09.20).
23 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: SUCK MONDUC ISABELLE. Presidente: SUCK MONDUC ISABELLE. Consejero: MONDUC MAX-MAXIME. Vicepresid.: MONDUC MAX-MAXIME. Consejero: TIERCELIN PHILIPPE MICHEL MARCEL. Secretario: TIERCELINPHILIPPE MICHEL MARCEL. Cons.Del.Sol: SUCK MONDUC ISABELLE;MONDUC MAX MAXIME. Nombramientos. Adm. Solid.:BIENFAIT JONATHAN PHILIPPE;VERNE THIERRY GERARD. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 12789 , F 208, S 8, H M 62726, I/A 22 (16.09.20).
28 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: AFLALLO GINARD ARMANDO. Con.Delegado: AFLALLO GINARD ARMANDO. Secretario: AFLALLOGINARD ARMANDO. Revocaciones. Apoderado: CAZALLA COBO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: TIERCELINPHILIPPE MICHEL MARCEL. Secretario: TIERCELIN PHILIPPE MICHEL MARCEL. Cons.Del.Sol: SUCK MONDUCISABELLE;MONDUC MAX MAXIME. Apo.Sol.: TIERCELIN PHILIPPE MICHEL MARCEL. Apo.Man.Soli: CAZALLA COBOFRANCISCO;CA脩EQUE VAZQUEZ CRISTINA. Datos registrales. T 12789 , F 206, S 8, H M 62726, I/A 21 (20.02.14).
06 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apoderado: BLIN FRANCOIS ALAIN LUCIEN MARIE. Datos registrales. T 12789 , F 206, S 8, H M 62726, I/A 20(30.08.13).
07 de Noviembre de 2012Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LABCATAL SA. Datos registrales. T 12789 , F 205, S 8, H M 62726, I/A 18(25.10.12).
Revocaciones. Apoderado: AFLALLO GINARD ARMANDO;AFLALLO GINARD ARMANDO;AFLALLO GINARD ARMANDO;AFLALLOGINARD ARMANDO. Nombramientos. Apoderado: MONDUC MAX MAXIME. Datos registrales. T 12789 , F 205, S 8, H M 62726,I/A 19 (25.10.12).
04 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: CAZALLA COBO FRANCISCO. Datos registrales. T 12789 , F 202, S 8, H M 62726, I/A 17 (22.02.11).
13 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: ROQUERO GARCIA CASAL CARLOS. Secretario: VIVERO GONZALEZ MARIA. Nombramientos.Secretario: AFLALLO GINARD ARMANDO. Datos registrales. T 12789 , F 202, S 8, H M 62726, I/A 16 ( 2.08.10).
09 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: AFLALLO MARQUINEZ ARMANDO. Apoderado: AFLALLO MARQUINEZ ARMANDO. Datos registrales. T12789 , F 202, S 8, H M 62726, I/A 15 (27.11.09).
18 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: AFLALLO MARQUINEZ ARMANDO. Datos registrales. T 12789 , F 200, S 8, H M 62726, I/A 14 (6.02.09).