Buscador CIF Logo

Actos BORME Laboratorio Atenea Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laboratorio Atenea Sa

Actos BORME Laboratorio Atenea Sa - A83600239

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Laboratorio Atenea Sa con CIF A83600239

馃敊 Perfil de Laboratorio Atenea Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Laboratorio Atenea Sa

01 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Representan: HELFGOTT LUDOVIC.Nombramientos. Liquidador: DE JUAN ECHAVARRI GUILLERMO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 28674, F 135, S 8, H M 325083, I/A 42 (25.08.15).

08 de Julio de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO. Datos registrales. T 28674 , F 135, S 8, H M 325083, I/A 41(25.06.15).

02 de Julio de 2015
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 28674 , F 135, S 8, H M325083, I/A 40 (23.06.15).

01 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: HARTVIG CAMILLA HARDER. Nombramientos. Representan: HELFGOTT LUDOVIC. Datosregistrales. T 28674 , F 134, S 8, H M 325083, I/A 39 (23.06.15).

20 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO. Otros conceptos: RECTIFICAR LOS PODERESCONFERIDOS A FAVOR DE DON LORENZO WITTUM, QUE CAUSARON LA INSCRIPCION 32& DE LA HOJA SOCIAL. Datosregistrales. T 28674 , F 129, S 8, H M 325083, I/A 38 ( 9.08.13).

12 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 28674 , F 128, S 8, H M 325083, I/A 37 ( 2.08.13).

30 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PLAZA PI脩OL FEDERICO. Datos registrales. T 28674 , F 128, S 8, H M 325083, I/A 36 (23.05.13).

19 de Abril de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LLORENTE ALONSO GEMMA. Apo.Sol.: LLORENTE ALONSO GEMMA. Datos registrales. T 28674, F 127, S 8, H M 325083, I/A 35 (11.04.13).

09 de Enero de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MASSA MAZARRASA LUIS. Apo.Sol.: MASSA MAZARRASA LUIS. Datos registrales. T 28674 , F127, S 8, H M 325083, I/A 34 (27.12.12).

06 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: AMESCUA ESPERON FERNANDO. Apoderado: FUCHS FEDERICO;PONCE SANCHO JESUS.Nombramientos. Apoderado: WITTUM LORENZO;VALLES BASILIO IGNACIO. Datos registrales. T 28674 , F 124, S 8, H M325083, I/A 32 (24.10.12).

Nombramientos. Apoderado: AMESCUA ESPERON FERNANDO. Datos registrales. T 28674 , F 127, S 8, H M 325083, I/A 33(24.10.12).

26 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apoderado: SANJURJO COUSELO MARIA JESUS. Datos registrales. T 28674 , F 123, S 8, H M 325083, I/A 31(14.03.12).

26 de Enero de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ URGAL MARIA AMPARO. Datos registrales. T 28674 , F 121, S 8, H M 325083, I/A 30(16.01.12).

17 de Enero de 2012
Revocaciones. Apoderado: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS. Nombramientos. Apo.Sol.: MASSA MAZARRASA LUIS.Datos registrales. T 28674 , F 120, S 8, H M 325083, I/A 29 ( 4.01.12).

18 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: HUDSON PAUL ASHLEY. Nombramientos. Representan: HARTVIG CAMILLA HARDER. Datosregistrales. T 28674 , F 120, S 8, H M 325083, I/A 28 ( 6.07.11).

15 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: MORENO PEDRAZ FERNANDO. Datos registrales. T 23775 , F 16, S 8, H M 325083, I/A 27 (1.06.11).

10 de Febrero de 2011
Revocaciones. Apo.Manc.: MCTAVISH IAN. Apo.Sol.: MCTAVISH IAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PONZODA ALVAREZ ANA.Apo.Sol.: PEREZ MUETE LYDIA;MARQUEZ ARIAS PALOMA;ENRIQUEZ AGUADO JORGE;ILARRAZ DE URZAIZ PILAR. Datosregistrales. T 23775 , F 13, S 8, H M 325083, I/A 26 (31.01.11).

23 de Diciembre de 2010
Revocaciones. Apo.Sol.: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO;LOPEZ-SORS ALONSO FERNANDO-JOAQUIN;LLOSENT DENARDIZ MARIA DEL DULCE NOMBRE. Nombramientos. Apoderado: PONCE SANCHO JESUS. Datos registrales. T 23775 , F11, S 8, H M 325083, I/A 25 (10.12.10).

14 de Julio de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FUCHS FEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Nombramientos.Apoderado: FUCHS FEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 23775 , F 8, S 8, H M325083, I/A 24 ( 2.07.10).

11 de Junio de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS. Apo.Sol.: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS;KUNTZESTEFAN. Apo.Manc.: KUNTZE STEFAN;BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Apo.Sol.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO;BARRIOS

09 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FUCHSFEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION;LLORENTE ALONSO GEMA. Datos registrales. T 23775 , F 5, S 8,H M 325083, I/A 22 (27.01.10).

21 de Enero de 2009
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 23775 , F 5, S 8, H M325083, I/A 21 ( 9.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n