Buscador CIF Logo

Actos BORME Laboratorio Beta Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laboratorio Beta Sa

Actos BORME Laboratorio Beta Sa - A82700808

Tenemos registrados 70 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Laboratorio Beta Sa con CIF A82700808

🔙 Perfil de Laboratorio Beta Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Laboratorio Beta Sa

12 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: ABDER-REZZAQ MARTINEZ SUSANA. Datos registrales. T 32510 , F 32, S 8, H M 260335, I/A 96 (1.12.23).

18 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MASAVEU BONET CAROLINA. Datos registrales. T 32510 , F 31, S 8, H M 260335, I/A 95(10.10.23).

01 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: IGLESIAS DE DIOS INMACULADA. Apoderado: LAHOZ BONET CARLOS. Nombramientos.Apoderado: VELASCO MUÑOZ CESAR. Datos registrales. T 32510 , F 29, S 8, H M 260335, I/A 94 (25.07.23).

12 de Junio de 2023
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GALINDO LAURA. Datos registrales. T 32510 , F 28, S 8, H M 260335, I/A 93 (5.06.23).

22 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: DUSMET MODINO MARIA-CRISTINA. Datos registrales. T 32510 , F 28, S 8, H M 260335, I/A 92(14.03.23).

10 de Enero de 2023
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Otros conceptos: El cambio de domicilio social tendrá efectos a día 31 deenero de 2023. Cambio de domicilio social. C/ PUERTO DE SOMPORT 21-23 (MADRID). Datos registrales. T 32510 , F 28, S 8,H M 260335, I/A 91 ( 2.01.23).

02 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32510 , F 27, S 8, H M 260335, I/A90 (25.10.22).

03 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ SERRANO MARIA LARA. Datos registrales. T 32510 , F 27, S 8, H M 260335, I/A 89(26.09.22).

18 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SERRANO MARIA LARA;ROUSSELOT SANZ CRISTINA;SANCHEZ GARCIAELENA;LAHOZ BONET CARLOS;SANCHEZ SERRANO MARIA LARA. Datos registrales. T 32510 , F 25, S 8, H M 260335, I/A 88(10.08.22).

30 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: RUIZ SERRANO CARLA. Datos registrales. T 32510 , F 24, S 8, H M 260335, I/A 87 (23.03.22).

18 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: MUTIS OBANDO ANA MARIA;MUTIS OBANDO ANA MARIA. Datos registrales. T 32510 , F 23, S 8, HM 260335, I/A 86 (11.02.22).

04 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32510 , F 23, S 8, H M 260335, I/A85 (27.10.21).

23 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: VALLES BASILIO IGNACIO. Apoderado: LOPEZ-FANDO DE LA FUENTE MARIA INMACULADA.Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MONTERO MARIA-CRISTINA. Datos registrales. T 32510 , F 23, S 8, H M 260335, I/A84 (16.04.21).

06 de Abril de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32510 , F 22, S 8, H M 260335, I/A83 (26.03.21).

01 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO MINGUEZ MARTA. Datos registrales. T 32510 , F 21, S 8, H M 260335, I/A 82(22.02.21).

22 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GNECCO ELVIO;DEL CANO MIQUEL MARTA. Datos registrales. T 32510 , F 20, S 8, H M 260335, I/A81 (15.01.21).

24 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 32510 , F 19, S 8, H M260335, I/A 80 (17.12.20).

16 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Representan: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO. Nombramientos. Representan: SUAREZ RICARDORAFAEL. Datos registrales. T 32510 , F 19, S 8, H M 260335, I/A 79 ( 9.07.20).

04 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ DOMINGUEZ ANA FLORA. Datos registrales. T 32510 , F 18, S 8, H M 260335, I/A 78(28.01.20).

24 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: DIAZ-ROPERO ESTESO JESUS-JAVIER. Datos registrales. T 32510 , F 17, S 8, H M 260335, I/A 77(17.12.19).

25 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PADILLA JUAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 32510 , F 16, S 8, H M 260335, I/A 76(18.09.19).

12 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LUIS CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOMBARDERO LASARTE IGNACIO.Datos registrales. T 32510 , F 14, S 8, H M 260335, I/A 75 ( 5.08.19).

04 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANJURJO COUSELO MARIA JESUS. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-FANDO DE LAFUENTE MARIA INMACULADA. Datos registrales. T 32510 , F 13, S 8, H M 260335, I/A 74 (28.03.19).

09 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: ROGER CASTELLVI PATRICIA. Datos registrales. T 32510 , F 13, S 8, H M 260335, I/A 73 (1.10.18).

30 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32510 , F 12, S 8, H M 260335,I/A 72 (21.11.17).

10 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: VALERO HUETE MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 32510 , F 12, S 8, H M 260335, I/A 71 (3.03.17).

03 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32510 , F 12, S 8, H M 260335, I/A 70 (23.12.16).

02 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FRANCO CESAR. Datos registrales. T 32510 , F 11, S 8, H M 260335, I/A 69(23.11.16).

20 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32510 , F 10, S 8, H M 260335, I/A 68 (12.09.16).

30 de Mayo de 2016
Revocaciones. Apoderado: DE JUAN ECHAVARRI GUILLERMO. Nombramientos. Apoderado: MORENO PEDRAZ FERNANDO-JAVIER;CORDERO PUENTES LUIS ANGEL. Datos registrales. T 32510 , F 9, S 8, H M 260335, I/A 67 (23.05.16).

17 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: MUTIS OBANDO ANA MARIA. Datos registrales. T 32510 , F 8, S 8, H M 260335, I/A 66 ( 6.05.16).

14 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: WITTUM LORENZO. Datos registrales. T 32510 , F 8, S 8, H M 260335, I/A 65 ( 4.03.16).

12 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PONZODA ALVAREZ ANA. Apoderado: PEREZ MUETE LYDIA;MARQUEZ ARIASPALOMA;ENRIQUEZ AGUADO JORGE;ILARRAZ DE URZAIZ PILAR. Nombramientos. Apoderado: DUSMET MODINO MARIA-CRISTINA. Datos registrales. T 32510 , F 7, S 8, H M 260335, I/A 64 ( 2.02.16).

08 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Representan: HELFGOTT LUDOVIC. Nombramientos. Representan: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO.Datos registrales. T 32510 , F 7, S 8, H M 260335, I/A 63 (29.01.16).

03 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ELICHABE BENOIT CHRISTOPHE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LUISCARLOS;IGLESIAS DE DIOS INMACULADA. Datos registrales. T 32510 , F 5, S 8, H M 260335, I/A 61 (21.10.15).

Cambio de domicilio social. C/ SERRANO GALVACHE 56 - PARQUE NORTE, EDIFICIO A (MADRID). Datos registrales. T 32510, F 7, S 8, H M 260335, I/A 62 (21.10.15).

21 de Julio de 2015
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 32510 , F 4, S 8, H M260335, I/A 60 (14.07.15).

18 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO. Datos registrales. T 32510 , F 4, S 8, H M 260335, I/A 59(10.03.15).

26 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: MUTIS OBANDO ANA MARIA. Datos registrales. T 32510 , F 3, S 8, H M 260335, I/A 58 (18.02.15).

20 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32510 , F 2, S 8, H M 260335, I/A 57 (12.11.14).

25 de Julio de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 27686 , F 225, S 8, H M 260335, I/A 55 (17.07.14).

Nombramientos. Apoderado: DIAZ-ROPERO ESTESO JESUS-JAVIER. Datos registrales. T 27686 , F 225, S 8, H M 260335, I/A56 (17.07.14).

29 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 27686 , F 224, S 8, H M260335, I/A 54 (21.05.14).

14 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JIMENEZ URGAL MARIA AMPARO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ELICHABE BENOITCHRISTOPHE. Apo.Sol.: ALONSO MERINO JULIO. Datos registrales. T 27686 , F 222, S 8, H M 260335, I/A 53 ( 6.02.14).

14 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27686 , F 222, S 8, H M 260335, I/A 52 ( 6.11.13).

30 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: HARTVIG CAMILLA HARDER. Nombramientos. Representan: HELFGOTT LUDOVIC. Datos

12 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 27686 , F 220, S 8, H M 260335, I/A 50 ( 2.08.13).

06 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO. Otros conceptos: Rectificados los poderes conferidos a favorde Don Lorenzo Wittum en escritura otorgada el dia 1 de octubre de 2012, ante el Notario de Madrid, Don Enrique Franch Valverde conel número 1499 de su protocolo y que causó la inscripción 44& dela Hoja Social. Datos registrales. T 27686 , F 215, S 8, H M260335, I/A 49 (29.07.13).

31 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apoderado: PLAZA PIÑOL FEDERICO. Datos registrales. T 27686 , F 215, S 8, H M 260335, I/A 48 (23.05.13).

19 de Abril de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LLORENTE ALONSO GEMA. Datos registrales. T 27686 , F 215, S 8, H M 260335, I/A 47 (10.04.13).

14 de Enero de 2013
Revocaciones. Apoderado: MASSA MAZARRASA LUIS. Apo.Sol.: MASSA MAZARRASA LUIS. Datos registrales. T 27686 , F 215,S 8, H M 260335, I/A 46 ( 3.01.13).

24 de Diciembre de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27686 , F 215, S 8, H M 260335, I/A 45 (10.12.12).

08 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: AMESCUA ESPERON FERNANDO. Apoderado: FUCHS FEDERICO;PONCE SANCHO JESUS.Nombramientos. Apo.Man.Soli: WITTUM LORENZO. Apo.Sol.: VALLES BASILIO IGNACIO. Datos registrales. T 27686 , F 212, S8, H M 260335, I/A 44 (26.10.12).

29 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANJURJO COUSELO MARIA JESUS. Datos registrales. T 27686 , F 211, S 8, H M 260335, I/A 43(16.03.12).

28 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27686 , F 211, S 8, H M 260335, I/A 41 (15.03.12).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27686 , F 211, S 8, H M 260335, I/A 42 (16.03.12).

13 de Enero de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ URGAL MARIA AMPARO. Datos registrales. T 27686 , F 210, S 8, H M 260335, I/A 39 (2.01.12).

Revocaciones. Apoderado: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS. Nombramientos. Apo.Sol.: MASSA MAZARRASA LUIS.Datos registrales. T 27686 , F 210, S 8, H M 260335, I/A 40 ( 2.01.12).

18 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: HUDSON PAUL ASHLEY. Nombramientos. Representan: HARTVIG CAMILLA HARDER. Datosregistrales. T 27686 , F 209, S 8, H M 260335, I/A 38 ( 6.07.11).

10 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: MORENO PEDRAZ FERNANDO. Datos registrales. T 27686 , F 209, S 8, H M 260335, I/A 37(31.05.11).

22 de Marzo de 2011
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 27686 , F 204, S 8, H M260335, I/A 34 (10.03.11).

Revocaciones. Apo.Sol.: MCTAVISH IAN. Apo.Manc.: MCTAVISH IAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PONZODA ALVAREZ ANA.Apoderado: PEREZ MUETE LYDIA;MARQUEZ ARIAS PALOMA;ENRIQUEZ AGUADO JORGE;ILARRAZ DE URZAIZ PILAR. Datos

Revocaciones. Apo.Manc.: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO. Apo.Sol.: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO;LOPEZ-SORS ALONSO FERNANDO-JOAQUIN;LLOSENT DE NARDIZ MARIA DEL DULCE NOMBRE. Nombramientos. Apoderado:PONCE SANCHO JESUS. Datos registrales. T 27686 , F 207, S 8, H M 260335, I/A 36 (11.03.11).

20 de Julio de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FUCHS FEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Nombramientos.Apoderado: FUCHS FEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 27686 , F 203, S 8, H M260335, I/A 33 ( 9.07.10).

14 de Junio de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS. Apo.Sol.: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS.Nombramientos. Apoderado: MASSA MAZARRASA LUIS;PLAZA PIÑOL FEDERICO. Datos registrales. T 21205 , F 174, S 8, H M260335, I/A 32 (31.05.10).

23 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21205 , F 174, S 8, H M 260335, I/A 31 (11.02.10).

19 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21205 , F 174, S 8, H M 260335, I/A 30 (10.02.10).

14 de Enero de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FUCHSFEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 21205 , F 173, S 8, H M 260335, I/A 29(29.12.09).

20 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Apo.Manc.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Nombramientos.Apo.Man.Soli: LLORENTE ALONSO GEMA. Datos registrales. T 21205 , F 172, S 8, H M 260335, I/A 28 ( 8.05.09).

04 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: KUNTZE STEFAN. Apo.Manc.: KUNTZE STEFAN. Datos registrales. T 21205 , F 172, S 8, H M 260335,I/A 27 (22.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información