Buscador CIF Logo

Actos BORME Laboratorio De Diagnosticos Y Alimentacion 2008 Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laboratorio De Diagnosticos Y Alimentacion 2008 Sl

Actos BORME Laboratorio De Diagnosticos Y Alimentacion 2008 Sl - B47609052

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Valladolid para Laboratorio De Diagnosticos Y Alimentacion 2008 Sl con CIF B47609052

🔙 Perfil de Laboratorio De Diagnosticos Y Alimentacion 2008 Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valladolid

Actos BORME de Laboratorio De Diagnosticos Y Alimentacion 2008 Sl

18 de Julio de 2023
Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: BIOAVIAN ALIMENTACION ANIMAL SL. Datos registrales. T 1564 , F131, S 8, H VA 20452, I/A 20 (11.07.23).

09 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: WESJOHANN DIRK. Presidente: WESJOHANN DIRK. Nombramientos. Consejero: DEEKENCHRISTIAN. Presidente: DEEKEN CHRISTIAN. Datos registrales. T 1564 , F 131, S 8, H VA 20452, I/A 19 (29.04.22).

07 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO MORENO PASCUAL. Secretario: ALONSO MORENO PASCUAL. Nombramientos.Consejero: SAGARDIA PRADERA JORGE. Secretario: SAGARDIA PRADERA JORGE. Datos registrales. T 1564 , F 131, S 8, H VA20452, I/A 18 (30.06.20).

05 de Marzo de 2020
Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1564 ,F 131, S 8, H VA 20452, I/A 17 (27.02.20).

10 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: ALONSO MORENO PASCUAL. Apoderado: SANCHEZ MAYORGA ANA ISABEL. Datos registrales. T1564 , F 131, S 8, H VA 20452, I/A 16 ( 3.10.19).

14 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: WESJOHANN DIRK;RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Presidente: WESJOHANNDIRK. Con.Delegado: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Consejero: ALONSO MORENO PASCUAL. Secretario:ALONSO MORENO PASCUAL. Nombramientos. Consejero: WESJOHANN DIRK;ALONSO MORENO PASCUAL;RAMIREZVILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Presidente: WESJOHANN DIRK. Secretario: ALONSO MORENO PASCUAL. Con.Delegado:RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Modificaciones estatutarias. án su cargo por tiempo indefinido. LosAdministradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por los socios que representen la mayoría del capital social.El cargo de Administrador será gratuito.. Datos registrales. T 1305 , F 225, S 8, H VA 20452, I/A 15 ( 6.02.18).

21 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: SAGARDIA PRADERA JORGE;SANCHEZ MAYORGA ANA ISABEL. Datos registrales. T 1305 , F225, S 8, H VA 20452, I/A 14 (14.11.17).

04 de Julio de 2017
Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1305 ,F 225, S 8, H VA 20452, I/A 13 (27.06.17).

23 de Febrero de 2015
Nombramientos. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T1305 , F 224, S 8, H VA 20452, I/A 12 (16.02.15).

21 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: PHILIPP HERLYN ENNO. Secretario: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: ALONSO MORENO PASCUAL. Secretario: ALONSO MORENO PASCUAL. Datos registrales. T 1305, F 224, S 8, H VA 20452, I/A 11 (14.01.15).

24 de Enero de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: EUROPEAN LAYER DISTRIBUTION GMBH. Datos registrales. T1305 , F 224, S 8, H VA 20452, I/A 9 (17.01.14).

Reelecciones. Consejero: WESJOHANN DIRK;RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Presidente: WESJOHANN DIRK.Secretario: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER.Consejero: PHILIPP HERLYN ENNO. Datos registrales. T 1305 , F 224, S 8, H VA 20452, I/A 10 (17.01.14).

05 de Julio de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: ALONSO MORENO PASCUAL. Apoderado: SANCHEZ MAYORGA ANA ISABEL. Datos registrales. T1305 , F 223, S 8, H VA 20452, I/A 8 (28.06.13).

14 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: FINCK HANS FIEDRICH. Nombramientos. Consejero: PHILIPP HERLYN ENNO. Datosregistrales. T 1305 , F 223, S 8, H VA 20452, I/A 7 ( 5.03.12).

27 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO MORENO PASCUAL. Datos registrales. T 1305 , F 223, S 8, H VA 20452, I/A 6(16.09.11).

23 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GAMBOA MARIA ROSA. Datos registrales. T 1305 , F 222, S 8, H VA 20452, I/A 5(14.02.11).

02 de Febrero de 2011
Nombramientos. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: ESCAÑO ROMAN LUIS. Datos registrales. T 1305 , F 222,S 8, H VA 20452, I/A 4 (24.01.11).

22 de Febrero de 2010
Declaración de unipersonalidad. Socio único: LOHMANN TIERZUCHT GESELLSCHAT MIT BESCHRANKTER HAF.Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DE LAS HERAS NIÑO RAFAEL. Consejero: BERND SEIDEL MICHAEL;PASCUAL GOMEZ-CUETARA TOMAS FLORENCIO;URBELZ PEREZ IGNACIO. Nombramientos. Consejero: FINCK HANS FIEDRICH. Secretario:RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Consejero: WESJOHANN DIRK;RAMIREZ VILLAESCUSAFRANCISCO JAVIER. Presidente: WESJOHANN DIRK. Con.Delegado: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 1305 , F 222, S 8, H VA 20452, I/A 3 (11.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información