Buscador CIF Logo

Actos BORME Laboratorio Lailan Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laboratorio Lailan Sa

Actos BORME Laboratorio Lailan Sa - A82630120

Tenemos registrados 72 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Laboratorio Lailan Sa con CIF A82630120

🔙 Perfil de Laboratorio Lailan Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Laboratorio Lailan Sa

31 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MASAVEU BONET CAROLINA. Datos registrales. T 43529 , F 157, S 8, H M 254850, I/A 103(24.10.23).

28 de Julio de 2023
Revocaciones. Apoderado: IGLESIAS DE DIOS INMACULADA. Apo.Sol.: LAHOZ BONET CARLOS. Nombramientos.Apo.Man.Soli: VELASCO MUÑOZ CESAR. Datos registrales. T 43529 , F 154, S 8, H M 254850, I/A 101 (21.07.23).

05 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GALINDO LAURA. Datos registrales. T 43529 , F 153, S 8, H M 254850, I/A 100(26.04.23).

17 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: DUSMET MODINO MARIA-CRISTINA. Datos registrales. T 43529 , F 153, S 8, H M 254850, I/A 99(10.03.23).

10 de Enero de 2023
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Otros conceptos: El cambio de domicilio social tendrá efectos a día 31 deenero de 2023. Cambio de domicilio social. C/ PUERTO DE SOMPORT 21-23 (MADRID). Datos registrales. T 43529 , F 153, S 8,H M 254850, I/A 98 ( 2.01.23).

03 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43529 , F 153, S 8, H M 254850,I/A 97 (26.10.22).

03 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ SERRANO MARIA LARA. Datos registrales. T 43529 , F 152, S 8, H M 254850, I/A 96(26.09.22).

18 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ SERRANO MARIA LARA. Apo.Sol.: SANCHEZ SERRANO MARIA LARA;ROUSSELOTSANZ CRISTINA;SANCHEZ GARCIA ELENA;LAHOZ BONET CARLOS. Datos registrales. T 43529 , F 151, S 8, H M 254850, I/A 95(10.08.22).

22 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABEZAS CEBALLOS ROSA MARIA. Datos registrales. T 32307 , F 25, S 8, H M 254850, I/A 94(15.06.22).

28 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: GNECCO ELVIO. Nombramientos. Apoderado: RUIZ SERRANO CARLA. Datos registrales. T 32307 , F24, S 8, H M 254850, I/A 93 (21.03.22).

16 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: MUTIS OBANDO ANA MARIA;MUTIS OBANDO ANA MARIA. Datos registrales. T 32307 , F 24, S 8, HM 254850, I/A 92 ( 9.02.22).

04 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32307 , F 23, S 8, H M 254850, I/A91 (27.10.21).

23 de Abril de 2021
Revocaciones. Apoderado: CORDERO PUENTES LUIS ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABEZAS CEBALLOS ROSAMARIA. Datos registrales. T 32307 , F 22, S 8, H M 254850, I/A 90 (16.04.21).

09 de Abril de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32307 , F 21, S 8, H M 254850, I/A89 (31.03.21).

26 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: MORENO MINGUEZ MARTA. Datos registrales. T 32307 , F 20, S 8, H M 254850, I/A 88 (19.02.21).

01 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GNECCO ELVIO;DEL CANO MIQUEL MARTA. Datos registrales. T 32307 , F 19, S 8, H M 254850, I/A87 (25.01.21).

24 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 32307 , F 19, S 8, H M254850, I/A 86 (17.12.20).

18 de Septiembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: VALLES BASILIO IGNACIO;LOPEZ-FANDO DE LA FUENTE MARIA INMACULADA. Nombramientos.Apo.Sol.: FERNANDEZ MONTERO MARIA-CRISTINA. Datos registrales. T 32307 , F 18, S 8, H M 254850, I/A 85 (11.09.20).

16 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Representan: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO. Nombramientos. Representan: SUAREZ RICARDORAFAEL. Datos registrales. T 32307 , F 18, S 8, H M 254850, I/A 84 ( 9.07.20).

13 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: PEREZ DOMINGUEZ ANA FLORA. Datos registrales. T 32307 , F 16, S 8, H M 254850, I/A 83 (6.02.20).

24 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: DIAZ-ROPERO ESTESO JESUS-JAVIER. Datos registrales. T 32307 , F 16, S 8, H M 254850, I/A 82(17.12.19).

24 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: PADILLA JUAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 32307 , F 15, S 8, H M 254850, I/A 81 (17.09.19).

09 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ LUIS CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOMBARDERO LASARTE IGNACIO.Datos registrales. T 32307 , F 13, S 8, H M 254850, I/A 80 ( 2.08.19).

04 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANJURJO COUSELO MARIA JESUS. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-FANDO DE LAFUENTE MARIA INMACULADA. Datos registrales. T 32307 , F 12, S 8, H M 254850, I/A 79 (28.03.19).

06 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: ROGER CASTELLVI PATRICIA. Datos registrales. T 32307 , F 12, S 8, H M 254850, I/A 78(26.10.18).

17 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32307 , F 11, S 8, H M 254850,I/A 77 (10.11.17).

09 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: VALERO HUETE MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 32307 , F 11, S 8, H M 254850, I/A 76 (2.03.17).

16 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ FRANCO CESAR. Apo.Sol.: FERNANDEZ FRANCO CESAR. Datos registrales. T32307 , F 9, S 8, H M 254850, I/A 74 ( 3.01.17).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32307 , F 10, S 8, H M 254850, I/A 75 ( 4.01.17).

26 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32307 , F 9, S 8, H M 254850, I/A 73 (16.09.16).

31 de Mayo de 2016
Revocaciones. Apoderado: DE JUAN ECHAVARRI GUILLERMO. Nombramientos. Apoderado: MORENO PEDRAZ FERNANDO-JAVIER;CORDERO PUENTES LUIS ANGEL. Datos registrales. T 32307 , F 7, S 8, H M 254850, I/A 72 (23.05.16).

13 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: MUTIS OBANDO ANA MARIA. Datos registrales. T 32307 , F 7, S 8, H M 254850, I/A 71 ( 5.05.16).

15 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: WITTUM LORENZO;WITTUM LORENZO. Datos registrales. T 32307 , F 7, S 8, H M 254850, I/A 70 (7.03.16).

11 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PONZODA ALVAREZ ANA. Nombramientos. Apoderado: DUSMET MODINO MARIA-CRISTINA.Datos registrales. T 32307 , F 6, S 8, H M 254850, I/A 69 ( 3.02.16).

08 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Representan: HELFGOTT LUDOVIC. Nombramientos. Representan: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO.Datos registrales. T 32307 , F 5, S 8, H M 254850, I/A 68 (29.01.16).

06 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: ELICHABE BENOIT CHRISTOPHE. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LUIS CARLOS;IGLESIASDE DIOS INMACULADA. Datos registrales. T 32307 , F 4, S 8, H M 254850, I/A 66 (28.10.15).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ SERRANO GALVACHE 56 -PARQUE NORTE, EDIFICIO A (MADRID). Datos registrales. T 32307 , F 5, S 8, H M 254850, I/A 67 (28.10.15).

13 de Julio de 2015
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 32307 , F 3, S 8, H M254850, I/A 65 ( 3.07.15).

18 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO. Datos registrales. T 32307 , F 3, S 8, H M 254850, I/A 64 (9.03.15).

26 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: MUTIS OBANDO ANA MARIA. Datos registrales. T 32307 , F 1, S 8, H M 254850, I/A 63 (18.02.15).

17 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32307 , F 1, S 8, H M 254850, I/A 62 ( 6.11.14).

22 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: DIAZ-ROPERO ESTESO JESUS-JAVIER. Datos registrales. T 27602 , F 225, S 8, H M 254850, I/A61 (14.07.14).

15 de Julio de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 27602 , F 224, S 8, H M 254850, I/A 60 ( 7.07.14).

29 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 27602 , F 224, S 8, H M254850, I/A 59 (21.05.14).

11 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JIMENEZ URGAL MARIA AMPARO. Nombramientos. Apoderado: ELICHABE BENOITCHRISTOPHE;ALONSO MERINO JULIO. Datos registrales. T 27602 , F 222, S 8, H M 254850, I/A 58 ( 3.02.14).

15 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27602 , F 222, S 8, H M 254850, I/A 57 ( 6.11.13).

30 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: HARTVIG CAMILLA HARDER. Nombramientos. Representan: HELFGOTT LUDOVIC. Datosregistrales. T 27602 , F 221, S 8, H M 254850, I/A 56 (21.10.13).

16 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 27602 , F 220, S 8, H M 254850, I/A 55 (6.08.13).

07 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO. Otros conceptos: RECTIFICACION DEL PODERCONFERIDO A DON LORENZO WITTUM QUE ORIGINO LA INSCRIPCION 47 DE ESTA HOJA. Datos registrales. T 27602 , F 218,S 8, H M 254850, I/A 54 (30.07.13).

26 de Junio de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27602 , F 218, S 8, H M 254850, I/A 53 (19.06.13).

25 de Junio de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27602 , F 148, S 8, H M 254850, I/A 52 (17.06.13).

31 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apoderado: PLAZA PIÑOL FEDERICO. Datos registrales. T 27602 , F 146, S 8, H M 254850, I/A 51 (23.05.13).

19 de Abril de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LLORENTE ALONSO GEMA. Datos registrales. T 27602 , F 146, S 8, H M 254850, I/A 50 (10.04.13).

14 de Enero de 2013
Revocaciones. Apoderado: MASSA MAZARRASA LUIS. Apo.Sol.: MASSA MAZARRASA LUIS. Datos registrales. T 27602 , F 146,S 8, H M 254850, I/A 49 ( 3.01.13).

29 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: AMESCUA ESPERON FERNANDO. Apoderado: FUCHS FEDERICO;PONCE SANCHO JESUS.Nombramientos. Apoderado: WITTUM LORENZO;WITTUM LORENZO;VALLES BASILIO IGNACIO. Datos registrales. T 27602 , F143, S 8, H M 254850, I/A 47 (17.10.12).

Nombramientos. Apoderado: AMESCUA ESPERON FERNANDO. Datos registrales. T 27602 , F 145, S 8, H M 254850, I/A 48(17.10.12).

17 de Mayo de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANJURJO COUSELO MARIA JESUS. Datos registrales. T 27602 , F 142, S 8, H M 254850, I/A 46( 7.05.12).

10 de Mayo de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27602 , F 142, S 8, H M 254850, I/A 45 (26.04.12).

17 de Enero de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ URGAL MARIA AMPARO. Datos registrales. T 27602 , F 140, S 8, H M 254850, I/A 42 (4.01.12).

Revocaciones. Apoderado: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS. Nombramientos. Apo.Sol.: MASSA MAZARRASA LUIS.Datos registrales. T 27602 , F 141, S 8, H M 254850, I/A 43 ( 4.01.12).

18 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: HUDSON PAUL ASHLEY. Nombramientos. Representan: HARTVIG CAMILLA HARDER. Datosregistrales. T 27602 , F 140, S 8, H M 254850, I/A 41 ( 6.07.11).

15 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: MORENO PEDRAZ FERNANDO. Datos registrales. T 27602 , F 140, S 8, H M 254850, I/A 40 (1.06.11).

22 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apo.Manc.: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO. Apo.Sol.: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO;LOPEZ-SORS ALONSO FERNANDO-JOAQUIN;LLOSENT DE NARDIZ MARIA DEL DULCE NOMBRE. Nombramientos. Apoderado:PONCE SANCHO JESUS. Datos registrales. T 27602 , F 137, S 8, H M 254850, I/A 39 (10.03.11).

28 de Febrero de 2011
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 27602 , F 134, S 8, H M254850, I/A 37 (15.02.11).

Revocaciones. Apo.Sol.: MCTAVISH IAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PONZODA ALVAREZ ANA. Apo.Sol.: PEREZ MUETELYDIA;MARQUEZ ARIAS PALOMA;ENRIQUEZ AGUADO JORGE;ILARRAZ DE URZAIZ PILAR. Datos registrales. T 27602 , F 134,S 8, H M 254850, I/A 38 (15.02.11).

21 de Julio de 2010
Revocaciones. Apoderado: FUCHS FEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Nombramientos. Apoderado:FUCHS FEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 27602 , F 133, S 8, H M 254850, I/A 36( 9.07.10).

11 de Junio de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS. Apo.Sol.: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS.Nombramientos. Apoderado: MASSA MAZARRASA LUIS;PLAZA PIÑOL FEDERICO. Datos registrales. T 21205 , F 188, S 8, H M254850, I/A 35 (31.05.10).

22 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21205 , F 188, S 8, H M 254850, I/A 34 (10.02.10).

19 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21205 , F 188, S 8, H M 254850, I/A 33 ( 9.02.10).

30 de Diciembre de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Apoderado: FUCHS FEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 21205 ,F 187, S 8, H M 254850, I/A 32 (16.12.09).

20 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Apo.Manc.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Nombramientos.Apo.Man.Soli: LLORENTE ALONSO GEMA. Datos registrales. T 21205 , F 186, S 8, H M 254850, I/A 31 ( 8.05.09).

04 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: KUNTZE STEFAN. Apo.Manc.: KUNTZE STEFAN. Datos registrales. T 21205 , F 186, S 8, H M 254850,I/A 30 (22.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información