Buscador CIF Logo

Actos BORME Laboratorio Tau Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laboratorio Tau Sa

Actos BORME Laboratorio Tau Sa - A28099745

Tenemos registrados 75 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Laboratorio Tau Sa con CIF A28099745

🔙 Perfil de Laboratorio Tau Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Laboratorio Tau Sa

27 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 41464 , F 131, S 8, H M 280762,I/A 110 (19.12.23).

19 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: ABDER-REZZAQ MARTINEZ SUSANA. Datos registrales. T 41464 , F 130, S 8, H M 280762, I/A 109(12.12.23).

19 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MASAVEU BONET CAROLINA. Datos registrales. T 41464 , F 128, S 8, H M 280762, I/A 108(11.10.23).

28 de Julio de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: IGLESIAS DE DIOS INMACULADA. Apoderado: LAHOZ BONET CARLOS. Nombramientos.Apoderado: VELASCO MUÑOZ CESAR. Datos registrales. T 41464 , F 128, S 8, H M 280762, I/A 107 (21.07.23).

03 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GALINDO LAURA. Datos registrales. T 41464 , F 127, S 8, H M 280762, I/A 106(24.04.23).

22 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: DUSMET MODINO MARIA-CRISTINA. Datos registrales. T 41464 , F 127, S 8, H M 280762, I/A 105(14.03.23).

10 de Enero de 2023
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Otros conceptos: El cambio de domicilio social tendrá efectos a día 31 deenero de 2023. Cambio de domicilio social. C/ PUERTO DE SOMPORT 21-23 (MADRID). Datos registrales. T 41464 , F 126, S 8,H M 280762, I/A 104 ( 2.01.23).

27 de Octubre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 41464 , F 126, S 8, H M 280762,I/A 103 (20.10.22).

03 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ SERRANO MARIA LARA. Datos registrales. T 41464 , F 126, S 8, H M 280762, I/A 102(26.09.22).

18 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SERRANO MARIA LARA;ROUSSELOT SANZ CRISTINA;SANCHEZ GARCIAELENA;LAHOZ BONET CARLOS. Datos registrales. T 41464 , F 124, S 8, H M 280762, I/A 101 (10.08.22).

15 de Junio de 2022
Revocaciones. Apoderado: CABEZAS CEBALLOS ROSA MARIA. Datos registrales. T 41464 , F 124, S 8, H M 280762, I/A 100 (8.06.22).

13 de Abril de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: GNECCO ELVIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ SERRANO CARLA. Datos registrales. T 41464, F 122, S 8, H M 280762, I/A 99 ( 6.04.22).

09 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: MUTIS OBANDO ANA MARIA;MUTIS OBANDO ANA MARIA. Datos registrales. T 41464 , F 121, S 8, HM 280762, I/A 98 ( 2.03.22).

19 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 41464 , F 121, S 8, H M 280762,I/A 97 (12.11.21).

21 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: VALLES BASILIO IGNACIO;LOPEZ-FANDO DE LA FUENTE MARIA INMACULADA. Nombramientos.Apoderado: FERNANDEZ MONTERO MARIA-CRISTINA. Datos registrales. T 41464 , F 120, S 8, H M 280762, I/A 96 (14.04.21).

14 de Abril de 2021
Revocaciones. Apoderado: CORDERO PUENTES LUIS ANGEL. Nombramientos. Apoderado: CABEZAS CEBALLOS ROSAMARIA. Datos registrales. T 33111 , F 39, S 8, H M 280762, I/A 95 ( 7.04.21).

08 de Abril de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 33111 , F 37, S 8, H M 280762, I/A94 (30.03.21).

04 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: MORENO MINGUEZ MARTA. Datos registrales. T 33111 , F 37, S 8, H M 280762, I/A 93 (25.02.21).

03 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: DEL CANO MIQUEL MARTA. Apo.Sol.: GNECCO ELVIO. Datos registrales. T 33111 , F 36, S 8, H M280762, I/A 92 (27.01.21).

24 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 33111 , F 35, S 8, H M280762, I/A 91 (17.12.20).

16 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Representan: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO. Nombramientos. Representan: SUAREZ RICARDORAFAEL. Datos registrales. T 33111 , F 35, S 8, H M 280762, I/A 90 ( 9.07.20).

07 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: PEREZ DOMINGUEZ ANA FLORA. Datos registrales. T 33111 , F 33, S 8, H M 280762, I/A 89(31.01.20).

24 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: DIAZ-ROPERO ESTESO JESUS-JAVIER. Datos registrales. T 33111 , F 33, S 8, H M 280762, I/A 88(17.12.19).

24 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: PADILLA JUAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 33111 , F 32, S 8, H M 280762, I/A 87 (17.09.19).

09 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LUIS CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOMBARDERO LASARTE IGNACIO.Datos registrales. T 33111 , F 30, S 8, H M 280762, I/A 86 ( 2.08.19).

04 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANJURJO COUSELO MARIA JESUS. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ-FANDO DE LA FUENTEMARIA INMACULADA. Datos registrales. T 33111 , F 29, S 8, H M 280762, I/A 85 (28.03.19).

04 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: ROGER CASTELLVI PATRICIA. Datos registrales. T 33111 , F 28, S 8, H M 280762, I/A 84(27.09.18).

27 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 33111 , F 28, S 8, H M 280762,I/A 83 (15.11.17).

17 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: VALERO HUETE MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 33111 , F 28, S 8, H M 280762, I/A 82 (9.03.17).

16 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ FRANCO CESAR. Apo.Sol.: FERNANDEZ FRANCO CESAR. Datos registrales. T33111 , F 26, S 8, H M 280762, I/A 81 ( 3.01.17).

23 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33111 , F 26, S 8, H M 280762, I/A 80 (16.12.16).

23 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33111 , F 26, S 8, H M 280762, I/A 79 (15.09.16).

31 de Mayo de 2016
Revocaciones. Apoderado: DE JUAN ECHAVARRI GUILLERMO. Nombramientos. Apoderado: MORENO PEDRAZ FERNANDO-JAVIER;CORDERO PUENTES LUIS ANGEL. Datos registrales. T 33111 , F 24, S 8, H M 280762, I/A 78 (23.05.16).

13 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: MUTIS OBANDO ANA MARIA. Datos registrales. T 33111 , F 24, S 8, H M 280762, I/A 77 ( 5.05.16).

16 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: WITTUM LORENZO. Datos registrales. T 33111 , F 23, S 8, H M 280762, I/A 76 ( 8.03.16).

11 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apoderado: PONZODA ALVAREZ ANA. Nombramientos. Apoderado: DUSMET MODINO MARIA-CRISTINA.Datos registrales. T 33111 , F 23, S 8, H M 280762, I/A 75 ( 3.02.16).

08 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Representan: HELFGOTT LUDOVIC. Nombramientos. Representan: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO.Datos registrales. T 33111 , F 22, S 8, H M 280762, I/A 74 (29.01.16).

26 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apoderado: ELICHABE BENOIT CHRISTOPHE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LUISCARLOS;IGLESIAS DE DIOS INMACULADA. Datos registrales. T 33111 , F 20, S 8, H M 280762, I/A 72 (15.10.15).

Cambio de domicilio social. C/ SERRANO GALVACHE 56 - PARQUE NORTE, EDIFICIO AL (MADRID). Datos registrales. T33111 , F 22, S 8, H M 280762, I/A 73 (15.10.15).

21 de Julio de 2015
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Datos registrales. T 33111 , F 20, S 8, H M280762, I/A 71 (14.07.15).

17 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO. Datos registrales. T 33111 , F 20, S 8, H M 280762, I/A 70 (9.03.15).

02 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apoderado: MUTIS OBANDO ANA MARIA. Datos registrales. T 30142 , F 103, S 8, H M 280762, I/A 69(20.02.15).

25 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30142 , F 103, S 8, H M 280762, I/A 68 (18.11.14).

23 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: DIAZ-ROPERO ESTESO JESUS-JAVIER. Datos registrales. T 30142 , F 101, S 8, H M 280762, I/A67 (15.07.14).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 30142 , F 101, S 8, H M 280762, I/A 66 (15.07.14).

26 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 30142 , F 101, S 8, H M280762, I/A 65 (19.05.14).

11 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JIMENEZ URGAL MARIA AMPARO. Nombramientos. Apoderado: ELICHABE BENOITCHRISTOPHE;ALONSO MERINO JULIO. Datos registrales. T 30142 , F 98, S 8, H M 280762, I/A 64 ( 3.02.14).

28 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30142 , F 98, S 8, H M 280762, I/A 63 (22.11.13).

30 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: HARTVIG CAMILLA HARDER. Nombramientos. Representan: HELFGOTT LUDOVIC. Datosregistrales. T 30142 , F 98, S 8, H M 280762, I/A 62 (21.10.13).

20 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO. Otros conceptos: RECTIFICADO EL PODER CONFERIDO AFAVOR DE DON LORENZO WITTUM, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 55& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 30142 , F93, S 8, H M 280762, I/A 61 ( 9.08.13).

12 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 30142 , F 91, S 8, H M 280762, I/A 60 ( 5.08.13).

31 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apoderado: PLAZA PIÑOL FEDERICO. Datos registrales. T 30142 , F 91, S 8, H M 280762, I/A 59 (23.05.13).

23 de Abril de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LLORENTE ALONSO GEMA. Datos registrales. T 30142 , F 91, S 8, H M 280762, I/A 58 (15.04.13).

14 de Enero de 2013
Revocaciones. Apoderado: MASSA MAZARRASA LUIS. Apo.Sol.: MASSA MAZARRASA LUIS. Datos registrales. T 30142 , F 90, S8, H M 280762, I/A 57 ( 3.01.13).

14 de Diciembre de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30142 , F 90, S 8, H M 280762, I/A 56 ( 7.12.12).

29 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: AMESCUA ESPERON FERNANDO. Apoderado: FUCHS FEDERICO. Nombramientos. Apo.Man.Soli:WITTUM LORENZO. Apo.Sol.: VALLES BASILIO IGNACIO. Datos registrales. T 27295 , F 44, S 8, H M 280762, I/A 55 (17.10.12).

26 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: AMESCUA ESPERON FERNANDO. Datos registrales. T 27295 , F 43, S 8, H M 280762, I/A 54(16.10.12).

29 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27295 , F 43, S 8, H M 280762, I/A 53 (16.03.12).

26 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANJURJO COUSELO MARIA JESUS. Datos registrales. T 27295 , F 42, S 8, H M 280762, I/A 52(13.03.12).

16 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27295 , F 42, S 8, H M 280762, I/A 51 ( 6.03.12).

20 de Enero de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ URGAL MARIA AMPARO. Datos registrales. T 27295 , F 40, S 8, H M 280762, I/A 49(10.01.12).

Revocaciones. Apoderado: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS. Nombramientos. Apo.Sol.: MASSA MAZARRASA LUIS.Datos registrales. T 27295 , F 42, S 8, H M 280762, I/A 50 (10.01.12).

18 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: HUDSON PAUL ASHLEY. Nombramientos. Representan: HARTVIG CAMILLA HARDER. Datosregistrales. T 27295 , F 40, S 8, H M 280762, I/A 48 ( 6.07.11).

09 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: MORENO PEDRAZ FERNANDO. Datos registrales. T 27295 , F 40, S 8, H M 280762, I/A 47(31.05.11).

22 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO. Apo.Manc.: RECODER DE LA CUADRA EDUARDO. Apo.Sol.:LOPEZ-SORS ALONSO FERNANDO-JOAQUIN;LLOSENT DE NARDIZ MARIA DEL DULCE NOMBRE. Nombramientos.Apoderado: PONCE SANCHO JESUS. Datos registrales. T 27295 , F 37, S 8, H M 280762, I/A 46 (10.03.11).

14 de Febrero de 2011
Reelecciones. Adm. Unico: ASTRAZENECA FARMACEUTICA HOLDING SPAIN SA. Representan: HUDSON PAUL ASHLEY. Datosregistrales. T 27295 , F 34, S 8, H M 280762, I/A 44 ( 2.02.11).

Revocaciones. Apo.Manc.: MCTAVISH IAN. Apo.Sol.: MCTAVISH IAN. Nombramientos. Apoderado: PONZODA ALVAREZANA;PEREZ MUETE LYDIA;MARQUEZ ARIAS PALOMA;ENRIQUEZ AGUADO JORGE;ILARRAZ DE URZAIZ PILAR. Datosregistrales. T 27295 , F 34, S 8, H M 280762, I/A 45 ( 2.02.11).

13 de Julio de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FUCHS FEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Otros conceptos:SUBSANADO ERROR PADECIDO EN LA FECHA DE COMIENZO DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL APODERADO D.FEDERICO FUCHS, SIENDOLA CORRECTA LA DE 24 DE MARZO DE 2010, Y NO LA DE 1 DE OCTUBRE DE 2010. Datosregistrales. T 27295 , F 34, S 8, H M 280762, I/A 43 (30.06.10).

10 de Junio de 2010
Nombramientos. Apoderado: FUCHS FEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 27295 ,F 32, S 8, H M 280762, I/A 41 (28.05.10).

Revocaciones. Apo.Sol.: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS. Apo.Manc.: ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS.Nombramientos. Apoderado: MASSA MAZARRASA LUIS;PLAZA PIÑOL FEDERICO. Datos registrales. T 27295 , F 33, S 8, H M280762, I/A 42 (31.05.10).

24 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27295 , F 32, S 8, H M 280762, I/A 40 (12.02.10).

23 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27295 , F 31, S 8, H M 280762, I/A 39 (11.02.10).

14 de Enero de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FUCHSFEDERICO;MARGALET FERNANDEZ MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 17392 , F 225, S 8, H M 280762, I/A 38(29.12.09).

20 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Apo.Sol.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Nombramientos.Apo.Man.Soli: LLORENTE ALONSO GEMA. Datos registrales. T 17392 , F 225, S 8, H M 280762, I/A 37 ( 8.05.09).

28 de Abril de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: KUNTZE STEFAN. Apo.Sol.: KUNTZE STEFAN. Datos registrales. T 17392 , F 225, S 8, H M 280762,I/A 36 (17.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información