Buscador CIF Logo

Actos BORME Laboratorios Alcala Farma Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laboratorios Alcala Farma Sl

Actos BORME Laboratorios Alcala Farma Sl - B28059012

Tenemos registrados 40 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Laboratorios Alcala Farma Sl con CIF B28059012

馃敊 Perfil de Laboratorios Alcala Farma Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Laboratorios Alcala Farma Sl

10 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25044 , F 111, S 8, H M 82957, I/A 107 (31.12.21).

29 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: BRIOSO MENDAZA AMELIA. Datos registrales. T 25044 , F 110, S 8, H M 82957, I/A 106 (22.06.21).

12 de Enero de 2021
Revocaciones. Apoderado: SOTO MENGOTTI ALVARO;CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;CUMPLIDO TORVISOABIMAEL;BANZET PIERRE PHILIPPE. Nombramientos. Apoderado: YOUNG LOPEZ ELISA. Datos registrales. T 25044 , F 109, S8, H M 82957, I/A 105 ( 4.01.21).

17 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: BANZET PIERRE PHILIPPE. Nombramientos. Representan: VIELLE BRUCE JEAN MARC.Datos registrales. T 25044 , F 109, S 8, H M 82957, I/A 104 (10.09.19).

18 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25044 , F 109, S 8, H M 82957, I/A 103 ( 9.01.19).

30 de Noviembre de 2018
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: FARMYGEL SA. Datos registrales. T 25044 , F 107, S 8, H M 82957, I/A 102(23.11.18).

07 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: BANZET PIERRE PHILIPPE. Consejero: GROUPE SYNERLAB SAS;THIRION PATRICK RICHARDGEORGES;SOTO FERNANDEZ ALVARO. Presidente: GROUPE SYNERLAB SAS. Secretario: THIRION PATRICK RICHARDGEORGES. Vicepresid.: SOTO FERNANDEZ ALVARO. VsecrNoConsj: YOUNG LOPEZ ELISA. Nombramientos. Representan:BANZET PIERRE PHILIPPE. Adm. Unico: GROUPE SYNERLAB SAS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 25044 , F 106, S 8, H M 82957, I/A 101 (29.01.18).

18 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: BERNALDO DE QUIROS FRESNADILLO GONZALO. Datos registrales. T 25044 , F 105, S 8, H M82957, I/A 99 ( 5.12.17).

Nombramientos. Apoderado: YOUNG LOPEZ ELISA. Datos registrales. T 25044 , F 106, S 8, H M 82957, I/A 100 ( 5.12.17).

26 de Septiembre de 2017
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GROUPE SYNERLAB SAS. Datos registrales. T 25044 , F 105, S 8, H M 82957,I/A 98 (18.09.17).

07 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ YUNQUERA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 25044 , F 104, S 8, H M 82957, I/A 97(28.11.16).

26 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25044 , F 104,S 8, H M 82957, I/A 96 (18.01.16).

19 de Enero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.299.999,41 Euros. Resultante Suscrito: 10.406.499,67 Euros. Datos registrales. T 25044 , F 101,S 8, H M 82957, I/A 93 (11.01.16).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SOTO FERNANDEZ ALVARO. Nombramientos. VsecrNoConsj: YOUNG LOPEZ ELISA.Consejero: GROUPE SYNERLAB SAS;THIRION PATRICK RICHARD GEORGES;SOTO FERNANDEZ ALVARO. Presidente:GROUPE SYNERLAB SAS. Secretario: THIRION PATRICK RICHARD GEORGES. Representan: BANZET PIERRE PHILIPPE.Vicepresid.: SOTO FERNANDEZ ALVARO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo

Revocaciones. Apoderado: GOMEZ DOMINGO CARMEN;FERRERO BOLONIO LORENZO;PINILLA DE BLAS ANDRES;GRANDELOZANO CONSTANTINO;GOMEZ DOMINGO CARMEN;FERRERO BOLONIO LORENZO;CALVO ESCRIBANO JORGE;PINILLA DEBLAS ANDRES;GRANDE LOZANO CONSTANTINO. Apo.Manc.: FERRERO BOLONIO LORENZO;CALVO ESCRIBANOJORGE;PINILLA DE BLAS ANDRES;GRANDE LOZANO CONSTANTINO;SOTO MENGOTTI ALVARO;CALVENTE GARCIA JUANMANUEL. Apoderado: SEVILLA PINTO JOSE LEONARDO. Apo.Manc.: GONZALEZ ENSE脩AT JUANA;ROCABERT ORUSCOALFREDO. Apoderado: CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;GARCIA ATANCE MORALES VANESA;FERRERO BOLONIOLORENZO;PINILLA DE BLAS ANDRES;GRANDE LOZANO CONSTANTINO;LOPEZ ALVAREZ MANUEL;CALVENTE GARCIA JUANMANUEL. Apo.Sol.: SOTO MENGOTTI ALVARO. Apoderado: FERRER PUIG ENRIQUE;GONZALEZ ENSE脩AT JUANA;ESCUDERLARROSA CARLOS JAIME;SOTO FERNANDEZ ALVARO;CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;SOTO MENGOTTI ALVARO;GOMEZYUNQUERA MARIA ISABEL;SANZ SANCHEZ EDUARDO;CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;SOTO FERNANDEZ JOSEMARIA;BALLESTEROS CHERP GONZALO;SOTO MENGOTTI ALVARO;SOTO FERNANDEZ ALVARO;FERRERO BOLONIOLORENZO. Apo.Sol.: GONZALEZ ENSE脩AT JUANA;PAWLOWSKA MARZENA. Apoderado: SOTO MENGOTTI ALVARO CARLOS.Apo.Man.Soli: GARFIA GARCIA NOELIA. Apo.Manc.: CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;SOTO MENGOTTI ALVARO;SOTOFERNANDEZ ALVARO. Nombramientos. Apoderado: SOTO MENGOTTI ALVARO;CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;GOMEZYUNQUERA MARIA ISABEL;GARFIA GARCIA NOELIA;CUMPLIDO TORVISO ABIMAEL;BANZET PIERRE PHILIPPE;THIRIONPATRICK RICHARD GEORGES. Datos registrales. T 25044 , F 102, S 8, H M 82957, I/A 95 (11.01.16).

02 de Junio de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ ORUSCO ARTURO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARFIA GARCIA NOELIA. Apo.Manc.:CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;SOTO MENGOTTI ALVARO;SOTO FERNANDEZ ALVARO. Datos registrales. T 25044 , F100, S 8, H M 82957, I/A 92 (26.05.15).

20 de Marzo de 2014
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. AVDA DE MADRID 82 (ALCALADE HENARES). Datos registrales. T 25044 , F 99, S 8, H M 82957, I/A 91 (12.03.14).

19 de Marzo de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.500.000,12 Euros. Resultante Suscrito: 6.106.500,26 Euros. Datos registrales. T 25044, F 99, S 8, H M 82957, I/A 90 (12.03.14).

06 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: SOTO FERNANDEZ ALVARO;SOTO MENGOTTI ALVARO. Presidente: SOTO FERNANDEZALVARO. Secretario: SOTO MENGOTTI ALVARO. Consejero: FERRERO BOLONIO LORENZO. Cons.Del.Sol: SOTO FERNANDEZALVARO;FERRERO BOLONIO LORENZO. Nombramientos. Adm. Unico: SOTO FERNANDEZ ALVARO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Modificaci贸n articulo 30潞.- .Datos registrales. T 25044 , F 98, S 8, H M 82957, I/A 87 (29.01.14).

Revocaciones. Apoderado: BALLESTEROS CHERP GONZALO. Datos registrales. T 25044 , F 98, S 8, H M 82957, I/A 88(29.01.14).

Nombramientos. Apoderado: SOTO MENGOTTI ALVARO CARLOS. Datos registrales. T 25044 , F 98, S 8, H M 82957, I/A 89(29.01.14).

21 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: MORENO CALLE JORGE. Datos registrales. T 25044 , F 98, S 8, H M 82957, I/A 86 ( 7.11.12).

12 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: SANZ SANCHEZ EDUARDO;SOTO FERNANDEZ JOSE MARIA. Apo.Sol.: MORENO CALLE JORGE.Datos registrales. T 25044 , F 97, S 8, H M 82957, I/A 85 (29.10.12).

03 de Octubre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.500.000,38 Euros. Resultante Suscrito: 12.606.500,38 Euros. Datos registrales. T 25044 , F 97, S8, H M 82957, I/A 84 (24.09.12).

30 de Abril de 2012
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25044 , F 96, S 8, H M 82957, I/A 83 (18.04.12).

13 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GURIDI GARCIA FRANCISCO JAVIER;BARROSO ARAUZO OLGA. Vicepresid.: GURIDI GARCIAFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 25044 , F 96, S 8, H M 82957, I/A 82 (30.03.12).

02 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO CALLE JORGE;PAWLOWSKA MARZENA. Datos registrales. T 25044 , F 96, S 8, H M82957, I/A 81 (21.02.11).

17 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ ENSE脩AT JUANA;GONZALEZ ORUSCO ARTURO;MORENO CALLE JORGE. Datosregistrales. T 25044 , F 96, S 8, H M 82957, I/A 80 ( 2.02.11).

02 de Febrero de 2011
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25044 , F 95, S 8, H M 82957, I/A 79 (21.01.11).

11 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: CALVO ESCRIBANO JORGE. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ YUNQUERA MARIAISABEL;SANZ SANCHEZ EDUARDO;CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;SOTO FERNANDEZ JOSE MARIA;BALLESTEROSCHERP GONZALO;SOTO MENGOTTI ALVARO;SOTO FERNANDEZ ALVARO;FERRERO BOLONIO LORENZO. Datos registrales.T 25044 , F 95, S 8, H M 82957, I/A 78 (28.10.10).

21 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROCABERT ORUSCO ALFREDO. Nombramientos. Consejero: FERRERO BOLONIOLORENZO;GURIDI GARCIA FRANCISCO JAVIER;BARROSO ARAUZO OLGA. Vicepresid.: GURIDI GARCIA FRANCISCO JAVIER.Cons.Del.Sol: SOTO FERNANDEZ ALVARO;FERRERO BOLONIO LORENZO. Datos registrales. T 25044 , F 91, S 8, H M 82957,I/A 76 (10.05.10).

Revocaciones. Apo.Manc.: DIAZ CAPOTE JOSE LUIS. Apo.Sol.: PINILLA DE BLAS ANDRES. Apoderado: SOTO MENGOTTIALVARO;CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;PINILLA DE BLAS ANDRES;FERRERO BOLONIO LORENZO;SOTO FERNANDEZJOSE MARIA;DIAZ CAPOTE JOSE LUIS;CALVO ESCRIBANO JORGE. Nombramientos. Apoderado: SANZ SANCHEZEDUARDO;CALVENTE GARCIA JUAN MANUEL;CALVO ESCRIBANO JORGE;SOTO FERNANDEZ JOSE MARIA;BALLESTEROSCHERP GONZALO;SOTO MENGOTTI ALVARO. Datos registrales. T 25044 , F 92, S 8, H M 82957, I/A 77 (10.05.10).

28 de Agosto de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARROSO ARAUZO OLGA. Datos registrales. T 25044 , F 90, S 8, H M 82957, I/A 73 (19.08.09).

Nombramientos. Apoderado: CALVO ESCRIBANO JORGE. Otros conceptos: Se ha modificado el poder conferido en Escrituraautorizadapor el Notario de Madrid, Don Juan Carlos Caballer铆a G贸mez,el d铆a 29 de Diciembre de 2006, con el n煤mero 4284/2006 desu Protocolo, que origin贸 la Inscripci贸n 59& en la Hoja social.- Datos registrales. T 25044 , F 90, S 8, H M 82957, I/A 74 (19.08.09).

Revocaciones. Apoderado: ESCUDER LARROSA CARLOS JAIME. Apo.Manc.: ESCUDER LARROSA CARLOS JAIME. Apoderado:HANSMANN JOHANN;HANSMANN JOHANN. Datos registrales. T 25044 , F 91, S 8, H M 82957, I/A 75 (19.08.09).

10 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ SAN JULIAN GUTIERREZ MARTA;GRANDE LOZANO CONSTANTINO;GRANDELOZANO CONSTANTINO. Datos registrales. T 25044 , F 89, S 8, H M 82957, I/A 71 (28.05.09).

Revocaciones. Apoderado: DIAZ CAPOTE JOSE LUIS;ROCABERT ORUSCO ALFREDO. Nombramientos. Apoderado: DIAZCAPOTE JOSE LUIS. Datos registrales. T 25044 , F 90, S 8, H M 82957, I/A 72 (28.05.09).

11 de Marzo de 2009
Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 25044 , F 86, S 8, H M 82957, I/A 70 (27.02.09).

04 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apoderado: SOTO FERNANDEZ ALVARO;HANSMANN JOHANN. Otros conceptos: MODIFICADA LAINSCRIPCION 59& EN CUANTO A LA FORMA DE ACTUACION DE LAS FACULTADES 3&,4& Y 5&. Datos registrales. T 25044 , F86, S 8, H M 82957, I/A 69 (23.02.09).

02 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ROCABERT BIELSA JOSE RAMON;SOTO FERNANDEZ ALVARO. Nombramientos.Consejero: BARROSO ARAUZO OLGA;ROCABERT ORUSCO ALFREDO;SOTO FERNANDEZ ALVARO;SOTO MENGOTTIALVARO. Presidente: SOTO FERNANDEZ ALVARO. Secretario: SOTO MENGOTTI ALVARO. Apoderado: HANSMANN JOHANN.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n.Datos registrales. T 25044 , F 86, S 8, H M 82957, I/A 68 (19.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n