Actos BORME de Laboratorios Beecham Sa
02 de Julio de 2012Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 23981 , F 18, S 8, H M 120048, I/A 147 (20.06.12).
30 de Mayo de 2012Reelecciones. Consejero: PEREZ SANTOS JUAN MANUEL. Datos registrales. T 23981 , F 17, S 8, H M 120048, I/A 146(18.05.12).
24 de Agosto de 2011Reelecciones. Consejero: PARIS VICENTE GONZALO;COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL. Secretario: COLLDEFORSMARTINEZ JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 23981 , F 17, S 8, H M 120048, I/A 144 (10.08.11).
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ FUENTES JORGE. Nombramientos. Apoderado: GARCIA-SOTO RETUERTAROBERTO;MARIN GALLARDO CONCEPCION JULIA. Datos registrales. T 23981 , F 17, S 8, H M 120048, I/A 145 (10.08.11).
11 de Julio de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: MU脩OZ FUENTES JORGE. Nombramientos. Apo.Sol.: PELAEZ DELGADO SILVIA. Datos registrales.T 23981 , F 16, S 8, H M 120048, I/A 143 (29.06.11).
02 de Marzo de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Apo.Manc.: PORTAL MARTINEZPERFECTO. Apoderado: PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Nombramientos. Apoderado: MORALES MENENDEZ EVA;BECKERRUDIGER;PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;MORALES MENENDEZEVA;BECKER RUDIGER;COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PEREZ SANTOS JUANMANUEL;RAMOS GAYTAN EDUARDO;PARIS VICENTE GONZALO;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;MORALES MENENDEZEVA;BECKER RUDIGER;PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;GOMEZFERNANDEZ CONSUELO;PELAEZ DELGADO SILVIA;BECKER RUDIGER;COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;FERNANDEZGONZALEZ CRISTINA;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Datos registrales. T 23981 , F 14, S 8,H M 120048, I/A 142 (16.02.11).
10 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: CADORNIGA MAO JOSE. Apoderado: CADORNIGA MAO JOSE;CADORNIGA MAO JOSE;TARRIZAMARTINEZ JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ ALVARO MARIA DEL VAL. Datos registrales. T 23981 , F 14, S 8, H M120048, I/A 141 (26.11.10).
26 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ JARAMILLO ALICIA;PEREZ DOMINGUEZ ANA FLORA. Datos registrales. T 23981 , F 13, S8, H M 120048, I/A 140 (13.10.10).
14 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: CHILVER-STAINER SARAH JANE. Datos registrales. T 23981 , F 12, S 8, H M 120048, I/A 139(30.09.10).
04 de Agosto de 2010Revocaciones. Apoderado: DE PRADO GARCIA SUSANA;DE PRADO GARCIA SUSANA. Nombramientos. Apoderado: FERREREVUELTA MERCEDES. Datos registrales. T 23981 , F 12, S 8, H M 120048, I/A 138 (26.07.10).
22 de Enero de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN BOADO ANA MARIA. Nombramientos. Apoderado: ORTEGA BASAGOITI RAFAEL;PORTALMARTINEZ PERFECTO;FERNANDEZ GONZALEZ CRISTINA;CARDENAL IRADIER MARIA. Datos registrales. T 23981 , F 11, S 8,H M 120048, I/A 137 (12.01.10).
01 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apoderado: DAL-RE SAAVEDRA RAFAEL. Datos registrales. T 23981 , F 11, S 8, H M 120048, I/A 136 (19.11.09).
11 de Agosto de 2009Revocaciones. Apoderado: FERRERO LOPEZ RAFAEL;FERRERO LOPEZ RAFAEL. Apo.Man.Soli: FERRERO LOPEZ RAFAEL.Apo.Sol.: LUZ MORENO JUAN PEDRO. Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;GOMEZ FERNANDEZCONSUELO. Datos registrales. T 23981 , F 9, S 8, H M 120048, I/A 135 (31.07.09).
17 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA. Datos registrales. T 23981 , F 9, S 8, H M 120048, I/A 133 ( 5.06.09).
Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;JIMENEZ COLETO JOSEFA;CALVO ALONSO DANIEL;TARRIZAMARTINEZ JOSE;REDONDO NIETO JULIAN;PARIS VICENTE GONZALO;PEREZ ESCOLANO ISABEL;DE PRADO GARCIASUSANA. Datos registrales. T 23981 , F 9, S 8, H M 120048, I/A 134 ( 5.06.09).
27 de Marzo de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: LAGUNA MENA JOSE LUIS. Datos registrales. T 23981 , F 9, S 8, H M 120048, I/A 132 (12.03.09).
03 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL. Datos registrales. T23981 , F 8, S 8, H M 120048, I/A 131 (20.02.09).