Actos BORME de Laboratorios Conda Sa
25 de Octubre de 2023Revocaciones. Apoderado: GALATAS ROVIRA JUAN LUIS;VALDECANTOS GARCIA FLORES JESUS;GONZALEZ MOLINUEVOJESUS ENRIQUE. Apo.Manc.: PRIETO LOPEZ ALVARO;LIRA GARCIA JUSTA;GONZALEZ MARTINEZ SONSOLES;SANCHEZ DELA NIETA REDONDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 44147 , F 64, S 8, H M 106181, I/A 105 (18.10.23).
21 de Julio de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AMERIND INVESTMENT INC. Datos registrales. T 44147 , F 63, S 8, H M 106181,I/A 103 (15.07.23).
Nombramientos. Apo.Manc.: PRIETO LOPEZ ALVARO;LIRA GARCIA JUSTA;GONZALEZ MARTINEZ SONSOLES;NAVARROGONZALEZ MARIA. Datos registrales. T 44147 , F 64, S 8, H M 106181, I/A 104 (15.07.23).
27 de Diciembre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.001.181,86 Euros. Resultante Suscrito: 5.051.765,60 Euros. Datos registrales. T 44147, F 63, S 8, H M 106181, I/A 102 (19.12.22).
04 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 31, S 8, H M 106181, I/A 101(27.10.22).
15 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: HERNANDO SANZ MONTSERRAT. Datos registrales. T 25461 , F 31, S 8, H M 106181, I/A 100 (8.03.22).
10 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: PRIETO LOPEZ ALVARO;LIRA GARCIA JUSTA;GONZALEZ MARTINEZ SONSOLES. Datosregistrales. T 25461 , F 30, S 8, H M 106181, I/A 98 ( 3.02.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: PRIETO LOPEZ ALVARO;LIRA GARCIA JUSTA;GONZALEZ MARTINEZ SONSOLES;SANCHEZ DELA NIETA REDONDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 25461 , F 31, S 8, H M 106181, I/A 99 ( 3.02.22).
31 de Diciembre de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.001.181,86 Euros. Resultante Suscrito: 6.052.947,46 Euros. Datos registrales. T 25461, F 30, S 8, H M 106181, I/A 97 (24.12.21).
19 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: GALATAS MARTINEZ MARIA LUISA. Presidente: GALATAS MARTINEZ MARIA LUISA. Consejero:PRIETO LOPEZ ALVARO. Secretario: PRIETO LOPEZ ALVARO. Cons.Del.Sol: GALATAS MARTINEZ MARIA LUISA;PRIETO LOPEZALVARO. Consejero: GALATAS MARTINEZ PABLO. Cons.Del.Sol: GALATAS MARTINEZ PABLO. Nombramientos. Consejero:GALATAS MARTINEZ MARIA LUISA;PRIETO LOPEZ ALVARO;GALATAS MARTINEZ PABLO. Cons.Del.Sol: GALATAS MARTINEZMARIA LUISA;GALATAS MARTINEZ PABLO;PRIETO LOPEZ ALVARO. Presidente: GALATAS MARTINEZ MARIA LUISA. Secretario:PRIETO LOPEZ ALVARO. Datos registrales. T 25461 , F 29, S 8, H M 106181, I/A 96 (12.08.20).
12 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ DE ISLA ALONSO RAMON. Cons.Del.Sol: PEREZ DE ISLA ALONSO RAMON.Nombramientos. Consejero: GALATAS MARTINEZ PABLO. Cons.Del.Sol: GALATAS MARTINEZ PABLO. Datos registrales. T25461 , F 29, S 8, H M 106181, I/A 95 ( 5.06.20).
04 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 29, S 8, H M 106181, I/A 94(27.11.19).
05 de Septiembre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 908.104,99 Euros. Resultante Suscrito: 7.054.129,32 Euros. Datos registrales. T 25461 ,F 28, S 8, H M 106181, I/A 93 (29.08.19).
23 de Enero de 2019Otros conceptos: RECTIFICADA LA ESCRITURA QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 90陋, EN CUANTO A LA CIFRA DEL AUMENTODE CAPITAL SOCIAL, SIENDO LO CORRECTO QUE EL CAPITAL SOCIAL SE AMPLIO EN 597.363,95 E, QUEDANDO FIJADO ELMISMO EN LA CANTIDAD DE 7.962.234,31 E. Datos registrales. T 25461 , F 27, S 8, H M 106181, I/A 92 (16.01.19).
18 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 27, S 8, H M 106181, I/A 91(11.12.18).
15 de Octubre de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.150.001,48 Euros. Desembolsado: 1.150.001,48 Euros. Resultante Suscrito: 8.514.871,84 Euros.Resultante Desembolsado: 8.514.871,84 Euros. Datos registrales. T 25461 , F 26, S 8, H M 106181, I/A 90 ( 5.10.18).
31 de Agosto de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 830.882,50 Euros. Resultante Suscrito: 7.364.870,36 Euros. Datos registrales. T 25461 ,F 25, S 8, H M 106181, I/A 89 (24.08.18).
05 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 25, S 8, H M 106181, I/A 88(27.12.17).
12 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 24, S 8, H M 106181, I/A 87 (3.01.17).
19 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 24, S 8, H M 106181, I/A 86(11.01.16).
12 de Agosto de 2015P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.condalab.com. Datos registrales. T 25461 , F 24, S 8, HM 106181, I/A 85 ( 4.08.15).
13 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 24, S 8, H M 106181, I/A 84 (2.01.15).
12 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GALATAS MARTINEZ CRISTINA. Nombramientos. Consejero: GALATAS MARTINEZ MARIALUISA. Presidente: GALATAS MARTINEZ MARIA LUISA. Consejero: PRIETO LOPEZ ALVARO. Secretario: PRIETO LOPEZALVARO. Consejero: PEREZ DE ISLA ALONSO RAMON. Cons.Del.Sol: PEREZ DE ISLA ALONSO RAMON;GALATAS MARTINEZMARIA LUISA;PRIETO LOPEZ ALVARO. Modificaciones estatutarias. COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ORGANO DEADMINISTRACION, SE HAN MODIFICADO LOS ARTICULOS 26, 27, 28 Y 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 25461 , F 23, S 8, H M106181, I/A 83 ( 2.09.14).
08 de Septiembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 802.377,07 Euros. Desembolsado: 802.377,07 Euros. Resultante Suscrito: 8.195.752,86 Euros.Resultante Desembolsado: 8.195.752,86 Euros. Datos registrales. T 25461 , F 23, S 8, H M 106181, I/A 82 (29.08.14).
04 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: VEGA ALONSO FELIX;VEGA ALONSO FELIX;VAZQUEZ GOMEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T25461 , F 23, S 8, H M 106181, I/A 81 (24.01.14).
24 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 22, S 8, H M 106181, I/A 80(16.01.14).
04 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apoderado: DIEGO LASTRA MANUELA. Apo.Manc.: DIEGO LASTRA MANUELA;ABRIL SANCHIDRIAN MARIADOLORES;PRIETO LOPEZ ALVARO. Datos registrales. T 25461 , F 22, S 8, H M 106181, I/A 79 (23.10.13).
22 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: PRIETO LOPEZ ALVARO;LIRA GARCIA JUSTA;GONZALEZ MARTINEZ SONSOLES;HERNANDOSANZ MONTSERRAT. Datos registrales. T 25461 , F 21, S 8, H M 106181, I/A 78 (12.08.13).
20 de Agosto de 2013Cambio de domicilio social. C/ LA FORJA 9 (TORREJON DE ARDOZ). Datos registrales. T 25461 , F 21, S 8, H M 106181, I/A 77(12.08.13).
27 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 21, S 8, H M 106181, I/A 76(19.02.13).
18 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 21, S 8, H M 106181, I/A 75 (5.01.12).
22 de Febrero de 2011Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 21, S 8, H M 106181, I/A 74(10.02.11).
18 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIEGO LASTRA MANUELA. Nombramientos. Adm. Unico: GALATAS MARTINEZ CRISTINA.Datos registrales. T 25461 , F 20, S 8, H M 106181, I/A 73 ( 5.01.11).
17 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MOLINUEVO JESUS ENRIQUE. Datos registrales. T 25461 , F 20, S 8, H M 106181, I/A72 ( 5.03.10).
24 de Septiembre de 2009Nombramientos. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 25461 , F 20, S 8, H M 106181, I/A 71(14.09.09).