Actos BORME de Laboratorios Farmaceuticos Valomed Sa
13 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ MILLAN JAIME. Apoderado: NIETO MAGRO CONCEPCION;MAS GARCIA ENCARNACION.Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARJA DE SOROA PALOMA. Apo.Manc.: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETEJAVIER. Apo.Man.Soli: NOMBELA GORDO LEONOR ELENA;PRESEDO HUETE JAVIER. Apo.Manc.: ACEBRON FERNANDEZALVARO;GARCIA MARIN JOSE. Reelecciones. Consejero: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Datos registrales. T 23322 , F223, S 8, H M 200128, I/A 39 ( 6.03.23).
23 de Diciembre de 2022Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 222, S 8, H M 200128, I/A 38 (16.12.22).
25 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ LOPEZ CELIA;NOVA NOVA MYRIAM;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDOHUETE JAVIER. Datos registrales. T 23322 , F 222, S 8, H M 200128, I/A 37 (18.05.22).
15 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 221, S 8, H M 200128,I/A 36 ( 7.10.21).
13 de Agosto de 2021Revocaciones. Apoderado: MOSCOSO DEL PRADO JAIME. Reelecciones. Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTISFRANCESCO. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Modificaciones estatutarias. Creación de los artículos19 bis y 27 bis de los estatutos sociales. Datos registrales. T 23322 , F 221, S 8, H M 200128, I/A 35 ( 6.08.21).
15 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: DELGADO ALONSO ALEJANDRO. Nombramientos. Apo.Sol.: D`ANTUONOMARGHERITA;FERNANDEZ MILLAN JAIME. Datos registrales. T 23322 , F 220, S 8, H M 200128, I/A 34 ( 8.04.21).
09 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 220, S 8, H M 200128,I/A 33 ( 2.10.20).
22 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: PRESEDO HUETE JAVIER;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA.Datos registrales. T 23322 , F 220, S 8, H M 200128, I/A 32 (15.11.19).
06 de Septiembre de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 219, S 8, H M 200128,I/A 31 (30.08.19).
22 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: SAENZ ESPINOSA JOSEANTONIO. Apo.Man.Soli: GARCIA MARIN JOSE. Apoderado: RODRIGUEZ FLORES JOSE. Apo.Man.Soli: ACEBRON FERNANDEZALVARO;NIETO MAGRO CONCEPCION. Apo.Manc.: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: PRESEDOHUETE JAVIER. Apoderado: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER;RODRIGUEZ BELTRANTERESA;GARCIA MARIN JOSE;NIETO MAGRO CONCEPCION;MAS GARCIA ENCARNACION;ALEMAN TAISMA JOSE;MOSCOSODEL PRADO JAIME;AGUILERA GIMENEZ JOSE MANUEL;CAROLA ROSES SANTIAGO;DELGADO ALONSO ALEJANDRO. Datosregistrales. T 23322 , F 216, S 8, H M 200128, I/A 30 (14.05.19).
17 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: DE EMBRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA. Modificaciones estatutarias. Modificado elartículo 25º. Datos registrales. T 23322 , F 214, S 8, H M 200128, I/A 29 ( 9.08.18).
23 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO.Nombramientos. Consejero: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Datos registrales. T 23322 , F 214, S 8, H M 200128, I/A 28(13.03.18).
11 de Noviembre de 2016Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 213, S 8, H M 200128,I/A 26 (28.10.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ CAMPILLO RAQUEL;DOMENECH CIANCAS JOSE MIGUEL;FERNANDEZ ESCRIBANOFERNANDEZ JOAQUIN IGNACIO. Datos registrales. T 23322 , F 214, S 8, H M 200128, I/A 27 (28.10.16).
27 de Octubre de 2016Reelecciones. Secretario: ENSEÑAT BENLLIURE JAIME LUIS. Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO;SAENZESPINOSA JOSE ANTONIO;SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO.Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Datos registrales. T 23322 , F 213, S 8, H M 200128, I/A 24 (18.10.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: PUIG-DURAN FRESCO RAFAEL. Datos registrales. T 23322 , F 213, S 8, H M 200128, I/A 25 (18.10.16).
15 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 212, S 8, H M 200128, I/A 23 ( 7.10.15).
20 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 212, S 8, H M 200128, I/A 22 ( 9.01.15).
07 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 212, S 8, H M 200128, I/A 21 (27.12.13).
10 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 212, S 8, H M 200128, I/A 20 (28.11.12).
15 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 212, S 8, H M 200128, I/A 19 ( 2.12.11).
22 de Septiembre de 2011Reelecciones. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Consejero: DIAVERICO MARIA DE SANTISFRANCESCO;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;SCIALDONE SAVERIO. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO. Secretario:ENSEÑAT BENLLIURE JAIME LUIS. Datos registrales. T 23322 , F 211, S 8, H M 200128, I/A 18 (13.09.11).
18 de Enero de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 211, S 8, H M 200128, I/A 17 ( 5.01.11).
24 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: BANFI TOSI BEATRIZ. Nombramientos. Apoderado: BANFI TOSI BEATRIZ. Datos registrales. T23322 , F 210, S 8, H M 200128, I/A 16 (11.03.10).
09 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23322 , F 210, S 8, H M 200128, I/A 15 (26.11.09).