Buscador CIF Logo

Actos BORME Laboratorios Servier Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laboratorios Servier Sl

Actos BORME Laboratorios Servier Sl - B28184687

Tenemos registrados 49 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Laboratorios Servier Sl con CIF B28184687

馃敊 Perfil de Laboratorios Servier Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Laboratorios Servier Sl

25 de Septiembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: LEFEBVRE MAXIME. Datos registrales. T 32224 , F 210, S 8, H M 81205, I/A 95 (18.09.23).

30 de Mayo de 2023
Reelecciones. Adm. Solid.: BELLOIR GILLES POL;DEBAILLON-VESQUE FRANCOIS JACQUES ANDRE MARCEL. Datos

Revocaciones. Apoderado: LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;DEBAILLON-VESQUEFRANCOIS JACQUES ANDRE MARCEL;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE;GAUBIL CATHERINE JOSEPHINE. Nombramientos.Apo.Manc.: ANDRIOT PIERRE JEAN BERNARD. Apo.Man.Soli: DEBAILLON-VESQUE FRANCOIS JACQUES ANDREMARCEL;CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Apo.Manc.: GAUBIL CATHERINE JOSEPHINE.Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32224 , F 209, S 8, H M81205, I/A 94 (23.05.23).

17 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apoderado: LEFEBVRE MAXIME. Datos registrales. T 32224 , F 207, S 8, H M 81205, I/A 91 ( 7.10.22).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GOMEZ CONRADO. Datos registrales. T 32224 , F 208, S 8, H M 81205, I/A 92 ( 7.10.22).

23 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;GONZALEZ MADRID MARIA VICTORIA;NICOLAS ARTEROMARIA AINHOA;MOLINIER VIRGINIE;AMBROS BIERN CLAUDIA;DE ISABEL ESTRADA ANA;ITRIAGO VISO MARINA;MOLINAGARCIA-VAQUERO JULIA;RAMIREZ BELLOCH BLANCA. Datos registrales. T 32224 , F 207, S 8, H M 81205, I/A 90 (16.09.22).

15 de Julio de 2022
Otros conceptos: Ampliadas la facultades bancarias que causaron la inscripci贸n 87陋 de esta hoja social. Datos registrales. T 32224, F 206, S 8, H M 81205, I/A 89 ( 8.07.22).

27 de Junio de 2022
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32224 , F 206, S 8, H M81205, I/A 88 (20.06.22).

29 de Abril de 2022
Nombramientos. Apoderado: LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;DEBAILLON-VESQUE FRANCOIS JACQUES ANDRE MARCEL;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE;GAUBIL CATHERINE JOSEPHINE. Datosregistrales. T 32224 , F 206, S 8, H M 81205, I/A 87 (23.04.22).

21 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: VENESQUE PIERRE CHARLES LOUIS. Presidente: VENESQUE PIERRE CHARLES LOUIS.Consejero: GAUDRON SYLVAIN OLIVIER GUY LOUIS;FEDRIGO REGIS;LAMARCHE VINCENT MARIE DENIS JEAN.SecreNoConsj: CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: BELLOIR GILLES POL;DEBAILLON-VESQUEFRANCOIS JACQUES ANDRE MARCEL. Modificaciones estatutarias. Derogaci贸n de los Estatutos Sociales y aprobaci贸n denuevos Estatutos Sociales. Datos registrales. T 32224 , F 202, S 8, H M 81205, I/A 86 (14.03.22).

28 de Julio de 2021
Reelecciones. Consejero: LAMARCHE VINCENT MARIE DENIS JEAN. Datos registrales. T 32224 , F 201, S 8, H M 81205, I/A 84(21.07.21).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32224 , F 202, S 8, H M81205, I/A 85 (21.07.21).

03 de Septiembre de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32224 , F 201, S 8, H M81205, I/A 82 (26.08.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BODINEAU EMERIC MARC;VILETTE FRANCOIS ALBERT HENRI. Nombramientos. Consejero:GAUDRON SYLVAIN OLIVIER GUY LOUIS;FEDRIGO REGIS. Datos registrales. T 32224 , F 201, S 8, H M 81205, I/A 83 (26.08.20).

04 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;SABATER TORRES FRANCISCO JAVIER;LUCAS ESTEBANARTURO. Datos registrales. T 32224 , F 200, S 8, H M 81205, I/A 81 (28.07.20).

14 de Julio de 2020
Reelecciones. SecreNoConsj: CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS. Datos registrales. T 32224 , F 200, S 8, H M 81205, I/A 80 (7.07.20).

17 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS. Presidente: SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS. Nombramientos.Consejero: VENESQUE PIERRE CHARLES LOUIS. Presidente: VENESQUE PIERRE CHARLES LOUIS. Datos registrales. T 32224, F 200, S 8, H M 81205, I/A 79 (10.12.19).

25 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Cons.Del.Sol: VILETTE FRANCOIS ALBERT HENRI. Datos registrales. T 32224 , F 199, S 8, H M 81205, I/A 77(18.09.19).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Cons.Del.Sol: VILETTE FRANCOIS ALBERT HENRI. Reelecciones. Auditor: ERNST& YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Consejero: SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS. Presidente: SAUVEUR CHRISTIANLOUIS. Consejero: BODINEAU EMERIC MARC;LAMARCHE VINCENT MARIE DENIS JEAN;VILETTE FRANCOIS ALBERT HENRI.Datos registrales. T 32224 , F 199, S 8, H M 81205, I/A 78 (18.09.19).

03 de Agosto de 2018
Nombramientos. Cons.Del.Sol: VILETTE FRANCOIS ALBERT HENRI. Datos registrales. T 32224 , F 198, S 8, H M 81205, I/A 76(27.07.18).

27 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: VILETTE FRANCOIS ALBERT HENRI. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LAINSCRIPCION 74陋 LA PUBLICACION DEL CESE DE VILETTE FRANCOIS ALBERT HENRI COMO CONSEJERO DELEGADO.Datos registrales. T 32224 , F 197, S 8, H M 81205, I/A 24 (20.04.18).

25 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DEL CASTILLO CASAS FEDERICO. Nombramientos. SecreNoConsj: CONEJERO GONZALEZPEDRO LUIS. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32224 , F198, S 8, H M 81205, I/A 75 (18.04.18).

19 de Junio de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Consejero: SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS.Presidente: SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS. Consejero: BODINEAU EMERIC MARC;LAMARCHE VINCENT MARIE DENISJEAN;VILETTE FRANCOIS ALBERT HENRI. SecreNoConsj: DEL CASTILLO CASAS FEDERICO. Datos registrales. T 32224 , F197, S 8, H M 81205, I/A 74 ( 8.06.17).

14 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: FEDRIGO REGIS. Otros conceptos: revocados los poderes "bancarios y ante administracionesTributarias de Don Stephane Olivier Mascarau", con NIE X2939556H, que constan en la inscripci贸n 69陋 de la hoja social, con efectosde 1 de febrero de 2017. Datos registrales. T 32224 , F 195, S 8, H M 81205, I/A 72 ( 6.03.17).

Revocaciones. Apoderado: CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;GOROSTIAGA AYESTARAN CARMEN;FERNANDEZ ALGARRAENRIQUE. Nombramientos. Apoderado: LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;FEDRIGO REGIS;CONEJERO GONZALEZPEDRO LUIS;GOROSTIAGA AYESTARAN CARMEN;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Otros conceptos: revocados los poderes"bancarios y ante administraciones Tributarias de Don Oliver Jacques Gerard Laureau", con NIE Y2651785Z, que constan en lainscripci贸n 69陋 de la hoja social, con efectos de 1 de febrero de 2017. Datos registrales. T 32224 , F 196, S 8, H M 81205, I/A 73 (6.03.17).

21 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: GAUBIL CATHERINE JOSEPHINE. Datos registrales. T 32224 , F 194, S 8, H M 81205, I/A 71(13.02.17).

23 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GAUSSENS WILLIAM JACQUES GEORGES. Con.Delegado: GAUSSENS WILLIAM JACQUESGEORGES. Nombramientos. Consejero: VILETTE FRANCOIS ALBERT HENRI. Con.Delegado: VILETTE FRANCOIS ALBERTHENRI. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. SecreNoConsj: DEL CASTILLO CASASFEDERICO. Datos registrales. T 32224 , F 194, S 8, H M 81205, I/A 70 (14.09.16).

06 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apoderado: VILAGINES OLIVIER;LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;CONEJERO GONZALEZ PEDROLUIS;GOROSTIAGA AYESTARAN CARMEN;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Nombramientos. Apoderado: MASCARAUSTEPHANE OLIVIER;LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;GOROSTIAGA AYESTARANCARMEN;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Otros conceptos: Revocados los poderes bancarios y ante administracionestributarias; y los poderes de gesti贸n y representaci贸n a don Olivier Vilagines, conferidos en la inscripci贸n 64&. Datos registrales. T32224 , F 192, S 8, H M 81205, I/A 69 (25.09.15).

12 de Mayo de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32224 , F 192, S 8, H M81205, I/A 68 ( 5.05.15).

06 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS;LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;GAUSSENS WILLIAMJACQUES GEORGES. Presidente: SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS. Con.Delegado: GAUSSENS WILLIAM JACQUES GEORGES.Consejero: BAZANTAY CHRISTIAN HENRY. Nombramientos. Consejero: SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS. Presidente: SAUVEURCHRISTIAN LOUIS. Consejero: BODINEAU EMERIC MARC;LAMARCHE VINCENT MARIE DENIS JEAN;GAUSSENS WILLIAMJACQUES GEORGES. Con.Delegado: GAUSSENS WILLIAM JACQUES GEORGES. Reelecciones. SecreNoConsj: DEL CASTILLOCASAS FEDERICO. Datos registrales. T 32224 , F 191, S 8, H M 81205, I/A 67 (26.02.15).

10 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: VILAGINES OLIVIER. Datos registrales. T 32224 , F 190, S 8, H M 81205, I/A 66 ( 2.09.14).

16 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: SETA JEAN PHILIPPE;CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;POLO URANGA ELENA;GOROSTIAGAAYESTARAN CARMEN;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Nombramientos. Apoderado: LAUREAU OLIVIER JACQUESGERARD;CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;GOROSTIAGA AYESTARAN CARMEN;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Otrosconceptos: Revocado el poder bancario y ante Administraciones Tributarias a DON OLIVIER VILAGINES. Se Mantiene el poder deGesti贸n y representaci贸n a DON OLIVIER VILAGINES de la inscripci贸n 61&. Datos registrales. T 19292 , F 219, S 8, H M 81205, I/A64 ( 6.05.14).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32224 , F 190, S 8, H M

30 de Mayo de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19292 , F 219, S 8, H M81205, I/A 63 (23.05.13).

18 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ ANGE. Presidente: DIAZ ANGE. Consejero: COURTOIS PATRICE;FARALDO PIERRE ANDRE.Con.Delegado: FARALDO PIERRE ANDRE. Secretario: DEL CASTILLO CASAS FEDERICO. Nombramientos. Consejero:SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS;LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;GAUSSENS WILLIAM JACQUES GEORGES. Presidente:SAUVEUR CHRISTIAN LOUIS. Con.Delegado: GAUSSENS WILLIAM JACQUES GEORGES. SecreNoConsj: FEDERICO DELCASTILLO CASAS. Reelecciones. Consejero: BAZANTAY CHRISTIAN HENRY. Otros conceptos: LIMITADA LAS FACULTADESDEL CONSEJERO DELEGADO. Datos registrales. T 19292 , F 218, S 8, H M 81205, I/A 62 (10.12.12).

27 de Marzo de 2012
Revocaciones. Apoderado: PRADERE EMMANUEL JEAN JACQUES;LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;SETA JEANPHILIPPE;CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;POLO URANGA ELENA;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Nombramientos.Apoderado: VILAGINES OLIVIER;LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;SETA JEAN PHILIPPE;CONEJERO GONZALEZ PEDROLUIS;POLO URANGA ELENA;GOROSTIAGA AYESTARAN CARMEN;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Datos registrales. T19292 , F 216, S 8, H M 81205, I/A 61 (14.03.12).

08 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19292 , F 216, S 8, H M

28 de Octubre de 2011
Otros conceptos: Queda subsanada la inscripci贸n 56& de la Hoja Social, en cuanto al DNI del apoderado Do帽a Carmen GorostiagaAyestaran, siendo el correcto "15829818-E".- Datos registrales. T 19292 , F 216, S 8, H M 81205, I/A 59 (13.10.11).

28 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19292 , F 216, S 8, H M81205, I/A 58 (16.09.11).

21 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Secretario: DEL CASTILLO CASAS FEDERICO. Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCRITURA QUECAUSO LA INSCRIPCION 53&, UNICAMENTE EN CUANTO A LA RENOVACION DEL SECRETARIO NO CONSEJERO. Datosregistrales. T 19292 , F 215, S 8, H M 81205, I/A 57 ( 8.09.11).

10 de Agosto de 2011
Nombramientos. Apoderado: GOROSTIAGA AYESTARAN CARMEN. Datos registrales. T 19292 , F 215, S 8, H M 81205, I/A 56(28.07.11).

10 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: POLO URANGA MARIA ELENA. Reelecciones. Consejero: DIAZ ANGE. Presidente: DIAZ ANGE.Consejero: COURTOIS PATRICE;BAZANTAY CHRISTIAN HENRY;FARALDO PIERRE ANDRE. Con.Delegado: FARALDO PIERREANDRE. Datos registrales. T 19292 , F 212, S 8, H M 81205, I/A 53 (23.08.10).

Nombramientos. Apoderado: CONEJERO GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 19292 , F 213, S 8, H M 81205, I/A 54(23.08.10).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ BALSA ENRIQUE. Datos registrales. T 19292 , F 214, S 8, H M 81205, I/A 55(23.08.10).

20 de Abril de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19292 , F 212, S 8, H M81205, I/A 52 ( 9.04.10).

22 de Octubre de 2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FARALDO PIERRE ANDRE;LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;SETA JEANPHILIPPE;CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;POLO URANGA ELENA;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Nombramientos.Apoderado: PRADERE EMMANUEL JEAN JACQUES;LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;SETA JEAN PHILIPPE;CONEJEROGONZALEZ PEDRO LUIS;POLO URANGA ELENA;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Datos registrales. T 19292 , F 210, S 8, H M81205, I/A 51 ( 9.10.09).

07 de Julio de 2009
Nombramientos. Con.Delegado: FARALDO PIERRE ANDRE. Datos registrales. T 19292 , F 210, S 8, H M 81205, I/A 50(25.06.09).

04 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: MOUGEOTTE DOMINIQUE GEORGE LOUIS;SETA JEAN PHILIPPE;CONEJERO GONZALEZ PEDROLUIS;CAMPUZANO GUERRERO JOSE RAMON;POLO URANGA ELENA;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE;MORIER FREDERICMARTIAL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FARALDO PIERRE ANDRE;LAUREAU OLIVIER JACQUES GERARD;SETA JEANPHILIPPE;CONEJERO GONZALEZ PEDRO LUIS;POLO URANGA ELENA;FERNANDEZ ALGARRA ENRIQUE. Datos registrales. T19292 , F 208, S 8, H M 81205, I/A 49 (26.05.09).

24 de Abril de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 19292 , F 208, S 8, H M81205, I/A 48 (14.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n