Buscador CIF Logo

Actos BORME Laboratorios Syva Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laboratorios Syva Sa

Actos BORME Laboratorios Syva Sa - A78633856

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Laboratorios Syva Sa con CIF A78633856

馃敊 Perfil de Laboratorios Syva Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Laboratorios Syva Sa

27 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38652 , F 202, S 8, H M 70781, I/A 78 (20.10.23).

01 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: CRUZ ROJO ELVIRA;DIEZ RAMOS HILARIO;GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL. Nombramientos.Apoderado: GOMEZ OLIVEROS DURAN JAIME;DIEZ RAMOS HILARIO;CRUZ ROJO ELVIRA;GARCIA GONZALEZ JUANMANUEL;CARNICER GARCIA CESAR LUIS. Datos registrales. T 38652 , F 201, S 8, H M 70781, I/A 77 (22.02.23).

29 de Septiembre de 2022
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38652 , F 200, S 8, H M 70781, I/A 76 (22.09.22).

06 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEVON HOLDING SL;TAUT SL. Presidente: TAUT SL. Vicepresid.: DEVON HOLDING SL. Consejero:GOMEZ PESO IGNACIO. Secretario: GOMEZ PESO IGNACIO. Representan: PABLOS ALONSO FERNANDO;PABLOS ALONSOEZEQUIEL. Nombramientos. Consejero: DEVON HOLDING SL;PABLOS GARCIA JORGE;TAUT SL;HERNANDEZ MARCOSFRANCISCO;LAZARO GONZALEZ JUAN. Vicepresid.: TAUT SL. Presidente: DEVON HOLDING SL;TAUT SL. Vicepresid.: DEVONHOLDING SL. SecreNoConsj: ARGUELLO ALVAREZ LUIS. Presidente: DEVON HOLDING SL. Vicepresid.: TAUT SL. Presidente:TAUT SL. Vicepresid.: DEVON HOLDING SL. Presidente: DEVON HOLDING SL. Vicepresid.: TAUT SL. Representan: PABLOSALONSO EZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culos 17 relativo al Organode Administraci贸n y su retribuci贸n, y el art铆culo 22 relativo a la duraci贸n del cargo de los administradores. Datos registrales. T 38652 ,F 199, S 8, H M 70781, I/A 75 (28.04.22).

28 de Febrero de 2022
Otros conceptos: Se a帽ade un art铆culo 15 bis a los Estatutos Sociales y un p谩rrafo g) al art铆culo 23 de los mismos, concernientes alas reuniones de Junta y Consejo para su celebraci贸n v铆a telem谩tica. Datos registrales. T 38652 , F 199, S 8, H M 70781, I/A 74(21.02.22).

26 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ PEREZ BEGO脩A;SERRANO LUIS ROBERTO;MARTINEZ DIEZ RUBEN. Datosregistrales. T 38652 , F 198, S 8, H M 70781, I/A 72 (19.10.21).

Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 38652 , F 198, S 8, H M 70781, I/A 73(19.10.21).

25 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38652 , F 198, S 8, H M 70781, I/A 71 (18.10.21).

18 de Agosto de 2020
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38652 , F 197, S 8, H M 70781, I/A 70 (11.08.20).

28 de Febrero de 2020
Nombramientos. Consejero: GOMEZ PESO IGNACIO. Secretario: GOMEZ PESO IGNACIO. Datos registrales. T 38652 , F 197, S8, H M 70781, I/A 69 (21.02.20).

26 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUMBRERAS DE AZANZA JUAN CARLOS. Secretario: LUMBRERAS DE AZANZA JUAN CARLOS.Datos registrales. T 38652 , F 197, S 8, H M 70781, I/A 68 (18.12.19).

21 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38652 , F 197, S 8, H M 70781, I/A 67 (13.08.19).

21 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DEVON HOLDING SL;TAUT SL. Representan: PABLOS ALONSO EZEQUIEL;PABLOSALONSO FERNANDO. Nombramientos. Representan: PABLOS ALONSO EZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. Consejero:DEVON HOLDING SL;TAUT SL;LUMBRERAS DE AZANZA JUAN CARLOS. Presidente: TAUT SL. Vicepresid.: DEVON HOLDING SL.Secretario: LUMBRERAS DE AZANZA JUAN CARLOS. Modificaciones estatutarias. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y28; incorporacion de una disposici贸n adicional.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoresmancomunados a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 16209 , F 130, S 8, H M 70781, I/A 66 (14.02.19).

21 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16209 , F 130, S 8, H M 70781, I/A 65 (13.11.18).

15 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16209 , F 129, S 8, H M 70781, I/A 64 ( 5.01.18).

17 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apoderado: SANTAMARIA DEL REY PRUDENCIO. Datos registrales. T 16209 , F 129, S 8, H M 70781, I/A 63 (9.08.17).

19 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: CARNICER GARCIA CESAR LUIS. Datos registrales. T 16209 , F 128, S 8, H M 70781, I/A 61(11.07.17).

Revocaciones. Apoderado: BASCU脩AN HERRERA LUIS NICOLAS. Datos registrales. T 16209 , F 129, S 8, H M 70781, I/A 62(11.07.17).

20 de Enero de 2017
Revocaciones. Apoderado: PABLOS ALONSO EZEQUIEL. Datos registrales. T 16209 , F 127, S 8, H M 70781, I/A 59 (13.01.17).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PABLOS ALONSO EZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. Nombramientos.Representan: PABLOS ALONSO FERNANDO;PABLOS ALONSO EZEQUIEL. Adm. Mancom.: DEVON HOLDING SL;TAUT SL.Datos registrales. T 16209 , F 127, S 8, H M 70781, I/A 60 (13.01.17).

01 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16209 , F 126, S 8, H M 70781, I/A 58 (24.08.16).

25 de Agosto de 2016
Reelecciones. Adm. Mancom.: PABLOS ALONSO EZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. Datos registrales. T 16209 , F 126,S 8, H M 70781, I/A 57 (18.08.16).

11 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16209 , F 126, S 8, H M 70781, I/A 56 ( 4.09.15).

07 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apoderado: CEPEDA DOMINGUEZ ANGEL JOSE;DIEZ RAMOS HILARIO. Otros conceptos: REVOCADOSPODERES A: DIEZ MARTINEZ, ANGEL; BASCU脩AN HERRERA, LUIS NICOLAS; Y FERNANDEZ DIEZ, JUAN JOSE, CONFERIDOSMEDIANTE ESCRITURA AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID DON JESUS FRANCH VALVERDE DE 28/7/1989 PROT2653, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 11&. Datos registrales. T 16209 , F 126, S 8, H M 70781, I/A 55 (31.07.15).

13 de Julio de 2015
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ SANCHEZ FERNANDO;BASCU脩AN HERRERA LUIS NICOLAS;CRUZ ROJO ELVIRA;DIEZRAMOS HILARIO;GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL;SANTAMARIA DEL REY PRUDENCIO. Datos registrales. T 16209 , F 124,S 8, H M 70781, I/A 54 ( 6.07.15).

19 de Marzo de 2013
Otros conceptos: Don M谩ximo Ram贸n Linacero Fern谩ndez, RENUNCIA a todos los poderes conferidos por la sociedad a su favor yque constabaninscrito en las inscripciones 11&, 25&, 29&, 31&, 32& de lahoja social. Datos registrales. T 16209 , F 124, S 8, H M70781, I/A 53 ( 8.03.13).

07 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16209 , F 123, S 8, H M 70781, I/A 52 (28.11.12).

22 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16209 , F 123, S 8, H M 70781, I/A 51 (12.09.11).

16 de Agosto de 2011
Reelecciones. Adm. Mancom.: PABLOS ALONSO EZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. Datos registrales. T 16209 , F 123,S 8, H M 70781, I/A 50 ( 1.08.11).

30 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16209 , F 123, S 8, H M 70781, I/A 49 (17.11.10).

10 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 16209 , F 123, S 8, H M 70781, I/A 48 (28.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n