Actos BORME de Labs & Technological Services Agq Sociedad Limitada
21 de Marzo de 2023Otros conceptos: Orden Ministerial de fecha 14 de diciembre de 2022. Se conceden incentivos regionales por importe de 542.856,60euros. Datos registrales. T 7083 , F 5, S 8, H SE 70904, I/A 27 (13.03.23).
30 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 7083 , F 4, S 8, H SE 70904, I/A 26 (22.09.21).
21 de Septiembre de 2021Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 7083 , F 4, S 8, H SE 70904, I/A 25 (10.09.21).
23 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ PERDICES JOSE RAMON;SANCHEZ PERDICES JOSE RAMON;SANCHEZ PERDICESJOSE RAMON;GARCIA GOMEZ MANUEL JOSE;ROMERO BEJARANO ROCIO;BENITO NAVARRO ARANTZAZU. Otrosconceptos: Revocado el poder no inscrito conferido a favor de DON JOSE RAMON SANCHEZ PERDICES, con N.I.F. 2897152A,mediante escritura otorgada en Alcalá del Rio, ante el notario don Antonio García Morales, el día dieciocho de diciembre de dos milocho, con el número 3.329 de protocolo.- Datos registrales. T 4569 , F 18, S 8, H SE 70904, I/A 21 (15.07.21).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GOMEZ MANUEL JOSE. Datos registrales. T 7083 , F 1, S 8, H SE 70904, I/A 22(15.07.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GANIVET MATEO JOSE LUIS. Datos registrales. T 7083 , F 3, S 8, H SE 70904, I/A 23 (15.07.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SERRANO CRUZ MARIA-SOLEDAD. Datos registrales. T 7083 , F 4, S 8, H SE 70904, I/A 24(15.07.21).
28 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: BENITO NAVARRO ARANTZAZU. Datos registrales. T 4569 , F 18, S 8, H SE 70904, I/A 20(21.10.19).
05 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENITO NAVARRO ARANTZAZU. Datos registrales. T 4569 , F 16, S 8, H SE 70904, I/A 18(27.06.19).
Nombramientos. Apoderado: ROMERO BEJARANO ROCIO. Datos registrales. T 4569 , F 16, S 8, H SE 70904, I/A 19 (27.06.19).
07 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: SUAREZ BARCENA RAMIREZ JUAN MANUEL;TORRES REY PEDRO ANTONIO;BENITO NAVARROARANTZAZU. Otros conceptos: Revocado el poder no inscrito conferido a favor de Doña María Del Mar Zamora De La Cruz,mediante escritura otorgada en Alcalá del Río, ante el notario Don Antonio García Morales, el día veinticinco de septiembre de dos milsiete, con el número 3.084 de protocolo. Datos registrales. T 4569 , F 16, S 8, H SE 70904, I/A 17 (31.05.19).
16 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: GARCIA GOMEZ MANUEL JOSE. Datos registrales. T 4569 , F 15, S 8, H SE 70904, I/A 16 (9.04.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4569 , F 15, S 8, H SE 70904, I/A 15 (26.03.19).
08 de Marzo de 2016Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 4569 , F 15, S 8, H SE 70904, I/A 14 ( 1.03.16).
12 de Enero de 2016Nombramientos. Apoderado: BENITO NAVARRO ARANTZAZU. Datos registrales. T 4569 , F 14, S 8, H SE 70904, I/A 13(28.12.15).
10 de Mayo de 2013Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 4569 , F 13, S 8, H SE 70904, I/A 12 (25.04.13).
09 de Mayo de 2013Nombramientos. Auditor: AUDITORES INMOBILIARIOS SL. Datos registrales. T 4569 , F 13, S 8, H SE 70904, I/A 11 (24.04.13).
24 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: TORRES REY PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 4569 , F 11, S 8, H SE 70904, I/A 10(11.01.12).
23 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PERDICES JOSE RAMON. Datos registrales. T 4569 , F 11, S 8, H SE 70904, I/A 9 (5.09.11).
20 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: SUAREZ BARCENA RAMIREZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 4569 , F 10, S 8, H SE 70904,I/A 8 ( 5.09.11).
01 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PERDICES JOSE RAMON. Datos registrales. T 4569 , F 9, S 8, H SE 70904, I/A 7(19.11.09).
01 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PERDICES JOSE RAMON. Datos registrales. T 4569 , F 9, S 8, H SE 70904, I/A 6(19.06.09).