Buscador CIF Logo

Actos BORME Laderaland Developments Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laderaland Developments Sl

Actos BORME Laderaland Developments Sl - B87350591

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Laderaland Developments Sl con CIF B87350591

馃敊 Perfil de Laderaland Developments Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Laderaland Developments Sl

14 de Octubre de 2022
Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 27陋 los actos de disoluci贸n, liquidaci贸n y extinci贸n, siendo lo correcto 煤nicamnetela disoluci贸n de la sociedad. Datos registrales. T 40450 , F 92, S 8, H M 607566, I/A 27 ( 5.10.21).

09 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: IGLESIAS RODRIGUEZ RUTH. Datos registrales. T 40450 , F 93, S 8, H M 607566, I/A 28 ( 2.06.22).

13 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LADERALAND SARL. Nombramientos. Liquidador: VACIERO SLP. Disoluci贸n. Voluntaria.Extinci贸n. Datos registrales. T 40450 , F 92, S 8, H M 607566, I/A 27 ( 5.10.21).

02 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE. Datos registrales. T 40450 , F 92, S 8, H M 607566, I/A 26(26.07.21).

27 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: QUINTANO VILLA ALVARO. Datos registrales. T 40450 , F 92, S 8, H M 607566, I/A 25 (20.05.21).

16 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: IGLESIAS RODRIGUEZ RUTH. Datos registrales. T 40450 , F 90, S 8, H M 607566, I/A 24 ( 9.02.21).

08 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RENAU JORGE. Datos registrales. T 35116 , F 122, S 8, H M 607566, I/A 23 ( 1.06.20).

18 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUINTANO VILLA ALVARO. Apo.Manc.: HOLGADO HERRERO MANUEL;HERRAEZ SANCHEZOSCAR;OCEJO CALVO IGNACIO MARIA. Datos registrales. T 35116 , F 120, S 8, H M 607566, I/A 22 (11.11.19).

30 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE. Datos registrales. T 35116 , F 120, S 8, H M 607566, I/A 21(23.05.19).

28 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: RAMAJO DIAZ LUIS DAVID;SANTOS CANDELARIO MIGUEL ANGEL;GONZALEZ GARCIAAITANA;VILLORA GARCIA FRANCISCO JAVIER;GALAN ANTO脩ANZAS PABLO;MARIN IZQUIERDO MARIA DEL CARMEN. Datosregistrales. T 35116 , F 120, S 8, H M 607566, I/A 20 (21.05.19).

14 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: LABIED MAJDA;FERNANDEZ DIAZ DE LOPE DIAZ ALEJANDRO;PORTILLO RUIZ FRANCISCOJOSE;RODRIGUEZ-BAILON FERNANDEZ CARLOS. Apo.Sol.: DEL RIO MERINO GONZALO;LABIED MAJDA;REDONDO LEONPABLO;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE MANZANARES LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 35116 , F 115, S 8, H M 607566, I/A16 ( 7.05.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: LABIED MAJDA;RODRIGUEZ-BAILON FERNANDEZ CARLOS;PATERSON KANDY;RODRIGUEZ DETEMBLEQUE MANZANARES LUIS. Datos registrales. T 35116 , F 115, S 8, H M 607566, I/A 17 ( 7.05.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: LABIED MAJDA;DEL RIO MERINO GONZALO;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE MANZANARESLUIS;LACAVE VELA BARCA JAVIER. Datos registrales. T 35116 , F 117, S 8, H M 607566, I/A 18 ( 7.05.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: LABIED MAJDA;BLASCO BLANCO JAVIER;PORTILLO RUIZ FRANCISCO JOSE;MUNGUIRAFERNANDEZ ROSA;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE MANZANARES LUIS. Datos registrales. T 35116 , F 118, S 8, H M 607566, I/A19 ( 7.05.19).

01 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: MOLINA CUBILLO BELEN. Datos registrales. T 35116 , F 114, S 8, H M 607566, I/A 15 (25.03.19).

18 de Enero de 2018
Revocaciones. Apoderado: DEL RIO MERINO GONZALO. Nombramientos. Apo.Sol.: DEL RIO MERINO GONZALO;LABIEDMAJDA. Datos registrales. T 35116 , F 112, S 8, H M 607566, I/A 13 (11.01.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: REDONDO LEON PABLO;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE MANZANARES LUIS FERNANDO. Datosregistrales. T 35116 , F 113, S 8, H M 607566, I/A 14 (11.01.18).

17 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ-BAILON FERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 35116 , F 111, S 8, H M 607566,

06 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: PORTILLO RUIZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 35116 , F 111, S 8, H M 607566, I/A 11(28.09.17).

18 de Agosto de 2017
Otros conceptos: CAMBIO DE DENONINACION DEL ADMINISTRADOR UNICO Y SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD POR LA DE"LADERALAND SARL". Datos registrales. T 35116 , F 110, S 8, H M 607566, I/A 10 (10.08.17).

09 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DIAZ DE LOPE DIAZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 35116 , F 110, S 8, H M607566, I/A 9 ( 1.06.17).

15 de Febrero de 2017
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 3 4潞 DR (MADRID). Datos registrales. T 35116 , F 110, S 8, H M 607566, I/A 8 (7.02.17).

14 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: DEL RIO MERINO GONZALO. Datos registrales. T 33756 , F 207, S 8, H M 607566, I/A 6 ( 5.12.16).

Nombramientos. Apoderado: LABIED MAJDA. Datos registrales. T 35116 , F 109, S 8, H M 607566, I/A 7 ( 5.12.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n