Buscador CIF Logo

Actos BORME Laftur Sal

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Laftur Sal

Actos BORME Laftur Sal - A50467000

Tenemos registrados 6 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Laftur Sal con CIF A50467000

馃敊 Perfil de Laftur Sal
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Laftur Sal

05 de Octubre de 2023
Nombramientos. Cons.Del.Sol: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS;PARDO ABAD PEDRO. Reelecciones. Consejero: JIMENEZMARQUES JESUS TOMAS. Presidente: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS. Consejero: PARDO ABAD PEDRO. Secretario:PARDO ABAD PEDRO. Consejero: MARTINEZ BLANZACO MARIA JOSEFA;PARDO ABAD FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 4200 , F 36, S 8, H Z 2148, I/A 13 (29.09.23).

14 de Febrero de 2022
Nombramientos. Auditor: POSTIGO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4200 , F 36, S 8, H Z 2148, I/A 12 ( 7.02.22).

05 de Agosto de 2021
Ampliacion del objeto social. El objeto social el almacenaje, transporte, distribuci贸n y comercializaci贸n, precisamente, de losproductos almacenados. Cambio de domicilio social. POLIG MALPICA - CALLE D, NUMERO 101 (ZARAGOZA). Datosregistrales. T 4200 , F 36, S 8, H Z 2148, I/A 11 (30.07.21).

18 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Consejero: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS. Presidente: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS. Consejero:PARDO ABAD PEDRO. Secretario: PARDO ABAD PEDRO. Consejero: MARTINEZ BLANZACO MARIA JOSEFA;PARDO ABADFRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Sol: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS;PARDO ABAD PEDRO. Datos registrales. T 2985 , F104, S 8, H Z 2148, I/A 10 (11.12.17).

08 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: PARDO ABAD PEDRO. Datos registrales. T 2985 , F 104, S 8, H Z 2148, I/A 9 (29.08.11).

25 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS. Presidente: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS. Consejero:PARDO LOZANO FRANCISCO. Secretario: PARDO LOZANO FRANCISCO. Consejero: MARTINEZ BLANZACO MARIAJOSEFA;ABAD SEGURA MARIA PILAR;JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS. Con.Delegado: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS.Nombramientos. Consejero: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS. Presidente: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS. Consejero:PARDO ABAD PEDRO. Secretario: PARDO ABAD PEDRO. Consejero: MARTINEZ BLANZACO MARIA JOSEFA;PARDO ABADFRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Sol: JIMENEZ MARQUES JESUS TOMAS;PARDO ABAD PEDRO. Desembolso de dividendospasivos. Desembolsado: 25.092,26 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 27潞.- DURACION DEL CARGO.- La duraci贸ndel cargo de Administrador ser谩 de seis a帽os. Podr谩n ser reelegidos unn煤mero indefinido de veces por periodos de igual duraci贸n..Otros conceptos: RATIFICADAS las actuaciones realizadas por el 贸rgano de administraci贸n en periodo vencido. Cambio dedomicilio social. POLIG INDUSTRIAL EL BORAO - PARCELA 3 (ALFAJARIN). Datos registrales. T 2985 , F 104, S 8, H Z 2148,I/A 8 (16.08.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n