Actos BORME de Lantia Maritima Sl
04 de Abril de 2023Nombramientos. Auditor: COLMART AUDITORES Y ASESORES SLP. Datos registrales. T 29400 , F 46, S 8, H M 149256, I/A 19(28.03.23).
28 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PEREZ VAZQUEZ DANIEL;PEREZ VAZQUEZ MARIA REYES;PEREZ VAZQUEZ RUBEN.Nombramientos. Representan: PEREZ VAZQUEZ MARIA REYES;PEREZ VAZQUEZ DANIEL;PEREZ VAZQUEZ RUBEN. Adm.Solid.: REPEVA HOLDING SL;D P HOLD SL;M & O HOLD SL. Datos registrales. T 29400 , F 45, S 8, H M 149256, I/A 17 (20.12.22).
Revocaciones. Apoderado: ARAGON GIJON DAVID;HERNANDEZ GRAVE DE PERALTA VIVIAN. Datos registrales. T 29400 , F45, S 8, H M 149256, I/A 18 (20.12.22).
29 de Julio de 2020Cambio de domicilio social. AVDA DE CASTILLA 2 - PLANTA BAJA, EDIFICIO DE EURO (SAN FERNANDO DE HENARES).Datos registrales. T 29400 , F 44, S 8, H M 149256, I/A 16 (22.07.20).
10 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: COLMART AUDITORES Y ASESORES SLP. Datos registrales. T 29400 , F 44, S 8, H M 149256, I/A 15(27.12.19).
22 de Febrero de 2018Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: LANTIA MARITIMA BARCELONA SL. LANTIA AEREA SL. Datos registrales. T29400 , F 42, S 8, H M 149256, I/A 14 (13.02.18).
23 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: COLAS APARICIO ALVARO. Aud.Supl.: CABANAS RICO SONIA. Datos registrales. T 29400 , F 42, S 8,H M 149256, I/A 13 (12.01.18).
24 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ GRAVE DE PERALTA VIVIAN. Datos registrales. T 29400 , F 41, S 8, H M 149256, I/A12 (16.12.14).
05 de Junio de 2014Otros conceptos: HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO DECIMOSEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LOREFERENTE A LA RETRIBUCION DEL ADMINISTRADOR.- Datos registrales. T 29400 , F 40, S 8, H M 149256, I/A 11 (29.05.14).
01 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PEREZ VAZQUEZ DANIEL. Nombramientos. Adm. Solid.: PEREZ VAZQUEZ DANIEL;PEREZVAZQUEZ MARIA REYES;PEREZ VAZQUEZ RUBEN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Ampliacion del objeto social. SERVICIO DE MENSAJERIA, PAQUETERIA YCOURRIER. Datos registrales. T 29400 , F 40, S 8, H M 149256, I/A 10 (25.07.13).
14 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: ARAGON GIJON DAVID. Datos registrales. T 9279 , F 201, S 8, H M 149256, I/A 9 ( 2.02.12).
02 de Junio de 2010Cambio de domicilio social. C/ HIERRO 33 B (TORREJON DE ARDOZ). Datos registrales. T 9279 , F 201, S 8, H M 149256, I/A 8(21.05.10).
04 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: PEREZ VAZQUEZ RUBEN. Datos registrales. T 9279 , F 199, S 8, H M 149256, I/A 7 (20.02.09).