Buscador CIF Logo

Actos BORME Lardea Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Lardea Sl

Actos BORME Lardea Sl - B58672221

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Lardea Sl con CIF B58672221

馃敊 Perfil de Lardea Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Lardea Sl

06 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: CUBILLO GOMEZ-ALONSO FRANCISCO JAVIER;TORRES ARLANDIS MAYO. Datos registrales. T41193 , F 1, S 8, H M 239061, I/A 37 (29.06.21).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GONZALEZ VIRGINIA. Datos registrales. T 41193 , F 1, S 8, H M 239061, I/A 38(29.06.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: VILLA MARTINEZ JOSE LUIS;MARTA LOPEZ FANDO PELAEZ;PE脩A ALONSO ROSA MARIA.Apo.Manc.: ALDAMA GARAIZABAL MARIA EUGENIA. Apo.Man.Soli: SANCHEZ GONZALEZ VIRGINIA. Apo.Manc.: BASURTO O脩AJORDI. Datos registrales. T 41193 , F 3, S 8, H M 239061, I/A 39 (29.06.21).

10 de Diciembre de 2020
Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 18 1 (MADRID). Datos registrales. T 37599 , F 168, S 8, H M 239061, I/A 36 (1.12.20).

17 de Julio de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA PRIETO MARTINEZ GONZALO. Datos registrales. T 37599 , F 168, S 8, H M 239061, I/A 35(10.07.19).

15 de Julio de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.531.974,48 Euros. Resultante Suscrito: 144.320,40 Euros. Modificaciones estatutarias.Aprobaci贸n de un nuevo texto de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 37599 , F 166, S 8, H M 239061, I/A 34 ( 8.07.19).

29 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: ALDAMA GARAIZABAL MARIA EUGENIA. Apo.Man.Soli: SANCHEZ GONZALEZ VIRGINIA.Apo.Manc.: GARCIA PRIETO MARTINEZ GONZALO;BASURTO O脩A JORDI. Datos registrales. T 33578 , F 157, S 8, H M 239061,I/A 33 (22.08.18).

15 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA. Representan: GOMEZ PINTADO RODRIGUEZDE SEGOVIA JUAN ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: DOSPUNTOS ASSET MANAGEMENT SL. Representan: LAFFITTEORTI ALFREDO. Cambio de domicilio social. PASEO PASEO DE RECOLETOS 16 1陋 (MADRID). Datos registrales. T 33578 , F

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: DOSPUNTOS ASSET MANAGEMENT SL. Datos registrales. T33578 , F 157, S 8, H M 239061, I/A 32 ( 7.02.18).

14 de Junio de 2017
Cambio de domicilio social. C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW 1 (MADRID). Datos registrales. T 33578 , F 156, S8, H M 239061, I/A 29 ( 5.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: VILLA MARTINEZ JOSE LUIS;MARTA LOPEZ FANDO PELAEZ;PE脩A ALONSO ROSA MARIA. Datosregistrales. T 33578 , F 156, S 8, H M 239061, I/A 30 ( 5.06.17).

17 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTIZ GARCIA JOAQUIN MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: DOS PUNTOSDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA. Representan: GOMEZ PINTADO RODRIGUEZ DE SEGOVIA JUAN ANTONIO. Datosregistrales. T 33578 , F 156, S 8, H M 239061, I/A 28 ( 8.05.17).

05 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTIZ GARCIA JOAQUIN MANUEL;ROMON SANCHEZ FERNANDO. Nombramientos. Adm.Unico: ORTIZ GARCIA JOAQUIN MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 79 6 (MADRID). Datos registrales. T 33578 , F155, S 8, H M 239061, I/A 27 (26.04.16).

10 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE;CASTELL GOMEZ DE MEMBRILLERA LUIS;PALACIO APARICIOCARLOS ANTONIO;ORITZ ECHAGUE RIFE ALFONSO. Datos registrales. T 33578 , F 155, S 8, H M 239061, I/A 26 (29.02.16).

31 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: REY LAREDO JAVIER;ALONSO LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Adm. Solid.: SAN JOSEDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA;UDRASUR INMOBILIARIA SL. Nombramientos. Adm. Solid.: ORTIZ GARCIA JOAQUINMANUEL;ROMON SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 33578 , F 155, S 8, H M 239061, I/A 24 (20.08.15).

Revocaciones. Apoderado: GARRIDO PASCUAL ESTHER;MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Datos registrales. T 33578 , F155, S 8, H M 239061, I/A 25 (20.08.15).

17 de Octubre de 2011
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SAN JOSE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA. Cambio dedomicilio social. C/ RONDA DE PONIENTE 11 (TRES CANTOS). Datos registrales. T 23656 , F 99, S 8, H M 239061, I/A 23 (4.10.11).

25 de Agosto de 2011
Revocaciones. Apoderado: ESCRIBANO CORTES FERNANDO;ESCRIBANO CORTES FERNANDO;CARRILLO ALCARAZENRIQUE;ESCRIBANO CORTES FERNANDO;CA脩AS GARCIA-ROJO FEDERICO;MARTINEZ CARBALLALSANTIAGO;RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL. Datos registrales. T 23656 , F 98, S 8, H M 239061, I/A 22 (12.08.11).

11 de Abril de 2011
Nombramientos. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE. Datos registrales. T 23656 , F 97, S 8, H M 239061, I/A 21(29.03.11).

13 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CARRILLO ALCARAZ ENRIQUE;RODRIGUEZ-ACOSTA MARQUEZ MANUEL. Nombramientos.Adm. Solid.: SAN JOSE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA;UDRASUR INMOBILIARIA SL. Representan: REY LAREDOJAVIER;ALONSO LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 23656 , F 97, S 8, H M 239061, I/A 20 (29.11.10).

09 de Septiembre de 2009
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.A. Datos registrales. T 23656 , F96, S 8, H M 239061, I/A 19 (31.08.09).

18 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: HERRERO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 23656 , F 96, S 8, H M 239061,I/A 17 ( 8.06.09).

Cambio de domicilio social. AVDA DE EUROPA, 26, EDIFICIO 5, PLANTA 3. (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T23656 , F 96, S 8, H M 239061, I/A 18 ( 8.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n