Buscador CIF Logo

Actos BORME Las Pailas De Cemento Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Las Pailas De Cemento Sa

Actos BORME Las Pailas De Cemento Sa - A82809799

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Las Pailas De Cemento Sa con CIF A82809799

馃敊 Perfil de Las Pailas De Cemento Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Las Pailas De Cemento Sa

26 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE LEON FUENTES ANGEL CUSTODIO. Datos registrales. T 40581 , F 125, S 8, H M267720, I/A 49 (19.08.22).

15 de Junio de 2022
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CONDADOOLZA INVERSIONES SL. Ceses/Dimisiones.Con.Delegado: ANIZ LEON JUAN ANTONIO. Consejero: ANIZ LEON JUAN ANTONIO. Presidente: ANIZ LEON JUAN ANTONIO.Consejero: ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA LUISA. Vicepresid.: ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA LUISA. Consejero: AERNEBRUNO JOHANN. SecreNoConsj: SAEZ CHAMORRO RAFAEL. Representan: RATHGEB HENRY DARIO. Nombramientos. Adm.Unico: CONDADOOLZA INVERSIONES SL. Representan: ANIZ LEON JUAN ANTONIO. Modificaciones estatutarias. 15. . 19.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domiciliosocial. C/ DIEGO DE LEON 59 2 C (MADRID). Datos registrales. T 40581 , F 124, S 8, H M 267720, I/A 47 ( 8.06.22).

Revocaciones. Apoderado: AERNE BRUNO JOHANN;QUEVEDO ACU脩A MARCO ANTONIO. Apo.Sol.: GARCIA ORDAX MARIACONCEPCION. Apoderado: RATHGEB HENRY DARIO;FRANCO JUNCA HAROLD;HERNANDEZ MONTERROSAS RODOLFO.Datos registrales. T 40581 , F 124, S 8, H M 267720, I/A 48 ( 8.06.22).

17 de Enero de 2022
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ MONTERROSAS RODOLFO. Datos registrales. T 40581 , F 122, S 8, H M 267720, I/A46 (10.01.22).

10 de Mayo de 2021
Nombramientos. Representan: RATHGEB HENRY DARIO. Apoderado: RATHGEB HENRY DARIO. Datos registrales. T 40581 , F120, S 8, H M 267720, I/A 44 (30.04.21).

Nombramientos. Apoderado: FRANCO JUNCA HAROLD. Datos registrales. T 40581 , F 121, S 8, H M 267720, I/A 45 ( 2.05.21).

06 de Agosto de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 89.782.220,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 40581 ,F 120, S 8, H M 267720, I/A 43 (30.07.20).

24 de Marzo de 2020
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN) SL. Datos registrales. T 21037 ,F 91, S 8, H M 267720, I/A 42 (17.03.20).

07 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: CANTILLANA IBARROLA JOSE;VIVANCO CORONEL MARLOVE GONZALO. Apo.Sol.: ASUA LOPEZISABEL. Apoderado: URIBE GUEVARA ALVARO. Datos registrales. T 21037 , F 91, S 8, H M 267720, I/A 40 (31.01.20).

Revocaciones. Apoderado: GARVIA SALCEDO LUIS;GARVIA SALCEDO LUIS;GARVIA SALCEDO LUIS;SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL. Datos registrales. T 21037 , F 91, S 8, H M 267720, I/A 41 (31.01.20).

03 de Enero de 2019
Cambio de objeto social. a) La modernizaci贸n, optimizaci贸n, rehabilitaci贸n y explotaci贸n de plantas de cemento, hormig贸n y 谩ridos,canteras y otras operaciones industriales relacionadas con la fabricaci贸n de materiales de construcci贸n. b) La producci贸n,almacenamiento, transporte, distribuci贸n y venta de materiales de. Datos registrales. T 21037 , F 90, S 8, H M 267720, I/A 39(26.12.18).

28 de Septiembre de 2018
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ALIANZA DE PROYECTOS 200 SL. Datos registrales. T 21037 , F 88, S 8, H M267720, I/A 38 (20.09.18).

23 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: AERNE BRUNO JOHANN. Presidente: AERNE BRUNO JOHANN. Consejero: GARVIA SALCEDOLUIS;SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL. Vicepresid.: GARVIA SALCEDO LUIS. Cons.Del.Sol: AERNE BRUNOJOHANN;GARVIA SALCEDO LUIS. Nombramientos. Consejero: ANIZ LEON JUAN ANTONIO. Presidente: ANIZ LEON JUANANTONIO. Consejero: ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA LUISA. Vicepresid.: ANCHUSTEGUI QUINTELA MARIA LUISA. Consejero:AERNE BRUNO JOHANN. Cambio de domicilio social. AVDA DE MANOTERAS 20 - EDIFICIO B (MADRID). Datos registrales. T21037 , F 87, S 8, H M 267720, I/A 36 (13.07.18).

Nombramientos. Con.Delegado: ANIZ LEON JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 21037 , F 88, S 8, H M 267720, I/A 37(13.07.18).

28 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ORDAX MARIA CONCEPCION. Datos registrales. T 21037 , F 87, S 8, H M 267720, I/A 35(21.05.18).

23 de Enero de 2018
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ALIANZA DE PROYECTOS 200 SL. Datos registrales. T 21037 , F 87, S 8, H M267720, I/A 34 (16.01.18).

02 de Enero de 2018
Reelecciones. SecreNoConsj: SAEZ CHAMORRO RAFAEL. Datos registrales. T 21037 , F 86, S 8, H M 267720, I/A 32 (21.12.17).

Nombramientos. Apoderado: QUEVEDO ACU脩A MARCO ANTONIO;URIBE GUEVARA ALVARO. Datos registrales. T 21037 , F86, S 8, H M 267720, I/A 33 (21.12.17).

30 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: ASUA LOPEZ ISABEL. Datos registrales. T 21037 , F 85, S 8, H M 267720, I/A 31 (20.01.17).

15 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: AERNE BRUNO JOHANN;SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL;SANTIESTEBAN LOUREIRODULCE MARIA;GARVIA SALCEDO LUIS. Nombramientos. Apoderado: AERNE BRUNO JOHANN;GARVIA SALCEDOLUIS;SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL. Datos registrales. T 21037 , F 83, S 8, H M 267720, I/A 30 ( 7.11.16).

18 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: AERNE BRUNO JOHANN;GARVIA SALCEDO LUIS. Nombramientos. Cons.Del.Sol: AERNEBRUNO JOHANN;GARVIA SALCEDO LUIS. Reelecciones. Consejero: AERNE BRUNO JOHANN. Presidente: AERNE BRUNOJOHANN. Consejero: GARVIA SALCEDO LUIS;SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL. Vicepresid.: GARVIA SALCEDO LUIS.Datos registrales. T 21037 , F 83, S 8, H M 267720, I/A 29 ( 7.08.15).

13 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apoderado: VELEZ ISLAS VICENTE HUMBERTO. Datos registrales. T 21037 , F 83, S 8, H M 267720, I/A 28 (6.05.13).

30 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: REDON REVUELTA BEGO脩A. Nombramientos. SecreNoConsj: SAEZ CHAMORRO RAFAEL.Datos registrales. T 21037 , F 81, S 8, H M 267720, I/A 27 (21.11.11).

22 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: SUAREZ DE LEZO Y CRUZ CONDE RAFAEL;AERNE BRUNO JOHANN. Presidente: AERNEBRUNO JOHANN. Consejero: GARVIA SALCEDO LUIS. Vicepresid.: GARVIA SALCEDO LUIS. Con.Delegado: AERNE BRUNOJOHANN. Nombramientos. Consejero: AERNE BRUNO JOHANN. Presidente: AERNE BRUNO JOHANN. Consejero: GARVIASALCEDO LUIS;SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL. Cons.Del.Sol: AERNE BRUNO JOHANN;GARVIA SALCEDO LUIS.Vicepresid.: GARVIA SALCEDO LUIS. Reelecciones. SecreNoConsj: REDON REVUELTA BEGO脩A. Datos registrales. T 21037 ,F 81, S 8, H M 267720, I/A 26 (10.02.11).

22 de Enero de 2010
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 21037 , F 81, S 8, H M 267720, I/A 25 (12.01.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n