Buscador CIF Logo

Actos BORME Las Rozuelas Del Valle Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Las Rozuelas Del Valle Sl

Actos BORME Las Rozuelas Del Valle Sl - B14059653

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Cordoba para Las Rozuelas Del Valle Sl con CIF B14059653

馃敊 Perfil de Las Rozuelas Del Valle Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Cordoba

Actos BORME de Las Rozuelas Del Valle Sl

19 de Julio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Cons.Del.Man: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS.Datos registrales. T 2564 , F 44, S 8, H CO 3296, I/A 40 (11.07.23).

28 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: AUDIBALANCE SLP. Datos registrales. T 2564 , F 44, S 8, H CO 3296, I/A 39 (18.12.20).

02 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: ROMERO MORA FRANCISCO JAVIER;ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZJUAN CARLOS;ROMERO MORA JOSE ANTONIO;FERNANDEZ ROMERO ISABEL MARIA. Nombramientos. Cons.Del.Man:ROMERO MORA JOSE ANTONIO;ROMERO MORA FRANCISCO JAVIER;ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZJUAN CARLOS;FERNANDEZ ROMERO ISABEL MARIA. Datos registrales. T 2564 , F 43, S 8, H CO 3296, I/A 38 (24.06.19).

05 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Presidente: ROMERO MORA JOSE ANTONIO. Vicepresid.: FERNANDEZ ROMERO ISABEL MARIA. Secretario:ROMERO GONZALEZ PABLO. Cons.Del.Sol: ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS.Nombramientos. Consejero: ROMERO MORA FRANCISCO JAVIER;ROMERO LOPEZ JUAN CARLOS. Presidente: ROMEROMORA JOSE ANTONIO. Vicepresid.: FERNANDEZ ROMERO ISABEL MARIA. Secretario: ROMERO LOPEZ JUAN CARLOS.Vicesecret.: ROMERO MORA FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Sol: ROMERO MORA FRANCISCO JAVIER;ROMERO LOPEZ JUANCARLOS;ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2564 , F 42, S 8, H CO 3296,I/A 36 (28.11.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO LOPEZ JUAN CARLOS. Secretario: ROMERO LOPEZ JUAN CARLOS. Cons.Del.Sol:ROMERO LOPEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: ROMERO GONZALEZ JUANA. SecreNoConsj: ROMERO LOPEZPABLO. Cons.Del.Sol: ROMERO MORA JOSE ANTONIO;FERNANDEZ ROMERO ISABEL MARIA. Reelecciones. Presidente:ROMERO MORA JOSE ANTONIO. Cons.Del.Sol: ROMERO MORA FRANCISCO JAVIER;ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMEROGONZALEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2564 , F 43, S 8, H CO 3296, I/A 37 (28.11.18).

11 de Abril de 2018
Nombramientos. Auditor: AUDIBALANCE SLP. Datos registrales. T 2564 , F 42, S 8, H CO 3296, I/A 35 ( 4.04.18).

08 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO GONZALEZ JOSE. Presidente: ROMERO GONZALEZ JOSE. Consejero: ROMEROGONZALEZ JUANA. Secretario: ROMERO GONZALEZ JUANA. Consejero: ROMERO ROMERO ISABEL;ROMERO GONZALEZJUAN CARLOS. Cons.Del.Sol: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Consejero: ROMERO GONZALEZ PABLO. Cons.Del.Sol:ROMERO GONZALEZ PABLO. Nombramientos. Consejero: ROMERO MORA JOSE ANTONIO. Presidente: ROMERO MORAJOSE ANTONIO. Consejero: FERNANDEZ ROMERO ISABEL MARIA. Vice.Depo.: FERNANDEZ ROMERO ISABEL MARIA.Consejero: ROMERO GONZALEZ PABLO. Secretario: ROMERO GONZALEZ PABLO. Consejero: ROMERO GONZALEZ JUANCARLOS;ROMERO ROMERO PABLO MANUEL. Cons.Del.Sol: ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZ JUANCARLOS. Cambio de domicilio social. AVDA GRAN CAPITAN 2 (CORDOBA). Datos registrales. T 2564 , F 41, S 8, H CO 3296,I/A 34 (31.05.17).

15 de Marzo de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 21.779.462,25 Euros. Resultante Suscrito: 48.276.630,99 Euros. Datos registrales. T 1378 , F 224,S 8, H CO 3296, I/A 33 ( 7.03.17).

31 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ROMERO CARLOS JOSE. Datos registrales. T 1378 , F 145, S 8, H CO 3296, I/A 32(24.01.17).

10 de Diciembre de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.458.366,36 Euros. Resultante Suscrito: 26.497.168,74 Euros. Datos registrales. T 1378 , F 144, S8, H CO 3296, I/A 31 ( 2.12.14).

30 de Abril de 2014
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EL OLMO CORDOBA SL. Datos registrales. T 1378 , F 144, S 8, H CO 3296, I/A30 (23.04.14).

21 de Junio de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 180.360,00 Euros. Resultante Suscrito: 22.038.802,38 Euros. Datos registrales. T 1378 ,F 143, S 8, H CO 3296, I/A 29 (14.06.13).

08 de Abril de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 180.360,00 Euros. Resultante Suscrito: 22.219.162,38 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: PORTENT BUSINESS SL. Datos registrales. T 1378 , F 141, S 8, H CO 3296, I/A 28 ( 1.04.13).

23 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO GONZALEZ JUANA;ROMERO GONZALEZ PABLO. Secretario: ROMERO GONZALEZPABLO. Cons.Del.Sol: ROMERO GONZALEZ PABLO. Consejero: ROMERO GONZALEZ CELEDONIO;ROMERO GONZALEZ JUANCARLOS;GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCA ISABEL. Presidente: GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCA ISABEL. Consejero:ROMERO GONZALEZ JOSE. Cons.Del.Sol: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: ROMEROGONZALEZ JOSE. Presidente: ROMERO GONZALEZ JOSE. Consejero: ROMERO GONZALEZ JUANA. Secretario: ROMEROGONZALEZ JUANA. Consejero: ROMERO ROMERO ISABEL;ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Cons.Del.Sol: ROMEROGONZALEZ JUAN CARLOS. Consejero: ROMERO GONZALEZ PABLO. Cons.Del.Sol: ROMERO GONZALEZ PABLO. Datosregistrales. T 1378 , F 141, S 8, H CO 3296, I/A 27 (12.07.12).

24 de Mayo de 2011
Nombramientos. Apoderado: ALCAIDE RODA RAFAEL ANTONIO. Datos registrales. T 1378 , F 140, S 8, H CO 3296, I/A 26(13.05.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n