Buscador CIF Logo

Actos BORME Latinoamerica Participaciones Holding Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Latinoamerica Participaciones Holding Sl

Actos BORME Latinoamerica Participaciones Holding Sl - B86861663

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Latinoamerica Participaciones Holding Sl con CIF B86861663

馃敊 Perfil de Latinoamerica Participaciones Holding Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Latinoamerica Participaciones Holding Sl

17 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE HOYOS MAROTO JOSE;VAZQUEZ CASAS ANA MARIA. Datos registrales. T 34458 , F 115, S8, H M 569091, I/A 21 (10.03.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: TEMES CASTRILLON ALVARO TOMAS. Datos registrales. T 34458 , F 116, S 8, H M 569091, I/A 22(10.03.21).

16 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BARRO ROBLES MANUEL IGNACIO;PONCE GUTIERREZ IGNACIO;MARTIN MORAN MARIASANDRA. Nombramientos. Representan: SHILLINGFORD TOMOS ARTHUR STANLEY;ROMERO-CAMACHO SILOSCARLOS;PONCE GUTIERREZ IGNACIO. Adm. Mancom.: CHEMO HOLDING SL;EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDINGSL;INSUD PHARMA SL. Datos registrales. T 34458 , F 115, S 8, H M 569091, I/A 20 ( 9.02.21).

03 de Agosto de 2018
Ampliacion del objeto social. Adquisici贸n, tenencia, disfrute, administraci贸n, direcci贸n y gestion de valores de entidades residentesen Espa帽a. Datos registrales. T 34458 , F 114, S 8, H M 569091, I/A 19 (27.07.18).

10 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ CASAS ANA MARIA. Datos registrales. T 34458 , F 114, S 8, H M 569091, I/A 18(31.10.17).

03 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA MARINA LAURA. Apo.Sol.: GARCIA MARINA LAURA. Nombramientos. Apoderado:HAGGAR NICHOLAS ROBERT;DE CASTILLA LINARES ALVARO;HAGGAR NICHOLAS ROBERT;HAGGAR NICHOLASROBERT;DE CASTILLA LINARES ALVARO. Datos registrales. T 34458 , F 113, S 8, H M 569091, I/A 17 (26.07.17).

27 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apoderado: CASTILLA LINARES ALVARO DE;SAN JOSE VICENTE BORJA. Datos registrales. T 34458 , F 113,S 8, H M 569091, I/A 16 (20.10.16).

20 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apoderado: MORLET EMMANUEL. Datos registrales. T 34458 , F 113, S 8, H M 569091, I/A 15 (11.10.16).

19 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: MORI脩IGO MARQUEZ INES. Datos registrales. T 34458 , F 112, S 8, H M 569091, I/A 14 (10.05.16).

15 de Abril de 2016
Revocaciones. Apoderado: GARCIA PICAZO ANDRES. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA PICAZO ANDRES;PONCEGUTIERREZ IGNACIO. Datos registrales. T 31626 , F 97, S 8, H M 569091, I/A 10 ( 7.04.16).

Revocaciones. Apoderado: PELIZZARI GUSTAVO DANIEL LORENZO;PONCE GUTIERREZ IGNACIO;NOBLEJAS SANCHEZ GILANTONIO;QUIJANO RIESTRA ALVARO;SECO DE HERRERA BENITEZ CARLOS ALBERTO;BARRO MANUEL IGNACIO;MARTINMORAN SANDRA MARIA;GARCIA MARINA LAURA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PONCE GUTIERREZ IGNACIO;MARTINMORAN SANDRA;BARRO ROBLES MANUEL IGNACIO;ROMERO-CAMACHO SILOS CARLOS;SIGMAN GOLD LUCAS;QUIJANORIESTRA ALVARO;SECO DE HERRERA BENITEZ CARLOS ALBERTO;GARCIA MARINA LAURA;DIAZ MARTINEZGASTON;GUTIERREZ FLOREZ ELISA-ISABEL. Datos registrales. T 31626 , F 97, S 8, H M 569091, I/A 11 ( 7.04.16).

Revocaciones. Apoderado: ROMERO-CAMACHO SILOS CARLOS;GUTIERREZ FLOREZ ELISA-ISABEL;PELIZZARI GUSTAVODANIEL LORENZO;PONCE GUTIERREZ IGNACIO;ALCALDE GIRAUDO ISABEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROMERO-CAMACHO SILOS CARLOS;GUTIERREZ FLOREZ ELISA-ISABEL. Apo.Manc.: PONCE GUTIERREZ IGNACIO;MARTIN MORANSANDRA;BARRO ROBLES MANUEL IGNACIO;SIGMAN GOLD LUCAS. Datos registrales. T 34458 , F 111, S 8, H M 569091, I/A 12( 7.04.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: PONCE GUTIERREZ IGNACIO;MARTIN MORAN SANDRA;ROMERO-CAMACHO SILOSCARLOS;QUIJANO RIESTRA ALVARO;GARCIA MARINA LAURA;GUTIERREZ FLOREZ ELISA-ISABEL;DE LASSALETTAFERNANDEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 34458 , F 112, S 8, H M 569091, I/A 13 ( 7.04.16).

07 de Abril de 2016
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Cambio de domicilio social. C/ MANUEL POMBO ANGULO 28 3 Y 4(MADRID). Datos registrales. T 31626 , F 96, S 8, H M 569091, I/A 9 (30.03.16).

08 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: PELIZZARI GUSTAVO DANIEL LORENZO;PONCE GUTIERREZ IGNACIO;ALCALDE GIRAUDOISABEL.Secretario: ALCALDE GIRAUDO ISABEL. Presidente: PELIZZARI GUSTAVO DANIEL LORENZO. Nombramientos. Adm.Mancom.: BARRO ROBLES MANUEL IGNACIO;PONCE GUTIERREZ IGNACIO;MARTIN MORAN MARIA SANDRA. Otros

19 de Agosto de 2014
Revocaciones. Apoderado: ALCALDE GIRAUDO ISABEL. Nombramientos. Apoderado: MARTIN MORAN SANDRAMARIA;GARCIA MARINA LAURA. Datos registrales. T 31626 , F 95, S 8, H M 569091, I/A 6 (11.08.14).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARINA LAURA. Datos registrales. T 31626 , F 96, S 8, H M 569091, I/A 7 (11.08.14).

29 de Julio de 2014
Cambio de objeto social. El desarrollo de todas las actividades que sean propias de un laboratorio farmac茅utico, incluido pero nolimitado a la titularidad, compraventa, importaci贸n, exportaci贸n, investigaci贸n y desarrollo, fabricaci贸n,. Datos registrales. T 31626 , F95, S 8, H M 569091, I/A 5 (22.07.14).

16 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: ROMERO CAMACHO SILOS CARLOS;GUTIERREZ FLOREZ ELISA-ISABEL;PELIZZARI GUSTAVODANIEL LORENZO;PONCE GUTIERREZ IGNACIO;ALCALDE GIRAUDO ISABEL. Datos registrales. T 31626 , F 94, S 8, H M569091, I/A 3 ( 9.12.13).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA PICAZO ANDRES. Datos registrales. T 31626 , F 95, S 8, H M 569091, I/A 4 ( 9.12.13).

09 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: PELIZZARI GUSTAVO DANIEL LORENZO;PONCE GUTIERREZ IGNACIO;ALCALDE GIRAUDOISABEL;NOBLEJAS SANCHEZ GIL ANTONIO;QUIJANO RIESTRA ALVARO;SECO DE HERRERA BENITEZ CARLOSALBERTO;BARRO MANUEL IGNACIO. Datos registrales. T 31626 , F 92, S 8, H M 569091, I/A 2 (28.11.13).

04 de Diciembre de 2013
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 8.11.13. Objeto social: - La adquisici贸n, tenencia, disfrute, administraci贸n, direcci贸n ygesti贸n de valores y/o acciones de sociedades o entidades espa帽olas o extranjeras, residentes en Espa帽a o en extranjero, pudiendorealizar toda clase de inversi贸n mobiliaria por cuenta propia, con excepci贸n de las actividades objeto.. Domicilio: C/ QUINTANAPALLA2 4 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDINGSL. Nombramientos. Consejero: PELIZZARI GUSTAVO DANIEL LORENZO;PONCE GUTIERREZ IGNACIO;ALCALDE GIRAUDOISABEL.Secretario: ALCALDE GIRAUDO ISABEL. Presidente: PELIZZARI GUSTAVO DANIEL LORENZO. Datos registrales. T31626 , F 90, S 8, H M 569091, I/A 1 (26.11.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n