Buscador CIF Logo

Actos BORME Lean Corporate Services Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Lean Corporate Services Sl

Actos BORME Lean Corporate Services Sl - B88448469

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Lean Corporate Services Sl con CIF B88448469

馃敊 Perfil de Lean Corporate Services Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Lean Corporate Services Sl

21 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apoderado: BERDEAL PALEO SANDRA. Datos registrales. T 41443 , F 213, S 8, H M 700765, I/A 28 (14.10.22).

Revocaciones. Apoderado: ATALOVICOVA GABRIELA. Datos registrales. T 41443 , F 214, S 8, H M 700765, I/A 29 (14.10.22).

Otros conceptos: Complementado el poder otorgado a do帽a Laura S谩nchez Moz煤n, que caus贸 la inscripci贸n 26. Datos registrales.T 41443 , F 214, S 8, H M 700765, I/A 30 (14.10.22).

Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 11. Prestaciones accesorias.. Datos registrales. T 41443 , F 214, S 8, H M700765, I/A 31 (14.10.22).

27 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO. Datos registrales. T 41443 , F 213, S 8, H M 700765,I/A 27 (20.05.22).

18 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO. Nombramientos. Vsecr2.NC: DE GONZALOMARTINEZ RODRIGO. SecreNoConsj: BERDEAL PALEO SANDRA. Datos registrales. T 41443 , F 212, S 8, H M 700765, I/A 25(11.03.22).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA DOMINGUEZ MARIA CRUZ. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ MOZUN LAURA.Datos registrales. T 41443 , F 212, S 8, H M 700765, I/A 26 (11.03.22).

04 de Marzo de 2022
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 41443 , F 212, S 8, H M 700765,I/A 24 (25.02.22).

14 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CERVANTES MUI脩A MANUEL. Datos registrales. T 41443 , F 211, S 8, H M 700765, I/A 23 (7.02.22).

19 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: NOAIN YOLDI MARIA CARMELA.Datos registrales. T 41443 , F 211, S 8, H M 700765, I/A 22 (12.08.21).

02 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO. Datos registrales. T 41443 , F 210, S 8, H M 700765,I/A 20 (23.02.21).

Nombramientos. Apoderado: ROMERO OLLEROS FRANCISCO. Datos registrales. T 41443 , F 211, S 8, H M 700765, I/A 21(23.02.21).

23 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: ROJAS JIMENEZ MANUELA. Datos registrales. T 41443 , F 210, S 8, H M 700765, I/A 19 (16.02.21).

19 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA DOMINGUEZ MARIA CRUZ;CERVANTES MUI脩A MANUEL. Datos registrales. T 39470 ,F 116, S 8, H M 700765, I/A 17 (12.02.21).

Revocaciones. Apoderado: RIVERO ARANDA JUAN JOSE;ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER;ALLER BLANCO MIGUELANGEL;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;FELIP FONT JOAN;FERNANDEZ ROSELLO EVA;MARTINEZ CASTRO SERGIOCARLOS;JUAN FERRER ROSA;RIVERO ARANDA JUAN JOSE;BARCAS LEWKOWICZ HILA;GARCIA ESTEBANJAVIER;LOMBARDIA ESCUDERO ALMUDENA;MAYOR BELLOSTA MARTA;SISO GURRIARAN MAGIN;TOTUSAUS CALVEJORDI;TREPAT FONT RAMON;VELASCO MIRANDA IRENE;FLOREZ ASTORGA FRANCISCO JAVIER;DIAZ DE TERAN LOPEZMARIA;GARCIA CORONADO ANA MARIA;MARTINEZ GARCIA SUSANA;ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL;TAPIA LOPEZENRIQUE;JIMENEZ SOLER GUILLERMO;GOMEZ FEBREL BALTASAR;FERNANDEZ ROSELLO EVA. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZGUERRERO SANTIAGO;LOMBARDIA ESCUDERO ALMUDENA;ORTIZ PERDICES IGNACIO;GALLEGO SALAS JOSE MIGUEL.Datos registrales. T 41443 , F 210, S 8, H M 700765, I/A 18 (12.02.21).

16 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: AGUIRRE GONZALEZ JOAQUIN. Consejero: BORRAS GOMEZ CESAR;DUQUE COLINOLAURA;TAPIA LOPEZ ENRIQUE. Presidente: ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL. VsecrNoConsj: MESEGUER BOFILL AINA.Nombramientos. SecreNoConsj: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO. Consejero: LOPEZ ARTEAGA ALFONSOJAVIER;TOURAL MENDEZ VIRGINIA;RANCHAL MU脩OZ LUIS. VsecrNoConsj: AGUIRRE GONZALEZ JOAQUIN. Presidente:OLAIZOLA CASIN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 39470 , F 112, S 8, H M 700765, I/A 13 ( 9.02.21).

Nombramientos. Apoderado: MA脩E CUIXO MARC. Datos registrales. T 39470 , F 113, S 8, H M 700765, I/A 14 ( 9.02.21).

Nombramientos. Apoderado: CATON SALAS MARIA BELEN. Datos registrales. T 39470 , F 114, S 8, H M 700765, I/A 15 (9.02.21).

Nombramientos. Apoderado: FLASKA ONDREJ;ATALOVICOVA GABRIELA;FUKAS MARTIN;KURUC FRANTISEK;MAKATURATOMAS;VALENTOVIC PETER. Datos registrales. T 39470 , F 115, S 8, H M 700765, I/A 16 ( 9.02.21).

30 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ CAGIGAS MARIA ISABEL. Nombramientos. Consejero: OLAIZOLA CASIN FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 39470 , F 112, S 8, H M 700765, I/A 12 (23.11.20).

03 de Agosto de 2020
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 39470 , F 112, S 8, H M 700765, I/A 11 (27.07.20).

29 de Julio de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO;LOMBARDIA ESCUDERO ALMUDENA;ORTIZ PERDICESIGNACIO;GALLEGO SALAS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 39470 , F 111, S 8, H M 700765, I/A 10 (22.07.20).

21 de Mayo de 2020
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GONZALEZ ALFARO ISABEL. Nombramientos. Consejero: TAPIA LOPEZENRIQUE;RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO;GOMEZ CAGIGAS MARIA ISABEL;PASCUAL IZQUIERDO JOSE MARIA.VsecrNoConsj: MESEGUER BOFILL AINA. Datos registrales. T 39470 , F 110, S 8, H M 700765, I/A 8 (13.05.20).

P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 39470 , F 111, S 8, H M 700765, I/A 9 (13.05.20).

09 de Marzo de 2020
Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 6 y 7 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 39470 , F 110, S 8, H M700765, I/A 7 ( 2.03.20).

19 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ROSELLO EVA. Datos registrales. T 39470 , F 109, S 8, H M 700765, I/A 6 (12.12.19).

08 de Agosto de 2019
Nombramientos. Presidente: ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL. SecreNoConsj: AGUIRRE GONZALEZ JOAQUIN. VsecrNoConsj:GONZALEZ ALFARO ISABEL. Datos registrales. T 39470 , F 106, S 8, H M 700765, I/A 2 ( 1.08.19).

Nombramientos. Apoderado: RIVERO ARANDA JUAN JOSE;ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER;ALLER BLANCO MIGUELANGEL;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;FELIP FONT JOAN;FERNANDEZ ROSELLO EVA;MARTINEZ CASTRO SERGIOCARLOS;JUAN FERRER ROSA;RIVERO ARANDA JUAN JOSE;BARCAS LEWKOWICZ HILA;GARCIA ESTEBANJAVIER;LOMBARDIA ESCUDERO ALMUDENA;MAYOR BELLOSTA MARTA;SISO GURRIARAN MAGIN;TOTUSAUS CALVEJORDI;TREPAT FONT RAMON;VELASCO MIRANDA IRENE;FLOREZ ASTORGA FRANCISCO JAVIER;DIAZ DE TERAN LOPEZMARIA. Datos registrales. T 39470 , F 107, S 8, H M 700765, I/A 3 ( 1.08.19).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA CORONADO ANA MARIA;MARTINEZ GARCIA SUSANA. Datos registrales. T 39470 , F108, S 8, H M 700765, I/A 4 ( 1.08.19).

Nombramientos. Apoderado: ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL;TAPIA LOPEZ ENRIQUE;JIMENEZ SOLER GUILLERMO;GOMEZFEBREL BALTASAR. Datos registrales. T 39470 , F 108, S 8, H M 700765, I/A 5 ( 1.08.19).

06 de Agosto de 2019
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 22.07.19. Objeto social: La prestaci贸n de servicios relacionados con la transformaci贸nempresarial, la gesti贸n de procesos y operativa economico-financiera, de recursos humanos, de compras y de servicios generales.Domicilio: AVDA DE SAN LUIS 77 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: NATURGYENERGY GROUP SA. Nombramientos. Consejero: ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL;BORRAS GOMEZ CESAR;DUQUE COLINOLAURA. Datos registrales. T 39470 , F 104, S 8, H M 700765, I/A 1 (30.07.19).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n