Actos BORME de Lean Customer Services Sl
03 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: NOVES SALTO CARLOS. Datos registrales. T 39470 , F 219, S 8, H M 700766, I/A 30 (27.03.23).
26 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. 11. Prestaciones accesorias.-. Datos registrales. T 39470 , F 218, S 8, H M 700766, I/A 29 (19.10.22).
24 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: BERDEAL PALEO SANDRA. Datos registrales. T 39470 , F 217, S 8, H M 700766, I/A 26 (17.10.22).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ATALOVICOVA GABRIELA. Datos registrales. T 39470 , F 218, S 8, H M 700766, I/A 27 (17.10.22).
Otros conceptos: Complementado el poder otorgado a don Manuel Alvarado Soto, en la inscripci贸n 18陋 de la hoja social. Datosregistrales. T 39470 , F 218, S 8, H M 700766, I/A 28 (17.10.22).
27 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO. Datos registrales. T 39470 , F 217, S 8, H M 700766, I/A25 (20.05.22).
17 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO. Nombramientos. SecreNoConsj: BERDEALPALEO SANDRA. VsecrNoConsj: DE GONZALO MARTINEZ RODRIGO. Datos registrales. T 39470 , F 217, S 8, H M 700766, I/A 24(10.03.22).
02 de Marzo de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39470 , F 216, S 8, H M 700766,I/A 23 (23.02.22).
16 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ GUERREROSANTIAGO. Datos registrales. T 39470 , F 216, S 8, H M 700766, I/A 22 ( 9.08.21).
16 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVARADO SOTO MANUEL. Datos registrales. T 39470 , F 129, S 8, H M 700766, I/A 18 (9.04.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO OLLEROS FRANCISCO. Datos registrales. T 39470 , F 215, S 8, H M 700766, I/A 19 (9.04.21).
Revocaciones. Apoderado: RIVERO ARANDA JUAN JOSE;ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER;ALLER BLANCO MIGUELANGEL;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;FELIP FONT JOAN;FERNANDEZ ROSELLO EVA;MARTINEZ CASTRO SERGIOCARLOS;JUAN FERRER ROSA;RIVERO ARANDA JUAN JOSE;BARCAS LEWKOWICZ HILA;GARCIA ESTEBANJAVIER;LOMBARDIA ESCUDERO ALMUDENA;MAYOR BELLOSTA MARTA;SISO GURRIARAN MAGIN;TOTUSAUS CALVEJORDI;TREPAT FONT RAMON;VELASCO MIRANDA IRENE;FLOREZ ASTORGA FRANCISCO JAVIER;DIAZ DE TERAN LOPEZMARIA;GARCIA CORONADO ANA MARIA;MARTINEZ GARCIA SUSANA;ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL;TAPIA LOPEZENRIQUE;JIMENEZ SOLER GUILLERMO;GOMEZ FEBREL BALTASAR;FERNANDEZ ROSELLO EVA. Apo.Man.Soli: NOAIN YOLDIMARIA CARMELA;SAN MILLAN DEFAUCE CESAR;PARADA PRIETO EVA;RICO GOMEZ LAURA. Datos registrales. T 39470 , F215, S 8, H M 700766, I/A 20 ( 9.04.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO. Datos registrales. T 39470 , F 216, S 8, H M 700766,I/A 21 ( 9.04.21).
15 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: AGUIRRE GONZALEZ JOAQUIN. VsecrNoConsj: MESEGUER BOFILL AINA. Consejero:BORRAS GOMEZ CESAR. Presidente: ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL. Consejero: VALENTINES BALCELLS JORDI;CODORNIUCASTELLO JOSEP;MARQUES GUTIERREZ XAVIER. Nombramientos. SecreNoConsj: BARREDA VELASCO CARLOSMAXIMILIANO. VsecrNoConsj: AGUIRRE GONZALEZ JOAQUIN. Consejero: LOPEZ ARTEAGA ALFONSO JAVIER;TOURALMENDEZ VIRGINIA;RANCHAL MU脩OZ LUIS;NOAIN YOLDI MARIA CARMELA. Presidente: OLAIZOLA CASIN FRANCISCO JAVIER.Cambio de objeto social. la prestaci贸n de servicios relacionados con la atenci贸n al cliente por diversos canales para la contrataci贸n,la gesti贸n de accesos, la facturaci贸n, la recaudaci贸n y la gesti贸n de impagados de los clientes, la programaci贸n de operacionesdomiciliarias en el sector del gas y la electricidad, ... Datos registrales. T 39470 , F 126, S 8, H M 700766, I/A 14 ( 8.04.21).
Nombramientos. Apoderado: PINTOR REVERTE RICARDO. Datos registrales. T 39470 , F 127, S 8, H M 700766, I/A 15 (8.04.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ONDREJ FLASKA;ATALOVICOVA GABRIELA;FUKAS MARTIN;KURUC FRANTISEK;MAKATURATOMAS;VALENTOVIC PETER. Datos registrales. T 39470 , F 128, S 8, H M 700766, I/A 16 ( 8.04.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPADA JURADO LAURA. Datos registrales. T 39470 , F 129, S 8, H M 700766, I/A 17 ( 8.04.21).
29 de Marzo de 2021Fe de erratas: Se public贸 por error la inscripci贸n 9陋 de fecha 12/03/2021 de rectificaci贸n y de cese y nombramiento de vicesecretariono consejero en el folio 126, siendo lo correcto la fecha 19/06/2020 y el folio 123. Datos registrales. T 39470 , F 123, S 8, H M700766, I/A 9 (19.06.20).
22 de Marzo de 2021Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 9潞. Datos registrales. T 39470 , F 126, S 8, H M 700766, I/A 13 (12.03.21).
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GONZALEZ ALFARO ISABEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: MESEGUER BOFILL AINA. Fede erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 9陋 la publicaci贸n del cese de la vicesecretaria no consejera GONZALEZ ALFAROISABEL y el nombramiento de MESEGUER BOFILL AINA para ese mismo cargo. Datos registrales. T 39470 , F 126, S 8, H M700766, I/A 9 (12.03.21).
01 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MENENDEZ PILAR;GOMEZ CAGIGAS MARIA ISABEL. Nombramientos. Consejero:OLAIZOLA CASIN FRANCISCO JAVIER;MARQUES GUTIERREZ XAVIER. Datos registrales. T 39470 , F 125, S 8, H M 700766, I/A12 (24.11.20).
03 de Agosto de 2020Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 39470 , F 125, S 8, H M 700766, I/A 11 (27.07.20).
29 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: NOAIN YOLDI MARIA CARMELA;SAN MILLAN DEFAUCE CESAR;PARADA PRIETO EVA;RICOGOMEZ LAURA. Datos registrales. T 39470 , F 124, S 8, H M 700766, I/A 10 (22.07.20).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Consejero: VALENTINES BALCELLS JORDI;CODORNIU CASTELLO JOSEP;GOMEZ CAGIGAS MARIAISABEL;PASCUAL IZQUIERDO JOSE MARIA. Datos registrales. T 39470 , F 123, S 8, H M 700766, I/A 9 (19.06.20).
20 de Mayo de 2020P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 39470 , F 123, S 8, H M 700766, I/A 8 (12.05.20).
27 de Febrero de 2020Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6 Y 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T39470 , F 123, S 8, H M 700766, I/A 7 (20.02.20).
20 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ROSELLO EVA. Datos registrales. T 39470 , F 122, S 8, H M 700766, I/A 6 (13.12.19).
13 de Agosto de 2019Nombramientos. SecreNoConsj: AGUIRRE GONZALEZ JOAQUIN. VsecrNoConsj: GONZALEZ ALFARO ISABEL. Presidente:ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 39470 , F 119, S 8, H M 700766, I/A 2 ( 6.08.19).
Nombramientos. Apoderado: RIVERO ARANDA JUAN JOSE;ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER;ALLER BLANCO MIGUELANGEL;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;FELIP FONT JOAN;FERNANDEZ ROSELLO EVA;MARTINEZ CASTRO SERGIOCARLOS;JUAN FERRER ROSA;RIVERO ARANDA JUAN JOSE;BARCAS LEWKOWICZ HILA;GARCIA ESTEBANJAVIER;LOMBARDIA ESCUDERO ALMUDENA;MAYOR BELLOSTA MARTA;SISO GURRIARAN MAGIN;TOTUSAUS CALVEJORDI;TREPAT FONT RAMON;VELASCO MIRANDA IRENE;FLOREZ ASTORGA FRANCISCO JAVIER;DIAZ DE TERAN LOPEZMARIA. Datos registrales. T 39470 , F 120, S 8, H M 700766, I/A 3 ( 6.08.19).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA CORONADO ANA MARIA;MARTINEZ GARCIA SUSANA. Datos registrales. T 39470 , F121, S 8, H M 700766, I/A 4 ( 6.08.19).
Nombramientos. Apoderado: ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL;TAPIA LOPEZ ENRIQUE;JIMENEZ SOLER GUILLERMO;GOMEZFEBREL BALTASAR. Datos registrales. T 39470 , F 121, S 8, H M 700766, I/A 5 ( 6.08.19).
06 de Agosto de 2019Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 22.07.19. Objeto social: La prestaci贸n de servicios relacionados con la atenci贸n al clientepor diversos canales para la contrataci贸n, la gesti贸n de accesos, la lectura de contadores, la facturaci贸n, la recaudaci贸n y la gesti贸n deimpagados de los clientes, la programaci贸n de operaciones domiciliarias en el sector del... Domicilio: AVDA DE SAN LUIS 77(MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: NATURGY ENERGY GROUP SA.Nombramientos. Consejero: ALLER BLANCO MIGUEL ANGEL;BORRAS GOMEZ CESAR;MARTINEZ MENENDEZ PILAR. Datosregistrales. T 39470 , F 117, S 8, H M 700766, I/A 1 (30.07.19).