Actos BORME de Leansis Expertos En Productividad Sl
30 de Noviembre de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL. Datos registrales. T 8179, L 5471, F 115, S 8,H V 103305, I/A 27 (23.11.23).
15 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO ANTONIO;TRIGO GONZALEZ ANGEL LUIS;PAREDESGONZALEZ SYLVIA;FRANCO REAL PILAR;LLAVERO RIVERA DIEGO;ZUAZO FARIAS IGNACIO;GARCIA HERNANDEZ MARIAEULALIA;MU脩OZ RODRIGUEZ JOAQUIN;GARCIA GOSALBEZ PABLO;ARNANDIS RODRIGUEZ JUAN MANUEL;LOZANOGONZALEZ EDUARDO ENRIQUE;GARCIA ICHER JUAN FELIPE;GIMENEZ MU脩OZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 8179, L5471, F 114, S 8, H V 103305, I/A 26 ( 7.11.23).
30 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO ANTONIO;TRIGO GONZALEZ ANGEL LUIS;PAREDESGONZALEZ SYLVIA;ZUAZO FARIAS IGNACIO;GARCIA HERNANDEZ MARIA EULALIA;FRANCO REAL PILAR;LLAVERO RIVERADIEGO;MU脩OZ RODRIGUEZ JOAQUIN;GARCIA GOSALBEZ PABLO;ARNANDIS RODRIGUEZ JUAN MANUEL;LOZANOGONZALEZ EDUARDO ENRIQUE;GARCIA ICHER JUAN FELIPE;HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO;MURRIA TATOCESAR FERNANDO. Datos registrales. T 8179, L 5471, F 113, S 8, H V 103305, I/A 25 (23.10.23).
14 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: GRUSZKA SUDOL SABINA JANINA;MAJ ILONA DOROTA. Datos registrales. T 8179, L 5471, F 113, S8, H V 103305, I/A 24 ( 7.09.23).
19 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA ICHER JUAN FELIPE;HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO;MURRIA TATO CESARFERNANDO. Datos registrales. T 8179, L 5471, F 113, S 8, H V 103305, I/A 23 (12.04.23).
18 de Abril de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SGS TECNOS SA. Datos registrales. T 8179, L 5471, F 112, S 8, H V 103305, I/A
31 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ICHER JUAN FELIPE;MURRIA TATO CESAR FERNANDO;HERMENEGILDO CAUDEVILLAFERNANDO. Secretario: HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO. Nombramientos. Secretario: LLAVERO RIVERA DIEGO.Datos registrales. T 8179, L 5471, F 112, S 8, H V 103305, I/A 21 (24.03.23).
12 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: ZUREK MARTA PAULINA;KRAWIEC PAWEL MARCIN. Datos registrales. T 8179, L 5471, F 112, S 8,H V 103305, I/A 20 ( 5.05.22).
17 de Enero de 2022Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datosregistrales. T 8179, L 5471, F 112, S 8, H V 103305, I/A 19 (10.01.22).
17 de Mayo de 2021Cambio de domicilio social. RONDA NARCISO MONTURIOL 17 A - PARQUE TECNOLOGICO (PATERNA). Datos registrales. T8095, L 5388, F 118, S 8, H V 103305, I/A 18 (10.05.21).
05 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: MAZUREK BRYLKA MARTYNA;GDANSKA MALGORZATA;IWANSKA BARBARA MARIA;GRUSZKASUDOL SABINA JANINA;MATURA NATALIA GABRIELA;TLALKA MATEUSZ SZYMON;MAJ ILONA DOROTA. Datos registrales. T8095, L 5388, F 118, S 8, H V 103305, I/A 17 (27.04.21).
11 de Mayo de 2020Nombramientos. Apoderado: CABALLERO GARCIA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 8095, L 5388, F 119, S 8, H V 103305,I/A 16 ( 4.05.20).
28 de Noviembre de 2019Revocaciones. Auditor: EVIDENCE AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL.Datos registrales. T 8095, L 5388, F 118, S 8, H V 103305, I/A 15 (21.11.19).
26 de Abril de 2019Otros conceptos: Modificaci贸n del regimen de transmisi贸n de las participaciones sociales, establecimiento de prestaci贸n accesoria ymodificaci贸n y refundici贸n de los estatutos sociales. Datos registrales. T 8095, L 5388, F 115, S 8, H V 103305, I/A 14 (18.04.19).
03 de Abril de 2019Nombramientos. Auditor: EVIDENCE AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 8095, L 5388, F115, S 8, H V 103305, I/A 13 (27.03.19).
21 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GARCIA ICHER JUAN FELIPE;MURRIA TATO CESAR FERNANDO;HERMENEGILDOCAUDEVILLA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: GARCIA ICHER JUAN FELIPE;HERMENEGILDO CAUDEVILLAFERNANDO;MURRIA TATO CESAR FERNANDO;GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO ANTONIO;TRIGO GONZALEZ ANGELLUIS;FRANCO REAL PILAR;LLAVERO RIVERA DIEGO. Presidente: GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO ANTONIO. Secretario:HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidariosa Consejo de administraci贸n. Se fija en SIETE el n煤mero de componentes del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 8095,L 5388, F 113, S 8, H V 103305, I/A 10 (14.03.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO ANTONIO;TRIGO GONZALEZ ANGEL LUIS;PAREDESGONZALEZ SYLVIA;ZUAZO FARIAS IGNACIO;GARCIA HERNANDEZ MARIA EULALIA;FRANCO REAL PILAR;LLAVERO RIVERADIEGO;MU脩OZ RODRIGUEZ JOAQUIN;GARCIA GOSALBEZ PABLO;ARNANDIS RODRIGUEZ JUAN MANUEL;LOZANOGONZALEZ EDUARDO ENRIQUE;GARCIA ICHER JUAN FELIPE;HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO;MURRIA TATOCESAR FERNANDO. Datos registrales. T 8095, L 5388, F 113, S 8, H V 103305, I/A 11 (14.03.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA ICHER JUAN FELIPE;HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO;MURRIA TATO CESARFERNANDO. Datos registrales. T 8095, L 5388, F 115, S 8, H V 103305, I/A 12 (14.03.19).
23 de Enero de 2014Modificaciones estatutarias. Modificado el art. 17潞 de los Estatutos en cuanto a la retribuci贸n del 贸rgano de Administraci贸n.. Datosregistrales. T 8095, L 5388, F 113, S 8, H V 103305, I/A 9 (16.01.14).
20 de Mayo de 2013Cambio de domicilio social. RONDA NARCISO MONTURIOL 6 - DESPACHO 8B EDIFICIO (PATERNA). Datos registrales. T8095, L 5388, F 112, S 8, H V 103305, I/A 8 (10.05.13).
09 de Mayo de 2012Cambio de domicilio social. AVDA CORTES VALENCIANAS 58 - EDIFICIO SOROLLA. NIV (VALENCIA). Cambio de objetosocial. La formaci贸n y la elaboraci贸n, edici贸n y comercializaci贸n de materiales formativos en cualquier tipo de soporte, en materia deIngenier铆a Industrial. Datos registrales. T 8095, L 5388, F 112, S 8, H V 103305, I/A 7 (26.04.12).
29 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 335,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.345,00 Euros. Datos registrales. T 8095, L 5388, F 112, S 8, HV 103305, I/A 6 (20.01.10).