Actos BORME de Leco De Sitges Sl
13 de Diciembre de 2018Revocaciones. ADM.UNICO: SOLER FERNANDEZ RAMON. LIQUIDADOR: RIERA LOPEZ OLGA. Nombramientos.LIQUIDADOR: RIERA LOPEZ OLGA. Extinci贸n. Datos registrales. T 28902 , F 158, S 8, H B 146136, I/A 7 ( 4.12.18).
03 de Abril de 2018Modificaciones estatutarias. ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Cambio dedomicilio social. PS DEL DOCTOR BENAPRES Num.43 P.BJ (SITGES). Datos registrales. T 28902 , F 158, S 8, H B 146136, I/A 6(23.03.18).
12 de Enero de 2016Revocaciones. ADM.CONJUNTO: SOLER FERNANDEZ JOSEP;SOLER FERNANDEZ RAMON. Nombramientos. ADM.UNICO:SOLER FERNANDEZ RAMON. Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO:DON RAMON SOLER FERNANDEZ. Datos registrales. T 28902 , F 157, S 8, H B 146136, I/A 5 (30.12.15).
03 de Noviembre de 2014Modificaciones estatutarias. ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 28902 , F 157, S 8, H B 146136, I/A 4 (23.10.14).
08 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 34.978,20 Euros. Resultante Suscrito: 38.584,20 Euros. Datos registrales. T 28902 , F 157, S 8, H B146136, I/A 3 (24.02.10).