Buscador CIF Logo

Actos BORME Lence Torres Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Lence Torres Sl

Actos BORME Lence Torres Sl - B27207588

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Lugo para Lence Torres Sl con CIF B27207588

馃敊 Perfil de Lence Torres Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Lugo

Actos BORME de Lence Torres Sl

31 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: LEIRO CASTRO ALBERTO. Aud.C.Con.: LEIRO CASTRO ALBERTO. Aud.Supl.: MIGUELEZ MARTINEZBEGO脩A. Aud.Supl.C.C: MIGUELEZ MARTINEZ BEGO脩A. Datos registrales. T 563 , F 222, S 8, H LU 4705, I/A 38 (20.10.23).

21 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: LEIRO CASTRO ALBERTO. Aud.C.Con.: LEIRO CASTRO ALBERTO. Aud.Supl.: MIGUELEZ MARTINEZBEGO脩A. Aud.Supl.C.C: MIGUELEZ MARTINEZ BEGO脩A. Datos registrales. T 519 , F 154, S 8, H LU 4705, I/A 36 (12.12.22).

26 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: ZEHNDER ALEXANDER. Datos registrales. T 519 , F 153, S 8, H LU 4705, I/A 35 (12.09.22).

26 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: CANTO VEIGA AIDA MARIA. Datos registrales. T 519 , F 153, S 8, H LU 4705, I/A 34 (14.07.22).

25 de Febrero de 2022
Nombramientos. Aud.C.Con.: LEIRO CASTRO ALBERTO. Aud.Supl.C.C: MIGUELEZ MARTINEZ BEGO脩A. Reelecciones.Auditor: LEIRO CASTRO ALBERTO. Aud.Supl.: MIGUELEZ MARTINEZ BEGO脩A. Datos registrales. T 519 , F 153, S 8, H LU 4705,I/A 33 (11.02.22).

27 de Septiembre de 2021
Modificaciones estatutarias. Refundici贸n de estatutos.. Datos registrales. T 519 , F 151, S 8, H LU 4705, I/A 32 (17.09.21).

15 de Septiembre de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.140.038,05 Euros. Resultante Suscrito: 38.982.212,25 Euros. Datos registrales. T 519 ,F 150, S 8, H LU 4705, I/A 31 ( 6.09.21).

29 de Julio de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CANTO VEIGA AIDA MARIA. Datos registrales. T 519 , F 150, S 8, H LU 4705, I/A 30 (22.07.20).

03 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Presidente: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Con.Delegado:LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Secretario: LENCE FERREIRO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Presidente: LENCEFERREIRO MARIA DEL CARMEN. Secretario: LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Con.Delegado: LENCE FERREIRO MARIA DELCARMEN. Datos registrales. T 519 , F 150, S 8, H LU 4705, I/A 29 (25.06.19).

05 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LENCE FERREIRO LUIS JESUS;GARCIA FERNANDEZ JESUS;CANTO VEIGA AIDA MARIA.Datos registrales. T 419 , F 208, S 8, H LU 4705, I/A 28 (20.02.19).

13 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LENCE FERREIRO JESUS LUIS;LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Nombramientos. Consejero:LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Presidente: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Con.Delegado: LENCE FERREIRO JESUS LUIS.Consejero: LENCE FERREIRO MARIA DEL CARMEN. Secretario: LENCE FERREIRO MARIA DEL CARMEN. Consejero: LENCEFERREIRO LUIS JESUS;CANTO VEIGA AIDA MARIA;GARCIA FERNANDEZ JESUS. Aud.Supl.: MIGUELEZ MARTINEZ BEGO脩A.Reelecciones. Auditor: LEIRO CASTRO ALBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 419 , F 208, S 8, H LU 4705, I/A 27 (21.01.19).

11 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Con.Delegado: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Presidente:LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Consejero: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Vicepresid.: LENCE FERREIRO MARIA JESUS.Consejero: LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Secretario: LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Consejero: LENCE FERREIRO MARIADEL CARMEN;ZEHNDER ALEXANDER. Nombramientos. Adm. Unico: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Otros conceptos:

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: LENCE FERREIRO JESUSLUIS;LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 419 , F 208, S 8, H LU 4705, I/A 25 (24.11.17).

24 de Abril de 2017
Nombramientos. Apoderado: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Datos registrales. T 419 , F 207, S 8, H LU 4705, I/A 23(12.04.17).

23 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Presidente: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Consejero:LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Secretario: LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Consejero: LENCE FERREIRO MARIA DELCARMEN;LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Con.Delegado: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Cons.Del.Sol: LENCE FERREIROMARIA JESUS;LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Revocaciones. Apoderado: LENCE FERREIRO MARIA DEL CARMEN.Nombramientos. Consejero: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Con.Delegado: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Presidente: LENCEFERREIRO JESUS LUIS. Consejero: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Vicepresid.: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Consejero:LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Secretario: LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Consejero: LENCE FERREIRO MARIA DELCARMEN;ZEHNDER ALEXANDER. Datos registrales. T 419 , F 207, S 8, H LU 4705, I/A 22 (13.09.16).

26 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: LEIRO CASTRO ALBERTO;SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICTOR. Datos registrales. T 419 , F 206, S 8,H LU 4705, I/A 21 (18.01.16).

30 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: LEIRO CASTRO ALBERTO. Aud.Supl.: SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICTOR. Datos registrales. T 419 , F206, S 8, H LU 4705, I/A 20 (19.01.13).

16 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Presidente: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Consejero:LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Secretario: LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Consejero: LENCE FERREIRO MARIA DELCARMEN. Cons.Del.Sol: LENCE FERREIRO MARIA JESUS;LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Nombramientos. Consejero: LENCEFERREIRO MARIA JESUS. Presidente: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Consejero: LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Secretario:LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Consejero: LENCE FERREIRO MARIA DEL CARMEN;LENCE FERREIRO JESUS LUIS.Con.Delegado: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Cons.Del.Sol: LENCE FERREIRO MARIA JESUS;LENCE FERREIRO LUIS JESUS.Datos registrales. T 419 , F 205, S 8, H LU 4705, I/A 19 ( 2.01.12).

18 de Julio de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HOTEL CEAO EXPRESS SL. Datos registrales. T 419 , F 204, S 8, H LU 4705, I/A18 ( 6.07.11).

07 de Diciembre de 2010
Ampliacion del objeto social. La tenencia, disfrute, direcci贸n y gesti贸n de acciones, participaciones o cualesquiera otros t铆tulosrepresentativos de los fondos propios de sociedades u otras entidades y la prestaci贸n de servicios de asesoramiento y apoyoa lagesti贸n de las sociedades participadas. Se i excluyen expresamente las. Datos registrales. T 419 , F 204, S 8, H LU 4705, I/A 17(18.11.10).

07 de Junio de 2010
Nombramientos. Apoderado: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Datos registrales. T 410 , F 147, S 8, H LU 4705, I/A 16 (24.05.10).

20 de Mayo de 2010
Revocaciones. Apoderado: LENCE FERREIRO JESUS LUIS. Datos registrales. T 410 , F 147, S 8, H LU 4705, I/A 15 ( 7.05.10).

04 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apoderado: LENCE FERREIRO MARIA JESUS;LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Datos registrales. T 410 , F 145,S 8, H LU 4705, I/A 13 (22.02.10).

Nombramientos. Cons.Del.Sol: LENCE FERREIRO MARIA JESUS;LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Datos registrales. T 410 , F146, S 8, H LU 4705, I/A 14 (22.02.10).

25 de Enero de 2010
Cambio de domicilio social. POLIG DO CEAO, AVENIDA BENIGNO RIVERA- LOCAL 16 10 (LUGO). Datos registrales. T 410 , F145, S 8, H LU 4705, I/A 12 (11.01.10).

22 de Enero de 2010
Nombramientos. Auditor: LEIRO CASTRO ALBERTO. Aud.Supl.: SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICTOR. Datos registrales. T 410 ,F 145, S 8, H LU 4705, I/A 11 ( 9.01.10).

10 de Agosto de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.290.456,65 Euros. Resultante Suscrito: 48.122.250,30 Euros. Datos registrales. T 410 , F 144, S8, H LU 4705, I/A 10 (28.07.09).

08 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Nombramientos. Consejero: LENCE FERREIRO MARIAJESUS. Presidente: LENCE FERREIRO MARIA JESUS. Consejero: LENCE FERREIRO LUIS JESUS. Secretario: LENCE FERREIROLUIS JESUS. Consejero: MARIA DEL CARMEN LENCE FERREIRO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 31.532.787,20 Euros.Resultante Suscrito: 32.073.687,20 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nicoa Consejo de administraci贸n. Cambio de objeto social. I. La venta de combustibles y lubricantes, lavado y engrase de todo tipo deveh铆culos y maquinaria, y el comercio al por mayor y al por menor de cubiertas y c谩maras para todo tipo de veh铆culos y maquinaria yaccesorios y repuestos para los mismos. II. La construcci贸n, promoci贸n, compraventa y arrend. Datos registrales. T 403 , F 114, S 8,H LU 4705, I/A 8 (24.06.09).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 9.758.106,45 Euros. Resultante Suscrito: 41.831.793,65 Euros. Datos registrales. T 403 , F 116, S8, H LU 4705, I/A 9 (24.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n