Actos BORME de Lepazar Xxi Sociedad Anonima
24 de Marzo de 2023Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: IKEMAS DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. Datos registrales. T 1631 , F 84, S 8,H VI 15291, I/A 20 ( 8.03.23).
08 de Febrero de 2023Declaración de unipersonalidad. Socio único: IKEMAS DESARROLLO EMPRESARIAL S.L. Datos registrales. T 1631 , F 83, S8, H VI 15291, I/A 19 (23.01.23).
22 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: LARRAÑAGA OYANGUREN ROBERTO;BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMANMIGUEL ANGEL;ALBA JIMENEZ LUIS MANUEL. Consejero: SARKIS SA. Presidente: SARKIS SA. Consejero: CONSTRUCCIONESPEREZ DE SAN ROMAN SA;ZIKOTZ SA;FRANCO GARAIZABAL GONZALO;BUIL ALDANA IGNACIO. Secretario: FERNANDEZ DETROCONIZ NUÑEZ ALFONSO JOSE. Nombramientos. Consejero: TEKPOLIO FINANCE S.L. Presidente: TEKPOLIO FINANCES.L. Consejero: HYDRA CAPITAL INVESTMENTS S.L. Secretario: HYDRA CAPITAL INVESTMENTS S.L. Con.Delegado: HYDRACAPITAL INVESTMENTS S.L. Consejero: HYDRA CAPITAL EQUITY S.L. Otros conceptos: Se designa a DON JUAN MANUELMUÑOZ FERNANDEZ, con D.N.I. 44874156-Y, como persona física representante de "HYDRA CAPITAL INVESTMENTS, S.L.", quees consejero, secretario y Consejero Delegado de la compañía "LEPAZAR XXI, S.A.".- Se designa a DON MANUEL DELCLAUXLEZAMA-LEGUIZAMON, con D.N.I. 16084724-L, como persona física representante de "TEKPOLIO FINANCE, S.L.", que es consejeroy presidente de la compañía "LEPAZAR XXI, S.A.".- Se designa a DOÑA LAURA IZQUIERDO BORJA, con D.N.I. 44884878-X, comopersona física representante de "HYDRA CAPITAL EQUITY, S.L.", que es consejero de la compañía "LEPAZAR XXI, S.A.".- Datosregistrales. T 1631 , F 82, S 8, H VI 15291, I/A 18 ( 7.12.22).
Revocaciones. Apo.Manc.: ALBA JIMENEZ LUIS MANUEL;BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUELANGEL;BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN JOSE MARIA;LARRAÑAGA OYANGUREN ROBERTO;ROMANOIGARTUA LUIS MARIA;SANCHEZ ALVAREZ JOSU;TARACENA ALBA JUAN MANUEL. Apoderado: ALBA JIMENEZ LUIS MANUEL.Apo.Manc.: CEBAS DE BLAS IBON. Nombramientos. Apo.Manc.: MUÑOZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;DELCLAUX LEZAMA-LEGUIZAMON MANUEL;IZQUIERDO BORJA LAURA;CEBAS DE BLAS IBON. Datos registrales. T 1631 , F 82, S 8, H VI 15291, I/A18 ( 7.12.22).
01 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SARKIS SA;LAGUNKETA SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA;ZIKOTZSA;CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN ROMAN SA;GRUPO PEREZ SAN ROMAN S.L.;GIROA SA. Presidente: SARKIS SA.Consejero: ROMANO IGARTUA LUIS MARIA. Nombramientos. Consejero: SARKIS SA. Presidente: SARKIS SA. Consejero:CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN ROMAN SA;ZIKOTZ SA;GIROA SA;BALLESTER SOLAZ JOSE LUIS;FRANCO GARAIZABALGONZALO;BUIL ALDANA IGNACIO. Otros conceptos: Se designa a DON MIGUEL ANGEL BELTRAN DE OTALORA PEREZ DESAN ROMAN, como persona física representante de la sociedad "CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN ROMAN, S.A.", la cual esConsejera de la compañía "LEPAZAR XXI, S.A. ".- Se designa a DON LUIS MANUEL ALBA JIMENEZ, como persona físicarepresentante de la sociedad "SARKIS, S.A.", la cual es Consejera de la compañía "LEPAZAR XXI, S.A. ".- Se designa a DONROBERTO LARRAÑAGA OYANGUREN, como persona física representante de la sociedad "ZIKOTZ, S.A.", la cual es Consejera de lacompañía "LEPAZAR XXI, S.A. ".- Se designa a DON JUAN MANUEL TARACENA ALBA, como persona física representante de lasociedad "GIROA, S.A.", la cual es Consejera de la compañía "LEPAZAR XXI, S.A. ".- Datos registrales. T 1631 , F 79, S 8, H VI15291, I/A 16 (23.07.19).
31 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: ARRIZABALAGA SAENZ LAUREANO. Datos registrales. T 1631 , F 79, S 8, H VI 15291, I/A 15(18.05.18).
12 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: LEITZONDO GONZALEZ JOSE MARIA GUILLERMO. Nombramientos. Apo.Manc.: CEBAS DE BLASIBON. Reelecciones. Secretario: FERNANDEZ DE TROCONIZ NUÑEZ ALFONSO JOSE. Consejero: SARKIS SA;LAGUNKETASOCIEDAD DE ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA;ZIKOTZ SA;CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN ROMAN SA;GRUPO PEREZSAN ROMAN S.L.;GIROA SA. Presidente: SARKIS SA. Consejero: ROMANO IGARTUA LUIS MARIA. Datos registrales. T 1545 , F144, S 8, H VI 15291, I/A 14 ( 3.05.17).
13 de Diciembre de 2016Reducción de capital. Importe reducción: 702.450,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.987.550,00 Euros. Datos registrales. T 1545 , F143, S 8, H VI 15291, I/A 13 (24.11.16).
29 de Mayo de 2015Ampliación de capital. Suscrito: 560.000,00 Euros. Desembolsado: 560.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.690.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.690.000,00 Euros. Datos registrales. T 1545 , F 142, S 8, H VI 15291, I/A 12 (22.05.15).
19 de Febrero de 2015Ampliación de capital. Suscrito: 300.000,00 Euros. Desembolsado: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.130.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.130.000,00 Euros. Datos registrales. T 1545 , F 141, S 8, H VI 15291, I/A 11 ( 9.02.15).
03 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: ALBA JIMENEZ LUIS MANUEL. Datos registrales. T 1545 , F 141, S 8, H VI 15291, I/A 10 (18.11.13).
25 de Noviembre de 2013Ampliación de capital. Suscrito: 1.530.000,00 Euros. Desembolsado: 1.530.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.830.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.830.000,00 Euros. Datos registrales. T 1479 , F 30, S 8, H VI 15291, I/A 9 ( 7.11.13).
24 de Octubre de 2013Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 915.000,00 Euros. Datos registrales. T 1479 , F 29, S 8, H VI 15291, I/A 8(11.10.13).
12 de Agosto de 2013Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.060.000,00 Euros. Datos registrales. T 1479 , F 28, S 8, H VI 15291, I/A 7 (2.08.13).
14 de Febrero de 2013Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 205.000,00 Euros. Datos registrales. T 1479 , F 27, S 8, H VI 15291, I/A 6 (1.02.13).
27 de Noviembre de 2012Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.045.000,00 Euros. Datos registrales. T 1479 , F 26, S 8, H VI 15291, I/A 5(10.11.12).
25 de Marzo de 2011Constitución. Comienzo de operaciones: 20.10.10. Objeto social: Materialización de la adjudicación definitiva del contrato de cesiónde underecho de superficie para la construcción de un edificio de oficinas municipales y otras infrestructuras y su explotación mediantearrendamiento al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.- Domicilio: C/ PORTAL DE GAMARRA 1 - EDIFICIO DEBA, OFICINA 11 (VITORIA-GASTEIZ). Capital suscrito: 4.300.000,00 Euros. Desembolsado: 1.075.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: SARKISSA;LAGUNKETA SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA;ZIKOTZ SA;CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN ROMANSA;GRUPO PEREZ SAN ROMAN S.L.;GIROA SA. Presidente: SARKIS SA. Secretario: FERNANDEZ DE TROCONIZ NUÑEZALFONSO JOSE. Consejero: ROMANO IGARTUA LUIS MARIA. Datos registrales. T 1479 , F 18, S 8, H VI 15291, I/A 1 ( 5.03.11).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALVAREZ JOSU. Datos registrales. T 1479 , F 23, S 8, H VI 15291, I/A 2 (14.03.11).
Nombramientos. Apoderado: PEÑA PEÑA LORENZO. Datos registrales. T 1479 , F 26, S 8, H VI 15291, I/A 4 (14.03.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: ALBA JIMENEZ LUIS MANUEL;ARRIZABALAGA SAENZ LAUREANO ANSELMO;BELTRAN DEOTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUEL ANGEL;BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN JOSE MARIA;LARRAÑAGAOYANGUREN ROBERTO;LEITZONDO GONZALEZ JOSE MARIA GUILLERMO;ROMANO IGARTUA LUIS MARIA;SANCHEZALVAREZ JOSU;TARACENA ALBA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1479 , F 24, S 8, H VI 15291, I/A 3 (14.03.11).