Actos BORME de Levantina Techlam Sl
06 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apoderado: GARCIA PUCHOL JESUS. Datos registrales. T 4350 , F 158, S 8, H A 172882, I/A 15 (29.08.23).
17 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: ALONSO GERIZ BEATRIZ. Apo.Manc.: ALONSO GERIZ BEATRIZ;BORJA ALVAREZ DE TOLEDOANTONIO-RAMON;MARTINEZ MANERO VICTOR JUAN. Datos registrales. T 4350 , F 157, S 8, H A 172882, I/A 14 ( 8.08.23).
31 de Julio de 2023Revocaciones. Apoderado: GRANT PAUL-DORIANT. Apo.Manc.: GRANT PAUL-DORIANT. Apoderado: HERRAIZ VENANCIO JOSEMANUEL. Datos registrales. T 4350 , F 157, S 8, H A 172882, I/A 13 (20.07.23).
25 de Julio de 2023Nombramientos. Apoderado: HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4350 , F 156, S 8, H A 172882, I/A 12(17.07.23).
11 de Agosto de 2022Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4350 , F 156, S 8, H A 172882, I/A 11 ( 3.08.22).
13 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: GRANT PAUL-DORIANT. Apo.Manc.: GRANT PAUL-DORIANT;BORJA ALVAREZ DE TOLEDOANTONIO-RAMON;MARTINEZ MANERO VICTOR JUAN. Datos registrales. T 4350 , F 155, S 8, H A 172882, I/A 10 ( 5.07.22).
07 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: VIVAS PEREZ MIGUEL. Apo.Manc.: DO ROSARIO VASCO JORGE MARUJO. Apo.Sol.: DO ROSARIOVASCO JORGE MARUJO. Datos registrales. T 4350 , F 154, S 8, H A 172882, I/A 9 (28.01.22).
15 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DO ROSARIO VASCO JORGE MARUJO. Apo.Manc.: DO ROSARIO VASCO JORGE MARUJO;BORJAALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO-RAMON;MARTINEZ MANERO VICTOR JUAN. Datos registrales. T 4350 , F 153, S 8, H A172882, I/A 7 ( 8.02.21).
Nombramientos. Apoderado: MARQUES GUISADO GLORIA. Datos registrales. T 4350 , F 154, S 8, H A 172882, I/A 8 ( 8.02.21).
12 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: VIVAS PEREZ MIGUEL. Datos registrales. T 4350 , F 152, S 8, H A 172882, I/A 5 ( 5.02.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO-RAMON;MARTINEZ MANERO VICTOR JUAN. Datosregistrales. T 4350 , F 152, S 8, H A 172882, I/A 6 ( 5.02.21).
11 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4348 , F 159, S 8, H A 172882, I/A 3 (3.02.21).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ BLANCO PABLO JOSE. Datos registrales. T 4348 , F 159, S 8, H A 172882, I/A 4 (4.02.21).
10 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MANERO VICTOR JUAN. Datos registrales. T 4348 , F 158, S 8, H A 172882, I/A 2 (3.02.21).
09 de Febrero de 2021Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 5.01.21. Objeto social: 1. Fabricaci贸n, elaboraci贸n, dise帽o y comercializaci贸n de materialessinterizados, porcel谩nicos o derivados de piedras y arenas naturales. 2. Fabricaci贸n y comercializaci贸n de materiales de construcci贸n yart铆culos para la rehabilitaci贸n, decoraci贸n de toda clase de inmuebles. 3. La investigaci贸n, d. Domicilio: AUTOV MADRID-ALICANTE,Km 382 (NOVELDA). Capital: 500.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LEVANTINA Y ASOCIADOS DEMINERALES SOCIEDAD ANONIM. Nombramientos. Adm. Unico: DIONIS TRENOR JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 4348 , F156, S 8, H A 172882, I/A 1 ( 1.02.21).