Actos BORME de Lgr Sl
06 de Abril de 2018Nombramientos. APODERAD.SOL: DEL CASTILLO GUASCH CARMEN. Datos registrales. T 22207 , F 59, S 8, H B 34658, I/A 11(27.03.18).
10 de Noviembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.020,24 Euros. Resultante Suscrito: 1.566.736,79 Euros. Datos registrales. T 22207 , F59, S 8, H B 34658, I/A 10 ( 2.11.17).
30 de Octubre de 2017Revocaciones. ADMINISTR.: MINGOT PALLES JAUME. Nombramientos. CONSEJERO: DEL CASTILLO GUASCH CARMEN.PRESIDENTE: DEL CASTILLO GUASCH CARMEN. CONSEJERO: GRATACOS DEL CASTILLO CARMEN. SECRETARIO:GRATACOS DEL CASTILLO CARMEN. CONS.DEL.MAN: GRATACOS DEL CASTILLO CARMEN. CONSEJERO: GRATACOS DELCASTILLO MARIA DEL MAR;GRATACOS DEL CASTILLO CARLOS;GRATACOS DEL CASTILLO JORGE. CONS.DEL.MAN:GRATACOS DEL CASTILLO JORGE. APODERAD.SOL: DEL CASTILLO GUASCH CARMEN. APOD.SOL/MAN: GRATACOS DEL
09 de Febrero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 82.494,92 Euros. Resultante Suscrito: 1.578.757,03 Euros. Datos registrales. T 22207 , F 57, S 8, HB 34658, I/A 8 ( 1.02.17).
17 de Mayo de 2013Nombramientos. APODERADO: GRATACOS DEL CASTILLO JORDI. Datos registrales. T 22207 , F 56, S 8, H B 34658, I/A 7 (9.05.13).
23 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 149.995,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.496.262,11 Euros. Datos registrales. T 22207 , F 55, S 8,H B 34658, I/A 6 (14.11.11).